SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00215000 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SCOTTISH & NEWCASTLE HOTELS LIMITED | 19 ago 1994 | 19 ago 1994 |
| TAMPLIN'S LICENSED PROPERTIES LIMITED | 12 lug 1926 | 12 lug 1926 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 22 ago 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 gen 2018 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU in data 13 set 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL in data 08 feb 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Robert Langford come amministratore in data 26 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daryl Antony Kelly come amministratore in data 26 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucy Jane Bell come amministratore in data 26 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 21 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Henry Jones come segretario in data 04 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 24 ago 2016 al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick James Gallagher come amministratore in data 23 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 23 ago 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 17 ago 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Segretario | 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London Resolve Partners Limited | 207523600001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| ADAMS, Susanne Margaret | Segretario | Azalea 167 High Street Northchurch HP4 3QT Berkhamsted Hertfordshire | British | 28738400002 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Segretario | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Segretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Segretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592260001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Segretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445620001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Segretario | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021780001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Amministratore | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Amministratore | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Amministratore | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Amministratore | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Amministratore | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Amministratore | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Amministratore | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Amministratore | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| MYDDELTON, Roger Hugh | Amministratore | 21 Lawford Road NW5 2LH London | British | 399500001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Amministratore | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Amministratore | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 02 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 15 dic 2003 Consegnato il 31 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 05 gen 1989 Consegnato il 12 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed | Creato il 30 set 1985 Consegnato il 07 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 1,288,988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of sterling pounds 349,595 5% redeemable debenture stock 2000, sterling pounds 243,200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & sterling pounds 696,193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all moneys intended to be secured by a trust deed dated 7/2/62 & deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 24 mag 1983 Consegnato il 25 mag 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing sterling pounds 50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney mann & truman holdings PLC & for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of the trust deed dated 7/2/62 and supplemental thereto | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 28 lug 1970 Consegnato il 12 ago 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 53,127,463 inclusive of sterling pounds 45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental | |
Brevi particolari First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 31 lug 1967 Consegnato il 31 lug 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 45,627,463 inclusive of sterling pounds 35,627,463 secured by trust deed dated 7/2/62 and deeds suppl. Thereto | |
Brevi particolari First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Equitable charge without instrument | Creato il 08 mag 1967 Consegnato il 26 mag 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 10,000,000 | |
Brevi particolari First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 26 lug 1965 Consegnato il 28 lug 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 7,500,000 | |
Brevi particolari Floating charge on the (see doc. 82). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 26 mar 1965 Consegnato il 06 apr 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 1,347,268 debenture stock of watney mann LTD. | |
Brevi particolari Floating charge:. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 22 gen 1964 Consegnato il 23 giu 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 8,000,000 | |
Brevi particolari Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. (See doc 77). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 08 feb 1962 Consegnato il 08 feb 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing sterling pounds 5,000,000 debenture stock of watney mann limited, (see doc 73 for further details) | |
Brevi particolari Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed. | Creato il 07 feb 1962 Consegnato il 07 feb 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing sterling pounds 13,780,195 debenture stock of watney mann LTD. (For further details see doc 72) | |
Brevi particolari Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0