SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED

SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00215000
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SCOTTISH & NEWCASTLE HOTELS LIMITED19 ago 199419 ago 1994
    TAMPLIN'S LICENSED PROPERTIES LIMITED12 lug 192612 lug 1926

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al22 ago 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 gen 2018

    9 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU in data 13 set 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL in data 08 feb 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 gen 2017

    LRESSP

    Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2016

    Stato del capitale al 02 mar 2016

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan Robert Langford come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daryl Antony Kelly come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lucy Jane Bell come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 21 dic 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henry Jones come segretario in data 04 dic 2015

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 24 ago 2016 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Patrick James Gallagher come amministratore in data 23 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2015

    Stato del capitale al 02 mar 2015

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 23 ago 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2014

    Stato del capitale al 03 mar 2014

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 17 ago 2013

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523600001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    ADAMS, Susanne Margaret
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    Azalea
    167 High Street Northchurch
    HP4 3QT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28738400002
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592260001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445620001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Segretario
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021780001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Amministratore
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Amministratore
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Amministratore
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    MYDDELTON, Roger Hugh
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    Amministratore
    21 Lawford Road
    NW5 2LH London
    British399500001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    02 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 15 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 05 gen 1989
    Consegnato il 12 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Twelfth supplemental trust deed
    Creato il 30 set 1985
    Consegnato il 07 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 1,288,988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of sterling pounds 349,595 5% redeemable debenture stock 2000, sterling pounds 243,200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & sterling pounds 696,193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all moneys intended to be secured by a trust deed dated 7/2/62 & deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 07 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 24 mag 1983
    Consegnato il 25 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing sterling pounds 50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney mann & truman holdings PLC & for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of the trust deed dated 7/2/62 and supplemental thereto
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 25 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 28 lug 1970
    Consegnato il 12 ago 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 53,127,463 inclusive of sterling pounds 45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental
    Brevi particolari
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co. LTD.
    Transazioni
    • 12 ago 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 31 lug 1967
    Consegnato il 31 lug 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 45,627,463 inclusive of sterling pounds 35,627,463 secured by trust deed dated 7/2/62 and deeds suppl. Thereto
    Brevi particolari
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co. LTD.
    Transazioni
    • 31 lug 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge without instrument
    Creato il 08 mag 1967
    Consegnato il 26 mag 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 10,000,000
    Brevi particolari
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co. LTD.
    Transazioni
    • 26 mag 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 26 lug 1965
    Consegnato il 28 lug 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 7,500,000
    Brevi particolari
    Floating charge on the (see doc. 82). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Brothers & Co. LTD.
    Transazioni
    • 28 lug 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 26 mar 1965
    Consegnato il 06 apr 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    1,347,268 debenture stock of watney mann LTD.
    Brevi particolari
    Floating charge:. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Bros. & Co., LTD
    Transazioni
    • 06 apr 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 22 gen 1964
    Consegnato il 23 giu 1964
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 8,000,000
    Brevi particolari
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. (See doc 77).
    Persone aventi diritto
    • Baring Bros. & Co., LTD
    Transazioni
    • 23 giu 1964Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 08 feb 1962
    Consegnato il 08 feb 1962
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing sterling pounds 5,000,000 debenture stock of watney mann limited, (see doc 73 for further details)
    Brevi particolari
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Bros. & Co., LTD
    Transazioni
    • 08 feb 1962Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed.
    Creato il 07 feb 1962
    Consegnato il 07 feb 1962
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing sterling pounds 13,780,195 debenture stock of watney mann LTD. (For further details see doc 72)
    Brevi particolari
    Undertaking and all assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Baring Bros. & Co., LTD
    Transazioni
    • 07 feb 1962Registrazione di un'ipoteca
    • 23 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 gen 2017Inizio della liquidazione
    14 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Praticante
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Praticante
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0