BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED

BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00220039
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in gomma (22190) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Beveridge Lane
    Bardon Hill
    LE67 1TA Coalville
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERTFORDSHIRE BTR LIMITED26 nov 198226 nov 1982
    HERTFORDSHIRE POLYMER PRODUCTS LIMITED03 mar 192703 mar 1927

    Quali sono gli ultimi bilanci di BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ordine del tribunale di liquidazione

    pagineCOCOMP
    Q21J8EYH

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92
    R4I8T9H6

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07
    A304EARV

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP
    Q21J8EYH

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    9 pagineAA
    A1CFPZ4Y

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 apr 2012

    Stato del capitale al 23 apr 2012

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01
    X17FZCU9

    Nomina di Mr Sanjeev Baranwal come amministratore

    2 pagineAP01
    XQIPHXIQ

    Cessazione della carica di Nirmal Modi come amministratore

    1 pagineTM01
    XQ73CXHN

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2011

    9 pagineAA
    A1G6ZV8Z

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XF3W9THU

    Cessazione della carica di Raj Khandelwal come amministratore

    1 pagineTM01
    XMLN5R9W

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010

    9 pagineAA
    ATFT4QEJ

    Bilancio annuale redatto al 25 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    XFBOMJ3J

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02
    XFBOLJ3I

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2009

    9 pagineAA
    A08MAHYT

    legacy

    4 pagine363a
    XM0XEATX

    legacy

    1 pagine190
    XM0XBATU

    legacy

    1 pagine288a
    XM0XDATW

    legacy

    1 pagine287
    XM0X9ATS

    legacy

    1 pagine353
    XM0XAATT

    legacy

    1 pagine288b
    XM0XCATV

    legacy

    1 pagine288b
    A8JZY8PV

    Chi sono gli amministratori di BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AGIWAL, Sanjay
    77 Abbey Fields Close
    NW10 7EG London
    Segretario
    77 Abbey Fields Close
    NW10 7EG London
    Indian108018820002
    BARANWAL, Sanjeev
    Bardon Hill
    LE67 1TA Coalville
    Beveridge Lane
    Leicestershire
    Amministratore
    Bardon Hill
    LE67 1TA Coalville
    Beveridge Lane
    Leicestershire
    IndiaIndianCompany Employee162991880001
    JOSHI, Amit Kumar
    Chittaranjan Avenue
    700073 Kolkata
    114
    West Bengal
    India
    Amministratore
    Chittaranjan Avenue
    700073 Kolkata
    114
    West Bengal
    India
    IndiaIndianAccountant135271180001
    HALL, Maxwell John
    4 Digby Close
    Tilton On The Hill
    LE7 9LL Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    4 Digby Close
    Tilton On The Hill
    LE7 9LL Leicester
    Leicestershire
    OtherAccountant10305430001
    LANDREY, Steven
    9 Gullimans Way
    CV31 1LA Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    9 Gullimans Way
    CV31 1LA Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant88093820001
    NICHOLSON, Mark
    10 Rockingham Hills
    PE8 4QA Oundle
    Northamptonshire
    Segretario
    10 Rockingham Hills
    PE8 4QA Oundle
    Northamptonshire
    BritishAccountant69438760001
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    Segretario
    Invensys House
    Carlisle Place
    SW1P 1BX London
    75491680001
    BAYS, James Claude
    28 Elmstone Road
    Fulham
    SW6 5TN London
    Amministratore
    28 Elmstone Road
    Fulham
    SW6 5TN London
    AmericanAttorney64404450001
    BORLACE, Charles Anthony
    3 Dunsmore Close
    LE11 3RD Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    3 Dunsmore Close
    LE11 3RD Loughborough
    Leicestershire
    BritishManaging Director70973940002
    BORLACE, Charles Anthony
    3 Dunsmore Close
    LE11 3RD Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    3 Dunsmore Close
    LE11 3RD Loughborough
    Leicestershire
    BritishManaging Director70973940002
    BOYNTON, David Philip
    5 Burlington Road
    Redland
    BS6 6TJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    5 Burlington Road
    Redland
    BS6 6TJ Bristol
    Avon
    BritishConsultant24699050001
    BROWN, Robert Casson
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    38 Newlands Avenue
    Melton Park
    NE3 5PX Newcastle Upon Tyne
    BritishSolicitor6343100001
    COCKS, Philip John
    The Copse 57 Odell Road
    Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Copse 57 Odell Road
    Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector27632800001
    COCKS, Philip John
    The Copse 57 Odell Road
    Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Copse 57 Odell Road
    Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Bedfordshire
    BritishTechnical Director27632800001
    COOPER, Richard Lewis
    8 Staines Square
    LU6 3JQ Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    8 Staines Square
    LU6 3JQ Dunstable
    Bedfordshire
    BritishPersonnel And Planning Director26573160001
    DE GRAEF, Matt
    8 Chemin Des Six Bordeaux
    Collonge Bellerive
    Ch 1245
    Switzerland
    Amministratore
    8 Chemin Des Six Bordeaux
    Collonge Bellerive
    Ch 1245
    Switzerland
    DutchEngineer72032180001
    FLAVELL, Alan John
    Meadow View
    Astley
    DY13 0RH Stourport
    Worcestershire
    Amministratore
    Meadow View
    Astley
    DY13 0RH Stourport
    Worcestershire
    BritishAccountant80518690001
    GARLING, Stuart Charles Hill
    7 Souberie Avenue
    SG6 3JA Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Souberie Avenue
    SG6 3JA Letchworth
    Hertfordshire
    BritishSales Director26573170001
    HARRIS, John Alfred
    236 London Road
    SG18 8PJ Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    236 London Road
    SG18 8PJ Biggleswade
    Bedfordshire
    BritishPlant Director26573180001
    JOSHI, Arvind Kumar
    Satsang Tower, Upper Govind Nagar
    Malad (E)
    400 097 Mumbai
    1201,
    India
    Amministratore
    Satsang Tower, Upper Govind Nagar
    Malad (E)
    400 097 Mumbai
    1201,
    India
    IndianChartered Accountant128080040002
    KHANDELWAL, Raj Kishor
    Sunflower Garden
    74 Topsia Road (South)
    Kolkata
    Flat 116
    West Bengal 700046
    India
    Amministratore
    Sunflower Garden
    74 Topsia Road (South)
    Kolkata
    Flat 116
    West Bengal 700046
    India
    IndiaIndianService135269960001
    LANDREY, Steven
    Rosedean
    Southam Street, Kineton
    CV35 0LW Warwick
    Amministratore
    Rosedean
    Southam Street, Kineton
    CV35 0LW Warwick
    BritishDirector126245980001
    MODI, Nirmal Kumar
    493/B/1 G T Road(South)
    711102 Howrah
    Panchsheel Apartment
    West Bengal
    India
    Amministratore
    493/B/1 G T Road(South)
    711102 Howrah
    Panchsheel Apartment
    West Bengal
    India
    IndiaIndianService135990910001
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Amministratore
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,IrishManager32235150003
    PYATT, Martin Thomas
    36 Garland
    LE7 7RF Rothley
    Leicestershire
    Amministratore
    36 Garland
    LE7 7RF Rothley
    Leicestershire
    BritishAccoutant83378570001
    ROUAS, Alain
    6 Rue Des Pyrenees
    92500 Rueil-Malmaison
    France
    Amministratore
    6 Rue Des Pyrenees
    92500 Rueil-Malmaison
    France
    FrenchPresident Directeur General50701550002
    SMITH, Robert Ian
    6 Montpellier Close
    CV3 5PL Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    6 Montpellier Close
    CV3 5PL Coventry
    West Midlands
    EnglandBritishEngineer69439140001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Amministratore
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    BritishSolicitor56704240001
    THOM, James Demmink
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    Amministratore
    Tollgate Cottage
    Turners Hill Road
    RH10 4HG Crawley Down
    West Sussex
    BritishTreasurer38683120002
    URBAIN, Alain
    Motzacher Weg 60
    Lindau
    88131
    Germany
    Amministratore
    Motzacher Weg 60
    Lindau
    88131
    Germany
    FrenchCfo88075940001
    WARDELL, David John
    3 Manor Park Drive
    MK45 5LS Westoning
    Bedfordshire
    Amministratore
    3 Manor Park Drive
    MK45 5LS Westoning
    Bedfordshire
    United KingdomBritishGroup Treasurer80361780001
    WARDELL, David John
    3 Manor Park Drive
    MK45 5LS Westoning
    Bedfordshire
    Amministratore
    3 Manor Park Drive
    MK45 5LS Westoning
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector80361780001
    WILLIAMS, Stanley Killa
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    White Raven
    Park Lane
    KT21 1EU Ashtead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary & Solicitor34401400001

    BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory charge
    Creato il 21 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Acting as Security Agent on Behalf of a Syndiacte of Banks)
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 14 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the company and each of the other obligors to the chargee under the senior finance documents or any of them and under the debenture (all defined therein)
    Brevi particolari
    The property: london road t/no. BD151361; beveridge lane, bardon hill, costville, leicestershire. T/no. LT187615.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dlj Capital Funding, Inc. as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 14 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 apr 1948
    Consegnato il 07 apr 1948
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc
    Transazioni
    • 07 apr 1948Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 07 apr 1948
    Consegnato il 27 apr 1948
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Transazioni
    • 27 apr 1948Registrazione di un'ipoteca

    BTR SEALING SYSTEMS (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 nov 2012Data della petizione
    21 gen 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Leicester
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester
    Praticante
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0