BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED

BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00220905
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    250 Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al18 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma02 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al18 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mark Christopher Croman come amministratore in data 18 dic 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Hedgecock come amministratore in data 21 nov 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joseph Sanderson come amministratore in data 20 nov 2024

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 002209050023, creata il 05 lug 2024

    24 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Lawrence James Ladbrook come amministratore in data 23 feb 2023

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Sanderson il 01 apr 2022

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 002209050019 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Neal Philip King come amministratore in data 31 mag 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Lawrence James Ladbrook come amministratore in data 31 mag 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Luke Speakman come amministratore in data 31 mag 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di James Thomas Green come amministratore in data 31 mag 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter David Christmas come amministratore in data 31 mag 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Karen Elizabeth Davies come amministratore in data 31 mag 2022

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 002209050022, creata il 11 mag 2022

    39 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Iain Thomas Wardhaugh come amministratore in data 25 mar 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Memorandum e Statuto

    34 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    175 Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830002
    CROMAN, Mark Christopher
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    ScotlandBritishBank Official330626450001
    GREEN, James Thomas
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official296439520001
    HARRISON, John David
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    ScotlandBritishSolicitor101435220003
    KING, Neal Philip
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official294327060001
    SPEAKMAN, Luke
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official294326230001
    BERESFORD, Robyn Fay
    West Bryson Road
    EH11 1BN Edinburgh
    21/5
    Segretario
    West Bryson Road
    EH11 1BN Edinburgh
    21/5
    Other132316300001
    CASTRO, Marcos
    2b St Johns Road
    RH1 6HF Redhill
    Surrey
    Segretario
    2b St Johns Road
    RH1 6HF Redhill
    Surrey
    Other109248350003
    LEA, John Albert
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    Segretario
    2 Heathgate
    CM8 3NZ Wickham Bishops
    Essex
    BritishBank Official1369400003
    RUSSELL, Christine Anne
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    163932860001
    WALLACE, Barbara Charlotte
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Rbs Gogarburn
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    149094520001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    ADAMS, Sarah Jane
    60 Kingsmead Avenue
    KT4 8UZ Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    60 Kingsmead Avenue
    KT4 8UZ Worcester Park
    Surrey
    BritishBank Clerk59354370001
    ALLAN, Gordon Robert
    10 Eridge Green
    Kents Hill
    MK7 6JE Milton Keynes
    Amministratore
    10 Eridge Green
    Kents Hill
    MK7 6JE Milton Keynes
    BritishBank Official35413620002
    BETNEY, Lee Alan
    3 Furlay Close
    SG6 4YL Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Furlay Close
    SG6 4YL Letchworth
    Hertfordshire
    BritishBank Official59354470001
    BOWIE, Craig Ferguson
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    ScotlandBritishBank Official229279830001
    CALDER, Alan Alexander
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    ScotlandBritishBank Official154937260001
    CHRISTMAS, Peter David
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official229715080001
    CLARK, James Forbes
    26 Clarendon Court
    14 Albermarle Road
    BR3 2HJ Beckenham
    Kent
    Amministratore
    26 Clarendon Court
    14 Albermarle Road
    BR3 2HJ Beckenham
    Kent
    BritishBank Official27961910001
    COLEMAN, Simon Gary
    131 Eden Way
    BR3 3DW Beckenham
    Kent
    Amministratore
    131 Eden Way
    BR3 3DW Beckenham
    Kent
    BritishBank Official52466060001
    CRAWFORD, Kenneth William
    Croftways
    Park Avenue Farnborough Park
    BR6 8LH Orpington
    Kent
    Amministratore
    Croftways
    Park Avenue Farnborough Park
    BR6 8LH Orpington
    Kent
    BritishBank Official79075180001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Amministratore
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    BritishAsst Co Secretary62801910001
    DARE, Simon Christopher
    6 Bishops Road
    Upper Hale
    GU9 0JA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    6 Bishops Road
    Upper Hale
    GU9 0JA Farnham
    Surrey
    BritishBank Official53439560001
    DAVIES, Karen Elizabeth
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 4AA London
    250 Bishopsgate
    England
    United KingdomBritishBank Official201351930001
    DAVIES, Kevin James
    34 Littleheath Road
    DA7 4DN Bexleyheath
    Kent
    Amministratore
    34 Littleheath Road
    DA7 4DN Bexleyheath
    Kent
    United KingdomBritishBank Official62962930001
    DAVIES, Stephen William
    3 The Cedars
    Brook Road
    IG9 5TS Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    3 The Cedars
    Brook Road
    IG9 5TS Buckhurst Hill
    Essex
    BritishCompany Director74709820001
    DUNCAN, James
    Flat 6 Sylvan House
    3 Hanbury Drive Winchmore Hill
    N21 London
    Amministratore
    Flat 6 Sylvan House
    3 Hanbury Drive Winchmore Hill
    N21 London
    BritishBank Official44453440001
    EWEN, Nichola
    27 Sinclair Way
    DA2 7JS Dartford
    Kent
    Amministratore
    27 Sinclair Way
    DA2 7JS Dartford
    Kent
    BritishBank Official31551480001
    FRIEND, Michelle Rosetta
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Amministratore
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official171407420001
    GEACH, Anthony Francis
    61 Ozonia Way
    SS12 0PQ Wickford
    Essex
    Amministratore
    61 Ozonia Way
    SS12 0PQ Wickford
    Essex
    BritishBank Official38656710001
    GOULDS, Philip Arthur
    28 Wilmour Gardens
    BR4 0LH West Wickham
    Kent
    Amministratore
    28 Wilmour Gardens
    BR4 0LH West Wickham
    Kent
    BritishBank Official59354540002
    GOULDS, Philip Arthur
    19 Foxbury Road
    BR1 4DG Bromley
    Kent
    Amministratore
    19 Foxbury Road
    BR1 4DG Bromley
    Kent
    BritishBank Official59354540001
    GREENWOOD, Russell John
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    EnglandBritishBank Official249702170001
    HARPER, Alan Christopher
    9 Fernheath
    Barton Hills
    LU3 4DG Luton
    Bedfordshire
    Amministratore
    9 Fernheath
    Barton Hills
    LU3 4DG Luton
    Bedfordshire
    BritishBank Official33508000001
    HAWKINS, Alan Roy
    70 Ardleigh Court
    Hutton Road
    CM15 8NA Shenfield
    Essex
    Amministratore
    70 Ardleigh Court
    Hutton Road
    CM15 8NA Shenfield
    Essex
    EnglandBritishBank Official53574770001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    25 set 2018
    Bishopsgate
    EC2M 4AA London
    250
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11194605
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    St. Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    36
    Scotland
    06 apr 2016
    St. Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    36
    Scotland
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 1985 + 1989
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc090312
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    The Royal Bank Of Scotland Plc
    St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    36
    Midlothian
    06 apr 2016
    St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    36
    Midlothian
    Forma giuridicaCompanies Act 1948
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleScotland
    Luogo di registrazioneCompanies House Scotland
    Numero di registrazioneSc090312
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    The Royal Bank Of Scotland Plc
    St Andrew Square
    Edinburgh
    36
    Scotland
    06 apr 2016
    St Andrew Square
    Edinburgh
    36
    Scotland
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 lug 2024
    Consegnato il 08 lug 2024
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland International Limited, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 08 lug 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 11 mag 2022
    Consegnato il 16 mag 2022
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Baring Asset Management Limited
    Transazioni
    • 16 mag 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 dic 2019
    Consegnato il 07 gen 2020
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Prs Operations Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2019
    Consegnato il 20 dic 2019
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland International Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 20 dic 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 ago 2019
    Consegnato il 14 ago 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Fixed charge over the freehold property known as unit 1, manton wood, worksop, nottinghamshire together will all fixtures, fittings, buildings, fixed plant and machinery, and all other rights and interests in the property as described more fully in clause 3 of the charge instrument.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Dhl Real Estate (UK) Limited
    Transazioni
    • 14 ago 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2015
    Consegnato il 01 lug 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as land at land on the south west side of hainault road, romford registered under title number NGL189236.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • The Wellcome Trust Limited
    Transazioni
    • 01 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 21 nov 2014
    Consegnato il 02 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as land and buildings on the south west side of cowley bridge road, exeter and registered at the land registry with title number DN147692.
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 ott 2013
    Consegnato il 05 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Subjects k/a leisure unit 2, fife leisure park, halbeath, dunfermline t/no FFE76481. Subjects k/a fife leisure park, whimbrel place, dunfermline t/no FFE64301. Subjects k/a units 7A and 7B, fife leisure park, halbeath, dunfermline t/no FFE99831.
    Persone aventi diritto
    • Fife Leisure General Partner Limited
    Transazioni
    • 05 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 03 apr 2013
    Consegnato il 09 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the original share any further shares any derived assets and any dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a debtor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1-4 cadleigh close ivybridge devon t/no DN162695. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 18 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to the aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of any of the assignors in connection with the letting of the property or any part thereof the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by a debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit H2 st mowden road marsh mills plymouth t/n DN368026 all buildings all plant and machinery proceeds of any claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 18 ago 2005
    Consegnato il 03 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to the aggregate of all amounts payable, rent, any guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rental income
    Creato il 23 lug 2004
    Consegnato il 29 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 2004
    Consegnato il 29 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h property k/a future house 125 chatham street reading t/n's BK208049 (f/h) and BK220435 (l/h). Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rental income
    Creato il 25 mag 2004
    Consegnato il 09 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the "borrower" to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of security all of its right title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2004
    Consegnato il 09 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the "borrower" to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a geopost UK limited distribution centre (formerly the parceline distribution centre) hambridge lane newbury berkshire t/n BK245173.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rental income
    Creato il 25 mar 2004
    Consegnato il 02 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the mc property growth fund "borrower" to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of security all its right, title and interest in and to the rental income.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 2004
    Consegnato il 02 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mayfair general partner (capital growth) limited "borrower" to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings at factories "a" and "b" henson way, kettering t/n NN124802. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rental income
    Creato il 01 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rental income
    Creato il 01 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as pinder house 249 upper third street milton keynes t/n BM147029. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as unit 9 nuffield way abingdon t/n ON49772. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2014Tutta la proprietà o l'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 09 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0