BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED
Panoramica
Nome della società | BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00220905 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 18 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 02 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 18 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Mark Christopher Croman come amministratore in data 18 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Hedgecock come amministratore in data 21 nov 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joseph Sanderson come amministratore in data 20 nov 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 002209050023, creata il 05 lug 2024 | 24 pagine | MR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lawrence James Ladbrook come amministratore in data 23 feb 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph Sanderson il 01 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 002209050019 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Neal Philip King come amministratore in data 31 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Lawrence James Ladbrook come amministratore in data 31 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Luke Speakman come amministratore in data 31 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di James Thomas Green come amministratore in data 31 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter David Christmas come amministratore in data 31 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Elizabeth Davies come amministratore in data 31 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 002209050022, creata il 11 mag 2022 | 39 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Iain Thomas Wardhaugh come amministratore in data 25 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 34 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Chi sono gli amministratori di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
CROMAN, Mark Christopher | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | Scotland | British | Bank Official | 330626450001 | ||||||||
GREEN, James Thomas | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 296439520001 | ||||||||
HARRISON, John David | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | Scotland | British | Solicitor | 101435220003 | ||||||||
KING, Neal Philip | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 294327060001 | ||||||||
SPEAKMAN, Luke | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 294326230001 | ||||||||
BERESFORD, Robyn Fay | Segretario | West Bryson Road EH11 1BN Edinburgh 21/5 | Other | 132316300001 | ||||||||||
CASTRO, Marcos | Segretario | 2b St Johns Road RH1 6HF Redhill Surrey | Other | 109248350003 | ||||||||||
LEA, John Albert | Segretario | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | Bank Official | 1369400003 | |||||||||
RUSSELL, Christine Anne | Segretario | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 163932860001 | |||||||||||
WALLACE, Barbara Charlotte | Segretario | Rbs Gogarburn EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 149094520001 | |||||||||||
WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
ADAMS, Sarah Jane | Amministratore | 60 Kingsmead Avenue KT4 8UZ Worcester Park Surrey | British | Bank Clerk | 59354370001 | |||||||||
ALLAN, Gordon Robert | Amministratore | 10 Eridge Green Kents Hill MK7 6JE Milton Keynes | British | Bank Official | 35413620002 | |||||||||
BETNEY, Lee Alan | Amministratore | 3 Furlay Close SG6 4YL Letchworth Hertfordshire | British | Bank Official | 59354470001 | |||||||||
BOWIE, Craig Ferguson | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | Scotland | British | Bank Official | 229279830001 | ||||||||
CALDER, Alan Alexander | Amministratore | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | Scotland | British | Bank Official | 154937260001 | ||||||||
CHRISTMAS, Peter David | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 229715080001 | ||||||||
CLARK, James Forbes | Amministratore | 26 Clarendon Court 14 Albermarle Road BR3 2HJ Beckenham Kent | British | Bank Official | 27961910001 | |||||||||
COLEMAN, Simon Gary | Amministratore | 131 Eden Way BR3 3DW Beckenham Kent | British | Bank Official | 52466060001 | |||||||||
CRAWFORD, Kenneth William | Amministratore | Croftways Park Avenue Farnborough Park BR6 8LH Orpington Kent | British | Bank Official | 79075180001 | |||||||||
CUNNINGHAM, Angela Mary | Amministratore | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | Asst Co Secretary | 62801910001 | |||||||||
DARE, Simon Christopher | Amministratore | 6 Bishops Road Upper Hale GU9 0JA Farnham Surrey | British | Bank Official | 53439560001 | |||||||||
DAVIES, Karen Elizabeth | Amministratore | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | United Kingdom | British | Bank Official | 201351930001 | ||||||||
DAVIES, Kevin James | Amministratore | 34 Littleheath Road DA7 4DN Bexleyheath Kent | United Kingdom | British | Bank Official | 62962930001 | ||||||||
DAVIES, Stephen William | Amministratore | 3 The Cedars Brook Road IG9 5TS Buckhurst Hill Essex | British | Company Director | 74709820001 | |||||||||
DUNCAN, James | Amministratore | Flat 6 Sylvan House 3 Hanbury Drive Winchmore Hill N21 London | British | Bank Official | 44453440001 | |||||||||
EWEN, Nichola | Amministratore | 27 Sinclair Way DA2 7JS Dartford Kent | British | Bank Official | 31551480001 | |||||||||
FRIEND, Michelle Rosetta | Amministratore | EC2M 3UR London 135 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 171407420001 | ||||||||
GEACH, Anthony Francis | Amministratore | 61 Ozonia Way SS12 0PQ Wickford Essex | British | Bank Official | 38656710001 | |||||||||
GOULDS, Philip Arthur | Amministratore | 28 Wilmour Gardens BR4 0LH West Wickham Kent | British | Bank Official | 59354540002 | |||||||||
GOULDS, Philip Arthur | Amministratore | 19 Foxbury Road BR1 4DG Bromley Kent | British | Bank Official | 59354540001 | |||||||||
GREENWOOD, Russell John | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 England | England | British | Bank Official | 249702170001 | ||||||||
HARPER, Alan Christopher | Amministratore | 9 Fernheath Barton Hills LU3 4DG Luton Bedfordshire | British | Bank Official | 33508000001 | |||||||||
HAWKINS, Alan Roy | Amministratore | 70 Ardleigh Court Hutton Road CM15 8NA Shenfield Essex | England | British | Bank Official | 53574770001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natwest Trustee And Depositary Services Limited | 25 set 2018 | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Natwest Markets Plc | 06 apr 2016 | St. Andrew Square EH2 2YB Edinburgh 36 Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 apr 2016 | St Andrew Square EH2 2YB Edinburgh 36 Midlothian | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
The Royal Bank Of Scotland Plc | 06 apr 2016 | St Andrew Square Edinburgh 36 Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BRITISH OVERSEAS BANK NOMINEES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 05 lug 2024 Consegnato il 08 lug 2024 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 11 mag 2022 Consegnato il 16 mag 2022 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 31 dic 2019 Consegnato il 07 gen 2020 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 18 dic 2019 Consegnato il 20 dic 2019 | In corso | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 07 ago 2019 Consegnato il 14 ago 2019 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Fixed charge over the freehold property known as unit 1, manton wood, worksop, nottinghamshire together will all fixtures, fittings, buildings, fixed plant and machinery, and all other rights and interests in the property as described more fully in clause 3 of the charge instrument. Debitore che agisce come trustee nudo: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 12 giu 2015 Consegnato il 01 lug 2015 | In corso | ||
Breve descrizione The freehold property known as land at land on the south west side of hainault road, romford registered under title number NGL189236. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 21 nov 2014 Consegnato il 02 dic 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione The freehold property known as land and buildings on the south west side of cowley bridge road, exeter and registered at the land registry with title number DN147692. Debitore che agisce come trustee nudo: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 17 ott 2013 Consegnato il 05 nov 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Subjects k/a leisure unit 2, fife leisure park, halbeath, dunfermline t/no FFE76481. Subjects k/a fife leisure park, whimbrel place, dunfermline t/no FFE64301. Subjects k/a units 7A and 7B, fife leisure park, halbeath, dunfermline t/no FFE99831. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over shares | Creato il 03 apr 2013 Consegnato il 09 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title and interest in and to the original share any further shares any derived assets and any dividends see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 ago 2005 Consegnato il 03 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from a debtor to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 1-4 cadleigh close ivybridge devon t/no DN162695. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment | Creato il 18 ago 2005 Consegnato il 03 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its right title and interest in and to the aggregate of all amounts payable to or for the benefit or account of any of the assignors in connection with the letting of the property or any part thereof the occupational leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 ago 2005 Consegnato il 03 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by a debtor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H property k/a unit H2 st mowden road marsh mills plymouth t/n DN368026 all buildings all plant and machinery proceeds of any claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assignment | Creato il 18 ago 2005 Consegnato il 03 set 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its right title and interest in and to the aggregate of all amounts payable, rent, any guarantee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of rental income | Creato il 23 lug 2004 Consegnato il 29 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All of its right title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 23 lug 2004 Consegnato il 29 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H and l/h property k/a future house 125 chatham street reading t/n's BK208049 (f/h) and BK220435 (l/h). Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of rental income | Creato il 25 mag 2004 Consegnato il 09 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the "borrower" to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of security all of its right title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 mag 2004 Consegnato il 09 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the "borrower" to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a geopost UK limited distribution centre (formerly the parceline distribution centre) hambridge lane newbury berkshire t/n BK245173. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of rental income | Creato il 25 mar 2004 Consegnato il 02 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the mc property growth fund "borrower" to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of security all its right, title and interest in and to the rental income. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 mar 2004 Consegnato il 02 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from mayfair general partner (capital growth) limited "borrower" to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a land and buildings at factories "a" and "b" henson way, kettering t/n NN124802. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of rental income | Creato il 01 mar 2004 Consegnato il 17 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment of rental income | Creato il 01 mar 2004 Consegnato il 17 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right, title and interest in and to the rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 mar 2004 Consegnato il 17 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as pinder house 249 upper third street milton keynes t/n BM147029. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 mar 2004 Consegnato il 17 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as unit 9 nuffield way abingdon t/n ON49772. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0