T J HUGHES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàT J HUGHES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00224422
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di T J HUGHES LIMITED?

    • (5212) /

    Dove si trova T J HUGHES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ERNST & YOUNG LLP
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di T J HUGHES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    T. J. HUGHES PLC30 apr 199230 apr 1992
    T.J.HUGHES & COMPANY LIMITED14 set 192714 set 1927

    Quali sono gli ultimi bilanci di T J HUGHES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 gen 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per T J HUGHES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagine4.72

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    10 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 dic 2015

    15 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 dic 2014

    14 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 dic 2013

    15 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Chi sono gli amministratori di T J HUGHES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    T J HUGHES (COMPANY SECRETARY) LIMITED
    London Road
    L3 8JA Liverpool
    Hughes House
    United Kingdom
    Segretario
    London Road
    L3 8JA Liverpool
    Hughes House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00224422
    118815860001
    LISTER, Robert
    c/o Ernst & Young Llp
    Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    100
    Amministratore
    c/o Ernst & Young Llp
    Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    100
    United KingdomBritish161099370001
    BOYFIELD, Stephen Andrew
    Fir Trees
    Beechwood Lane Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Fir Trees
    Beechwood Lane Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Cheshire
    English17685690001
    FOSTER, George William
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    Segretario
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    British106832100001
    GILBERT, Paul John Thomas
    WA14
    Segretario
    WA14
    British149769990001
    GOODY, Andrew John
    36 Woodkind Hey
    Spital
    CH63 9JZ Wirral
    Segretario
    36 Woodkind Hey
    Spital
    CH63 9JZ Wirral
    British76861870002
    POTTER, Anthony Philip
    16 Saxon Road
    Hoylake
    CH47 3AE Wirral
    Merseyside
    Segretario
    16 Saxon Road
    Hoylake
    CH47 3AE Wirral
    Merseyside
    British41904110002
    BAILEY, Susan
    14 Gayton Lane
    CH60 3SJ Gayton
    Wirral
    Amministratore
    14 Gayton Lane
    CH60 3SJ Gayton
    Wirral
    British82196590001
    BARTON, James
    9 Birchwood Road
    BR5 1NX Petts Wood
    Kent
    Amministratore
    9 Birchwood Road
    BR5 1NX Petts Wood
    Kent
    British84172520001
    BAYLIS, Vincent Wilfred
    6 Croft Edge
    Oxton
    L43 5UD Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    6 Croft Edge
    Oxton
    L43 5UD Birkenhead
    Merseyside
    British17685700001
    BECKWITH, John Lionel, Sir
    55 Campden Hill Road
    Kensington
    W8 7DY London
    Amministratore
    55 Campden Hill Road
    Kensington
    W8 7DY London
    United KingdomBritish1017520002
    BECKWITH, John Lionel
    6 Lichfield Road
    Kew
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Amministratore
    6 Lichfield Road
    Kew
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    British1017520001
    BOYFIELD, Stephen Andrew
    Fir Trees
    Beechwood Lane Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Fir Trees
    Beechwood Lane Culcheth
    WA3 4HJ Warrington
    Cheshire
    EnglandEnglish17685690001
    DICKIE, Robin
    1 Gatcombe Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2GG Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    1 Gatcombe Close
    Radcliffe On Trent
    NG12 2GG Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish66824830001
    DOUGLAS, Brian Archibald Speedie
    Ladybank
    The Avenue
    RH1 5RY South Nutfield
    Surrey
    Amministratore
    Ladybank
    The Avenue
    RH1 5RY South Nutfield
    Surrey
    British73459970001
    DUNN, Barry John Keith
    4 The Walled Garden
    Shaw Hill Drive
    PR6 7PD Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    4 The Walled Garden
    Shaw Hill Drive
    PR6 7PD Chorley
    Lancashire
    British60493690001
    FONTAINE, Mark Philip
    6 Lickey Grange Drive
    Marlbrook
    B60 1RD Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Lickey Grange Drive
    Marlbrook
    B60 1RD Bromsgrove
    Worcestershire
    British40505630003
    FOSTER, George William
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish106832100001
    GILBERT, Paul John Thomas
    WA14
    Amministratore
    WA14
    EnglandBritish149769990001
    GOODY, Andrew John
    36 Woodkind Hey
    Spital
    CH63 9JZ Wirral
    Amministratore
    36 Woodkind Hey
    Spital
    CH63 9JZ Wirral
    British76861870002
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    HODGES, Eric
    16 Whitebeam Walk
    Greasby
    L49 3QJ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    16 Whitebeam Walk
    Greasby
    L49 3QJ Wirral
    Merseyside
    British17113000001
    HOWARD, Robin Paul
    Coppers 8 Wrigleys Lane
    Formby
    L37 7DR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Coppers 8 Wrigleys Lane
    Formby
    L37 7DR Liverpool
    Merseyside
    British60540010001
    HOYER MILLAR, Christian Gurth
    27 Trevor Place
    SW7 1LD London
    Amministratore
    27 Trevor Place
    SW7 1LD London
    British10411140001
    KELLY, Bernard
    109 Studdridge Street
    SW6 3TD London
    Amministratore
    109 Studdridge Street
    SW6 3TD London
    British78649990004
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Amministratore
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LAFON MACDONALD, Beatrice Madeline Valarie
    Hughes House
    London Road
    L3 8JA Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Hughes House
    London Road
    L3 8JA Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish82963210005
    LUPER, David Elliott
    Beech Hill Road
    Wylde Green
    B72 1BY Sutton Coldfield
    35
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Beech Hill Road
    Wylde Green
    B72 1BY Sutton Coldfield
    35
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish159975170001
    MCCAUSLAND, Neil William
    Frensham Court House
    20 Gardeners Hill Road
    GU10 3JB Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Frensham Court House
    20 Gardeners Hill Road
    GU10 3JB Farnham
    Surrey
    EnglandBritish81700630003
    MCDONALD, Paul Andrew
    Hughes House
    London Road
    L3 8JA Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Hughes House
    London Road
    L3 8JA Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish122906510001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Amministratore
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    MCDOWELL, Catherine
    27 Routh Road
    SW18 3SP London
    Amministratore
    27 Routh Road
    SW18 3SP London
    British65638230002
    PLUMMER, Jeremy James
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    EnglandBritish3994380002
    POTTER, Anthony Philip
    16 Saxon Road
    Hoylake
    CH47 3AE Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    16 Saxon Road
    Hoylake
    CH47 3AE Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish41904110002
    ROBERTSON, John Manwaring
    Wellers Place Farm
    Bentworth
    GU34 5JH Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Wellers Place Farm
    Bentworth
    GU34 5JH Alton
    Hampshire
    EnglandBritish23497540002

    T J HUGHES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture and guarantee
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 06 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP, as Security Trustee
    Transazioni
    • 06 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2011
    Consegnato il 14 mar 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 14 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A deed of charge over deposit
    Creato il 03 mar 2011
    Consegnato il 05 mar 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge its entire right title and interest in and to the deposit being all money standing to the credit of account number 06027732 and sort code 12-17-40 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of charge over deposit
    Creato il 28 gen 2011
    Consegnato il 05 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being all money standing to the credit of account no. 6006341, sort code 80-17-40 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge over shares
    Creato il 28 gen 2011
    Consegnato il 05 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares being 1 ordinary share of £1.00 in t j hughes (properties) company limited and all othr shares in the capital of t j hughes (properties) company limited, all rights, dividend. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 21 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that l/h land k/a the department store regent house 1 high street kidderminster t/no HW109222, all that l/h land k/a the department store at 27 bell street wolverhampton west midlands t/no WM529420, all that l/h land k/a 177-187 terminus road eastbourne BN21 3NX (for further details of properties charged please see schedule to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 03 giu 1996
    Consegnato il 06 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as land/blds on the north side of pighue lane liverpool merseyside and the proceeds of sale thereof; t/no ms 354900. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 apr 1994
    Consegnato il 13 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Warehouse at binns road liverpool the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    T J HUGHES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 dic 2012Fine dell'amministrazione
    30 giu 2011Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    DataTipo
    24 dic 2012Inizio della liquidazione
    29 mar 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0