LAVA CAPITAL UK LIMITED

LAVA CAPITAL UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLAVA CAPITAL UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00224601
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chancery House
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHELLEY OAK LIMITED15 dic 200815 dic 2008
    SHELLEY OAK PLC20 mar 200620 mar 2006
    QUINCUNX PLC11 gen 199511 gen 1995
    SR RESTAURANT PLC10 ago 199410 ago 1994
    SCOTT'S RESTAURANT, PUBLIC LIMITED COMPANY22 set 192722 set 1927

    Quali sono gli ultimi bilanci di LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2020

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2016

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ago 2015

    Stato del capitale al 12 ago 2015

    • Capitale: GBP 300,000
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Philip James Curwen come segretario in data 29 giu 2013

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2014

    Stato del capitale al 09 ott 2014

    • Capitale: GBP 300,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2013 al 30 giu 2014

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Snaebjorn Sigurdsson come amministratore in data 26 giu 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di So Director Limited come amministratore in data 26 giu 2014

    2 pagineAP02

    Chi sono gli amministratori di LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PERRY, Alan
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish125162690001
    SO DIRECTOR LIMITED
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione06045490
    190248950001
    BLAND, Geoffrey Charles
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    Segretario
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    British1763600001
    CURWEN, Philip James
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    155749400001
    CURWEN, Philip James
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    British161979510001
    FOKES, Brian Ronald
    34 Rowan Way
    Rottingdean
    BN2 7FP Brighton
    East Sussex
    Segretario
    34 Rowan Way
    Rottingdean
    BN2 7FP Brighton
    East Sussex
    British14013980001
    PRICHARD-JONES, Kenneth Victor
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Segretario
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British37769570002
    NETWORK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    50353670001
    BENNISON, Peter James
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    Amministratore
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    EnglandBritish88640070003
    BLAND, Geoffrey Charles
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    Amministratore
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    EnglandBritish1763600001
    HELGASON, Arni
    19
    Reykjavik
    Kambasel
    109
    Iceland
    Amministratore
    19
    Reykjavik
    Kambasel
    109
    Iceland
    IcelandIcelander137732190002
    KERMAN, Anthony David
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    Amministratore
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    United KingdomBritish72531870002
    KERMAN, Isidore
    11 Mansfield Street
    W1M 0AH London
    Amministratore
    11 Mansfield Street
    W1M 0AH London
    British35542530001
    KERMAN, Nicholas
    25 Eaton Mews South
    SW1W 9HR London
    Amministratore
    25 Eaton Mews South
    SW1W 9HR London
    EnglandBritish55578530001
    LORENZ, Robert Jacques
    97 St Johns Wood Terrace
    NW8 6PP London
    Amministratore
    97 St Johns Wood Terrace
    NW8 6PP London
    British3397220001
    OSBORNE, Clarke Anthony
    1 Malthouse Barn
    Barn Lane Chelwood
    BS18 4NN Bristol
    Amministratore
    1 Malthouse Barn
    Barn Lane Chelwood
    BS18 4NN Bristol
    British48713080003
    PRICHARD JONES, Kenneth Victor
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish118944980001
    PRICHARD JONES, Sebastian James
    Flat 4
    26/27 Great Tower Street
    EC3R 5AQ London
    Amministratore
    Flat 4
    26/27 Great Tower Street
    EC3R 5AQ London
    EnglandBritish69343350002
    PRICHARD-JONES, Dagmar Eve
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British6556330001
    PRICHARD-JONES, Kenneth Victor
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British37769570002
    SCHINDLER, Darren
    86 Stag Leys
    KT21 2TL Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    86 Stag Leys
    KT21 2TL Ashtead
    Surrey
    British118944850001
    SIGURDSSON, Snaebjorn
    Kirkjusandi 2
    155 Reyjavik
    Islandsbanki Hf
    Iceland
    Amministratore
    Kirkjusandi 2
    155 Reyjavik
    Islandsbanki Hf
    Iceland
    IcelandIcelandic168776090001
    COLERIDGE PARTNERS LLP
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    120033030001
    CONSOLIDATED HOLDINGS PLC
    PO BOX 134 4th North Suite
    Town Mills Trinity Square
    GY1 3HN St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    PO BOX 134 4th North Suite
    Town Mills Trinity Square
    GY1 3HN St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    109847110001
    DRAGON DIRECTORS LIMITED
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    85218910001
    ENTERPRISE CORPORATION
    P O Box 556 Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Amministratore
    P O Box 556 Charlestown
    Nevis
    West Indies
    52245280001
    MANAGEMENT CORPORATION
    P O Box 556
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Amministratore
    P O Box 556
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    51797180001
    STJORNARMENN ENF
    Skofarhlid 12
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    Amministratore
    Skofarhlid 12
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    126702600001
    STJORNARZ EHF
    Borgartun 18,
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    Amministratore
    Borgartun 18,
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    120033190001
    STJORNARZ EHF
    Borgartun 18,
    Reykjavik
    105
    Iceland
    Amministratore
    Borgartun 18,
    Reykjavik
    105
    Iceland
    120033190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Jason Scott Haigh
    CM23 4FS Bishops Stortford
    19 Ploughmans Close
    Hertfordshire
    England
    06 apr 2016
    CM23 4FS Bishops Stortford
    19 Ploughmans Close
    Hertfordshire
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Christopher James Duncan Mcdougall
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: Australian
    Paese di residenza: Australia
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    LAVA CAPITAL UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of priorities containing a charging clause
    Creato il 03 lug 2009
    Consegnato il 21 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any money or assets which the company receives in contravention of the deed which has not been agreed by the senior creditor see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of priorities
    Creato il 31 mar 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from consero homes dartnell ave limited to the chargee and the senior creditor not exceeding £4,205,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any money or assets which the company receives in contravention of the deed, which has not been agreed by the senior creditor see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of priorities
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 01 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from consero more lane limited (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any money or assets which the company receives. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture and charge
    Creato il 12 mar 2007
    Consegnato il 29 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets and undertaking of the company including uncalled capital and including all monies due under and all security for loans made by the company from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Sparisjodur Velstjora
    Transazioni
    • 29 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1992
    Consegnato il 21 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage bristol lawn tennis & squash centre, redland green, redland, bristol by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property the plant machinery and fixtures and fittings, furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business of a licenced publican etc the benefit of all licences (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1992
    Consegnato il 04 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Creato il 31 mar 1992
    Consegnato il 04 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 1 pont street l/b of kensington and chelsea, greater london title no. 334759 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment the goodwill of the business the benefit of all justices, excise or other licences (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 ott 1991
    Consegnato il 07 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 4-7 (inclusive) victoria buildings, terminus place, l/b of city of westminster, greater london, title no. 353505 fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture andequipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 12 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mirabelle restaurant 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 25 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1987
    Consegnato il 12 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 9, 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipement.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1987
    Consegnato il 02 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,200,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H premises at pickering place vaults (title no 106860) l/h premises at 5 st.jame's street (title no ln U04252) l/h premises at 4/7 victoria buildings (title no ln 65915). (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Mr L Muller
    Transazioni
    • 02 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1984
    Consegnato il 27 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 81 & 83 buckingham alace road and 164 victoria street, london SW1 title no. 249201.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 gen 1966
    Consegnato il 12 gen 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000
    Brevi particolari
    1 & 2 great windmill street 18, 19, 20 coventry street W1.
    Persone aventi diritto
    • Legal & General Assurance Society LTD
    Transazioni
    • 12 gen 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0