LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED

LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00225815
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED?

    • Attività di società sportive (93120) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hazelwood Centre
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Cessazione della carica di Mark Laurence Bensted come amministratore in data 30 set 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2021

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2020

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Brian William Ernest Facer come amministratore in data 06 feb 2021

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 002258150019, creata il 24 dic 2020

    40 pagineMR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2019

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Adrian Alli come segretario in data 24 lug 2020

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Paul Forsyth come segretario in data 24 lug 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2019 al 29 giu 2019

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017

    13 pagineAA

    Nomina di Mr Brian Facer come amministratore in data 16 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Mary Assumpta Cusack come amministratore in data 28 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Francis Cusack come amministratore in data 28 feb 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2016

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLI, Adrian
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    Segretario
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    272760590001
    CROSSAN, Michael Rowland
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    Amministratore
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    BritishBritish183794460001
    ADAMS, Peter Charles
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    Segretario
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    British181387400001
    BYRNE, Trevor Anthony, Mr.
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    Segretario
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    186736810001
    FORSYTH, Paul
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    Segretario
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    198732360001
    GUMM, Paul
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    Segretario
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    British130071670002
    JAMES, David
    18-20 Southwark Street
    SE1 1TS London
    Segretario
    18-20 Southwark Street
    SE1 1TS London
    British42416910001
    MC GAUGHEY, Patrick
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Segretario
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Irish15772640001
    MILES, Christopher
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    Segretario
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    165079020001
    STACPOOLE, John
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    Segretario
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    British39470570001
    WILLIAMS, Helen Wyn
    33 Andover Road
    TW2 6PD Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    33 Andover Road
    TW2 6PD Twickenham
    Middlesex
    British57143980001
    BENSTED, Mark Laurence
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    Amministratore
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    EnglandBritish183794530001
    BRADY, Hugh Rochfort
    16 Selwood Terrace
    SW7 London
    Amministratore
    16 Selwood Terrace
    SW7 London
    British40514330001
    CONLAN, John Oliver
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish9020510001
    CUSACK, Mary Assumpta
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    EnglandIrish183794520001
    CUSACK, Philip Francis
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    EnglandIrish183794510001
    FACER, Brian William Ernest
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    Amministratore
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    EnglandBritish239035370001
    FITZGERALD, David
    The Avenue
    TW16 5EQ Sunbury-On-Thames
    London Irish Rfc
    Middlesex
    England
    Amministratore
    The Avenue
    TW16 5EQ Sunbury-On-Thames
    London Irish Rfc
    Middlesex
    England
    EnglandIrish183794500001
    FORSYTHE, James Roy
    104 Earls Court Road
    W8 6EG London
    Amministratore
    104 Earls Court Road
    W8 6EG London
    British15772650001
    JACKSON, David
    141 Argyle Road
    Ealing
    W13 8ER London
    Amministratore
    141 Argyle Road
    Ealing
    W13 8ER London
    United KingdomBritish2147720001
    JAMES, Peter
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    British125239810001
    JOHNSTON, Ronald Mervyn
    19 Greenhill Close
    GU15 1PG Camberley
    Surrey
    Amministratore
    19 Greenhill Close
    GU15 1PG Camberley
    Surrey
    British15772660001
    LITTLE, Brian Thomas
    Cobb Hall Cottage Backway
    Great Haseley
    OX44 7JS Oxford
    Amministratore
    Cobb Hall Cottage Backway
    Great Haseley
    OX44 7JS Oxford
    British40499770001
    MC GAUGHEY, Patrick
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Amministratore
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Irish15772640001
    MCPHILLIPS, Charles Declan Francis
    10 Abbottsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    10 Abbottsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    British47193040001
    MULLIN, Brendan
    Albert Lodge
    3 Stillorgan Road
    DUBLIN 4 Donnybrook
    Ireland
    Amministratore
    Albert Lodge
    3 Stillorgan Road
    DUBLIN 4 Donnybrook
    Ireland
    Irish90335420001
    ONEILL, John Gerard
    Willows Farmhouse Stratton Audley
    OX6 9BA Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    Willows Farmhouse Stratton Audley
    OX6 9BA Bicester
    Oxfordshire
    Irish55228900001
    STACPOOLE, James Edmund John
    Stylecroft Road
    HP8 4HX Chalfont St. Giles
    Dellcroft
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Stylecroft Road
    HP8 4HX Chalfont St. Giles
    Dellcroft
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish92096790003
    STACPOOLE, John
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    Amministratore
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    EnglandBritish39470570001
    TAYLOR, Ian Charles Boucher
    Woodlands
    TA11 6NS Littleton
    Somerset
    Amministratore
    Woodlands
    TA11 6NS Littleton
    Somerset
    United Kingdom British169792830001
    TRAYNOR, Noel
    29 Priory Crescent
    Sudbury
    HA0 2QR Wembley
    Middlesex
    Amministratore
    29 Priory Crescent
    Sudbury
    HA0 2QR Wembley
    Middlesex
    Irish53605410001
    WALPOLE, Graham Martin
    Leslie Road
    GU24 8LB Chobham
    7
    Surrey
    Amministratore
    Leslie Road
    GU24 8LB Chobham
    7
    Surrey
    EnglandBritish147000430001
    WHITESIDE, Peter Hamilton
    Woodrising
    Shooters Way
    HP4 3NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodrising
    Shooters Way
    HP4 3NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomIrish39170040001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    London Irish Holdings Limited
    Hazelwood Drive
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood
    Middlesex
    England
    14 lug 2016
    Hazelwood Drive
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood
    Middlesex
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 dic 2020
    Consegnato il 29 dic 2020
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The English Sports Council
    Transazioni
    • 29 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 ago 2014
    Consegnato il 04 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Oval Ventures Limited
    • Steve Palmer
    • John Conlon
    Transazioni
    • 04 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 ago 2014
    Consegnato il 30 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Oval Ventures Limited
    • Steve Palmer
    • John Conlan
    Transazioni
    • 30 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2013
    Consegnato il 28 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the rugby bond noteholders and the security trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h land on the north side of manor lane and west of the avenue, sunbury t/no:SY456116 and all f/h land lying to the west of the avenue, sunbury t/no:SY456117, fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Conlan,Steve Palmer and Oval Ventures Limited the Parties Acting in the Capacity of Trustees for Themselves and the Noteholders (The Security Trustees)
    Transazioni
    • 28 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2013
    Consegnato il 28 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h land on the north side of manor lane and west of the avenue, sunbury t/no:SY456116 and all f/h land lying to the west of the avenue, sunbury t/no:SY456117, fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Conlan, Steve Palmer and Oval Ventures Limited the Parties Acting in the Capacity of Trustees for Themselves and the Noteholders (The Security Trustees)
    Transazioni
    • 28 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment
    Creato il 08 mar 2013
    Consegnato il 09 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of security the benefit of each relevant agreement, all rights in each relevant policy (being policy numbers UKDAOO07852112 and 774BLU/P493309A12/476883) including the proceeds of any claims and the benefit of all other contracts guarantees appointments warranties and other documents see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 09 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 mar 2013
    Consegnato il 09 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 09 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 08 mar 2013
    Consegnato il 09 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no SY456116 and f/h land lying to the west of the avenue now forming part of gaflac sports ground sunbury t/no SY456117 any right title and interest in and to the land including the drainage channel comprised with it lying between the two aforementioned titles which is indicated as unregistered on the plan annexed hereto together with the absence of rights to drain surface water drainage into the channel lying between 151 an 153 the avenue sunbury on thames middlesex by way of specific charge, the goodwill & connection of the business or businesses & also by way of a floating security, all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work in progress & other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 09 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 2013
    Consegnato il 06 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,445,400 due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at the avenue sunbury on thames middlesex part to the land under t/no. SY678171 SY456116 and SY456117 and any part of it including all rights attached or appurtenant to it and all immoveable property including buildings fixtures and fixed plant and machinery from time to time situate on it see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Crest Nicholson Operations Limited
    Transazioni
    • 06 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 2011
    Consegnato il 19 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no's SY456116 and SY456117 and f/h property k/a the land on the west side of the avenue sunbury t/no SY678171 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Conlan Steve Palmer and Oval Ventures Limited
    Transazioni
    • 19 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 15 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north of manor lane and to the west side of the avenue sunbury on thames t/nos SY456116 & SY456117; by way of specific charge, the goodwill & connection of the business or businesses & also by way of a floating security, all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work in progress & other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 2008
    Consegnato il 12 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no SY456116, the land lying to the west of the avenue now forming part of the gaflac sports ground sunbury t/no SY456117 and all buildings and fixtures on this land see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Conlan and Steve Palmer and Oval Ventures Limited
    Transazioni
    • 12 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 21 dic 2007
    Consegnato il 03 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the west side of the avenue, sunbury on thames and land being on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/nos SY456116 and SY456117. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 nov 2007
    Consegnato il 05 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 02 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that land lying to the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no SY456116; all that land lying to the west of the avenue now forming part of the gaflac sports ground sunbury t/no SY456117.
    Persone aventi diritto
    • Powerscourt Nominees Limited, Labyrinth Investments Limited, Little Ship Investments Limitedand the Clancy Group PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 06 giu 1995
    Consegnato il 07 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury together with land lying to the west of the avenue sunbury t/no SY456116 & SY456117 inc fixtures & fittings the goodwill of the business & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 07 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 nov 1987
    Consegnato il 10 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee & all other moneys due for goods or services supplied (as defined) under the terms of this deed
    Brevi particolari
    F/H land & premises on the north of manor lane and west of the avenue sunbury-on-thames, middlesex title nos. Sy 456116 & sy 456117 together with goodwill, book debts & other debts.
    Persone aventi diritto
    • Watney Coomb Reid & Truman Limited
    Transazioni
    • 10 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1985
    Consegnato il 25 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £30,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 30/7/85
    Brevi particolari
    F/H land lying to the west of the avenue forming part of gafflac sports ground, sunbury, surrey t/nos. Sy 456116 & sy 456117 together with all fixtures whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Whitbread Company Public Limited Company
    Transazioni
    • 25 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral charge
    Creato il 08 nov 1985
    Consegnato il 25 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Land on the north of manor lane west of the avenue sunbury spelthorne surrey and land going to the west of the avenue sunbury now forming part of gaflac sports ground sunbury title nos: sy 456116 and sy 456117.
    Persone aventi diritto
    • Courage Limited
    Transazioni
    • 25 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 mar 2024Conclusione della liquidazione
    02 giu 2023Data della petizione
    19 lug 2023Inizio della liquidazione
    12 giu 2024Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Praticante
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0