JOHN BRYANT & SONS LIMITED

JOHN BRYANT & SONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJOHN BRYANT & SONS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00226166
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Wychwood Court 8 Wychwood Court
    Cotswold Business Village
    GL56 0JQ Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mag 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al11 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma25 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al11 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Julian Gaymond il 09 set 2024

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Anthony Julian Gaymond il 09 set 2024

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2023

    9 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Cotswold Link Moreton-in-Marsh Gloucestershire GL56 0JU England a 8 Wychwood Court 8 Wychwood Court Cotswold Business Village Moreton in Marsh Gloucestershire GL56 0JQ in data 16 ott 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2022

    9 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Estate Office Ladle Farm Armscote Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 8DF a 4 Cotswold Link Moreton-in-Marsh Gloucestershire GL56 0JU in data 16 mag 2023

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ago 2021

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2019

    8 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 002261660017, creata il 03 ago 2018

    39 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2017

    7 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 002261660016, creata il 28 set 2017

    6 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2016

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2016

    Stato del capitale al 12 mag 2016

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ago 2015

    6 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GAYMOND, Anthony Julian
    8 Wychwood Court
    Cotswold Business Village
    GL56 0JQ Moreton In Marsh
    8 Wychwood Court
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Segretario
    8 Wychwood Court
    Cotswold Business Village
    GL56 0JQ Moreton In Marsh
    8 Wychwood Court
    Gloucestershire
    United Kingdom
    156494120001
    ACLAND, Harry Alexander
    Notgrove
    GL54 3BT Cheltenham
    The Manor
    Gloucestershire
    Amministratore
    Notgrove
    GL54 3BT Cheltenham
    The Manor
    Gloucestershire
    EnglandBritishSurveyor46196170002
    GAYMOND, Anthony Julian
    8 Wychwood Court
    Cotswold Business Village
    GL56 0JQ Moreton In Marsh
    8 Wychwood Court
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    8 Wychwood Court
    Cotswold Business Village
    GL56 0JQ Moreton In Marsh
    8 Wychwood Court
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishCivil Engineer1968840009
    BRYANT, Ian Newton Alexander
    Redlands Keep
    Stoke Bliss
    WR15 8QJ Tenbury Wells
    Worcestershire
    Segretario
    Redlands Keep
    Stoke Bliss
    WR15 8QJ Tenbury Wells
    Worcestershire
    British13221050001
    TIMS, Walter William George
    87 New Road
    B60 2LL Bromsgrove
    Worcestershire
    Segretario
    87 New Road
    B60 2LL Bromsgrove
    Worcestershire
    British13221010001
    BERRY, Winifred Hilda
    2a Shepley Road
    Barnt Green
    B45 8JW Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    2a Shepley Road
    Barnt Green
    B45 8JW Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director13221020001
    BRYANT, David Harvey
    87 Bleachfield Street
    B49 5BB Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    87 Bleachfield Street
    B49 5BB Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director13221030001
    BRYANT, Harvey Burden
    3 Church Lane
    Cookhill
    B49 5JS Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Church Lane
    Cookhill
    B49 5JS Alcester
    Warwickshire
    BritishCompany Director13221040001
    BRYANT, Ian Newton Alexander
    Redlands Keep
    Stoke Bliss
    WR15 8QJ Tenbury Wells
    Worcestershire
    Amministratore
    Redlands Keep
    Stoke Bliss
    WR15 8QJ Tenbury Wells
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director13221050001
    COURT, Robert Dennis
    11 Kitebrook Close
    B98 0LN Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    11 Kitebrook Close
    B98 0LN Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director38979320001
    PATTERSON, John Royden Bowater
    145 Fleurance
    Laguna Niguel
    California 92677
    United States
    Amministratore
    145 Fleurance
    Laguna Niguel
    California 92677
    United States
    UsaBritishEngineer133331890001
    ST JOHN MITCHELL, Geoffrey
    Statfold Lane
    WS13 8NY Fradley
    50
    Amministratore
    Statfold Lane
    WS13 8NY Fradley
    50
    Great BritainBritishManager132873600001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JOHN BRYANT & SONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Business Village Ltd
    Armscote
    CV37 8DF Stratford Upon Avon
    Ladle Farm
    Warwickshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Armscote
    CV37 8DF Stratford Upon Avon
    Ladle Farm
    Warwickshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione04504002
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    JOHN BRYANT & SONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 ago 2018
    Consegnato il 03 ago 2018
    In corso
    Breve descrizione
    Freehold property known as weston body hardware crossgates road park farm industrial estate redditch B98 7SN registered at the land registry with title number HW83506.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 set 2017
    Consegnato il 10 ott 2017
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land being weston body hardware, crossgate road, park farm industrial estate, redditch B98 7SN as registered at hm land registry under the title number HW83506.
    Persone aventi diritto
    • Business Village Limited (Company Number. 04504002)
    Transazioni
    • 10 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 22 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 21 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bryant house, washford drive, redditch, t/nos: hw 87304, hw 87305, hw 87306, and hw 81396 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 12 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1997
    Consegnato il 08 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter the cash loan agreement and a guarantee (all as defined therein)
    Brevi particolari
    Land on the north side of washford drive park farm redditch hereford and worcester with all fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bp Oil UK Limited and Mobil Oil Company Limited
    Transazioni
    • 08 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1995
    Consegnato il 22 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land & office/workshop premises at washford drive redditch worcestershire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1995
    Consegnato il 22 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land & office workshop premises at washford drive redditch worcestershire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Further charge
    Creato il 14 lug 1992
    Consegnato il 15 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £262,000.00 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a bryant of redditch filling station washford drive redditch park farm redditch t/no hw 87306 and hw 87305 together with the assigns of goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transazioni
    • 15 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 1988
    Consegnato il 21 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 400000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverincluding sums due for goods sold & delivered under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H premises comprising the petrol filling station carwash shop offices & store fronting washford drive park farm estate redditch worcs together with the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transazioni
    • 21 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 1988
    Consegnato il 18 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at washford drive park farm redditch worcs. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 04 ago 1986
    Consegnato il 06 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 26 mar 1975
    Consegnato il 07 apr 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 52 & 54 birmingham road bromsgrove, worcs.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 apr 1971
    Consegnato il 30 apr 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding sterling pounds 100000
    Brevi particolari
    F/H 52, 54 birmingham rd bromsgrove worcs (see doc 68 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Oral charge
    Creato il 28 ott 1968
    Consegnato il 04 nov 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc from company to lloyds bank LTD
    Brevi particolari
    52, 54 birmingham rd bromsgrove worcs (see doc 68 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Oral charge
    Creato il 25 gen 1968
    Consegnato il 29 gen 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    45 stratford road sparkhill birmingham.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0