WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED

WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILCON HOMES MIDLANDS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00226898
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILCON HOMES MIDLAND LIMITED28 nov 198828 nov 1988
    CHOWNS LIMITED28 dic 192728 dic 1927

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al03 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma17 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al03 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 09 dic 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come amministratore in data 09 dic 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come segretario in data 09 dic 2024

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Sayed Suleiman Ashrafi come segretario in data 09 dic 2024

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 24 apr 2024

    1 pagineTM01

    Nomina di Jennifer Canty come amministratore in data 24 apr 2024

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come segretario in data 29 nov 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Molly Banham come segretario in data 29 nov 2023

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 01 set 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 01 set 2023

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come segretario in data 26 ago 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Miss Molly Banham come segretario in data 26 ago 2022

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come amministratore in data 26 ago 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alice Hannah Black come amministratore in data 26 ago 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Alice Hannah Marsden il 30 mag 2021

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHRAFI, Sayed Suleiman
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    330347810001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary330353690001
    BANHAM, Molly
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    299550800001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Segretario
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    LAWTHER, Samuel David
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460012
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    316506030001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British34521340004
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Secretary116824870001
    STOTE, Tanya
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    British113603590001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BLACK, Alice Hannah
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor264031110002
    BLACK, Ian Craig
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    Amministratore
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant4579780003
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector48396030001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Amministratore
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    HATCH, Christopher John
    Paynes Farm New Road
    Woolmer Green
    SG3 6LE Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Paynes Farm New Road
    Woolmer Green
    SG3 6LE Knebworth
    Hertfordshire
    BritishManaging Director50577850005
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    JORDAN, James John
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary120602100002
    LAWTHER, Samuel David
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishChartered Accountant41835460012
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary34521340004
    MCCALLUM, Graeme Reid
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director152856250001
    MCEWAN, Keith
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritishManaging Director9631320003
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant115863170001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Amministratore
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritishDirector75750250002
    PENNY, Shaun
    41 Micklewood Close
    Penkridge
    ST19 5JE Stafford
    Amministratore
    41 Micklewood Close
    Penkridge
    ST19 5JE Stafford
    BritishRegional Director58706230001
    TUTTE, John Frederick
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector56012720002
    WATTS, Christopher Philip
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant83391430001
    WEIR, John Michael
    Farndon Hill Barn
    Byfield
    NN11 6UQ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Farndon Hill Barn
    Byfield
    NN11 6UQ Daventry
    Northamptonshire
    UkBritishBuilder9417650001
    WILSON, Lynn Anthony
    The Maltings Tithe Farm
    Moulton Road Holcot
    NN6 9SH Northampton
    Amministratore
    The Maltings Tithe Farm
    Moulton Road Holcot
    NN6 9SH Northampton
    BritishBuilder92355200002

    Chi sono le persone con controllo significativo di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione244804
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 giu 2016
    Consegnato il 14 lug 2016
    In corso
    Breve descrizione
    "Overage property".
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Punch Taverns (Pr) Limited
    Transazioni
    • 14 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Mortgage
    Creato il 04 lug 2002
    Consegnato il 10 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The former st crispins hospital northampton.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State
    Transazioni
    • 10 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £4,860,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date together with interest, costs and expenses legal and other costs (all as defined therein)
    Brevi particolari
    The f/h property k/a abbey works and adjoining land, weedon road northampton t/n NN189026.
    Persone aventi diritto
    • Otis Limited "the Secured Party"
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £240,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for sale dated 22ND march 1999
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of hancock road and east side of anthony road saltley under f/h WK49572 and land and buildings k/a all that piece or parcel of land situate in the city of birmingham.
    Persone aventi diritto
    • British Telecommunications PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First legal charge
    Creato il 22 dic 1998
    Consegnato il 04 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the legal charge
    Brevi particolari
    F/H land off houghton road houghton regis dunstable bedfordshire t/nos: BD199039 (part) and BD296919.
    Persone aventi diritto
    • Saxon Developments Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 nov 1998
    Consegnato il 21 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a covenant for further payment made under the legal mortgage
    Brevi particolari
    Land at parchfields farm blithbury road rugeley t/n SF386534 and part SF357097 and SF358126.
    Persone aventi diritto
    • Victoria Jane Pope
    • Adrian John Pope
    • Michael John Pope
    Transazioni
    • 21 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed
    Creato il 18 feb 1998
    Consegnato il 19 feb 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 2ND july 1997 made between caroline teresa adams (1) and gallagher estates limited (2) (as novated by a deed of covenant dated 18TH february 1998 made between homes midlands limited (1) caroline teresa adams (2) and gallagher broughton limited (3))
    Brevi particolari
    F/H land adjoining broughton manor buckinghamshire as more particularly described in the deed of legal charge dated 29TH august 1997 made between gallagher broughton limited (1) and caroline teresa adams (2).
    Persone aventi diritto
    • Caroline Teresa Adams
    Transazioni
    • 19 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1997
    Consegnato il 06 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The land situate at the development site k/a monkstone ldo at milton keynes buckingham.
    Persone aventi diritto
    • Commission for the New Towns
    Transazioni
    • 06 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint legal charge
    Creato il 16 dic 1997
    Consegnato il 06 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or lovell homes limited to the chargee
    Brevi particolari
    Land forming part of the development site k/a monkstone ldo at milton keynes buckingham.
    Persone aventi diritto
    • Commission for the New Towns
    Transazioni
    • 06 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First legal charge
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 being the cost to the chargee of carrying out works to be done by the company under the provisions of an agreement dated 17TH april 1997 and all other monies which may be charged or incurred by the chargee in accordance with the provisions of the legal charge dated 30TH april 1997
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a land off mill road houghton regis dunstable bedfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Saxon Developments Limited
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First legal charge
    Creato il 29 nov 1996
    Consegnato il 03 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000.00 and all other moneys due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement dated 1/10/96 and this legal charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a land off houghton road regis dunstable bedfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Saxon Developments Limited
    Transazioni
    • 03 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ott 1994
    Consegnato il 27 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,170,500.00
    Brevi particolari
    Approx 19.96 acres of land to the south of winchester road bedford.
    Persone aventi diritto
    • John Lockhart Wood
    • Edward Crispin Akers Martineauntthe Trustees of the Whitbread Harrowden Settleme
    • Martin Charles Findlay
    • Bedford Borough Council
    Transazioni
    • 27 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 set 1994
    Consegnato il 23 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,370,000
    Brevi particolari
    F/H property with the buildings and outbuildings at grange road banbury oxfordshre being the site of the banbury cricket club of 6 acres approx.
    Persone aventi diritto
    • Robert Hayes Fox
    • Ernest Alexander Colegrave
    • George Michael Robinsont Clubas Trustees for the Time Being of Banbury Cricke
    Transazioni
    • 23 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 dic 1993
    Consegnato il 16 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £780000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at home farm long lawford rugby warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • Glyn Rhys Evans and Christopher Stuart Pratt
    Transazioni
    • 16 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 nov 1992
    Consegnato il 17 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed (as defined)
    Brevi particolari
    Property at wollaston road stourbridge west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Severn Trent Property Limited
    Transazioni
    • 17 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 ott 1992
    Consegnato il 23 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £672,000 and other monies due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Land forming part of top farm great doddington weelingborough northampton title no: NN138048 and plot of land to west of duke street wellingborough northampton.
    Persone aventi diritto
    • Alan John Cherry,Philip Freeman and Hampton Keynes Investments Limited
    Transazioni
    • 23 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint legal charge
    Creato il 05 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or lovell homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land situate at and known as the mentally handicapped site monkston ldo milton keynes see form 395 ref M465C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Milton Keynes Development Corporation
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Joint legal charge
    Creato il 05 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or lovell homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold land situate at monkston ldo milton keynes and known as the probation centre site see form 395 for full details ref M464C.
    Persone aventi diritto
    • Milton Keynes Development Corporation
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The land value & the corporations increment payable on the sale of a dwelling or building plot (as defined in the legal charge)
    Brevi particolari
    Land situate & k/a housing development site monkston ldo milton keynes (phase 1)freehold.
    Persone aventi diritto
    • Milton Keynes Development Corporation
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 1991
    Consegnato il 12 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land at grimsby green banbury, county of oxford & pursuant to an buildings & fixtures agreement dated fittings plant & machinery 21.6.91.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Anglia Building Society
    Transazioni
    • 12 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 mag 1991
    Consegnato il 10 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    1) £12,500 per plot sale (plot land value) total 207 plots x £12,500 = £2,2587,500 (payable at completion of the resale of each plot) 2) 50% of the sale proceeds of plots at prices above those set out in the 2ND schedule of the mortgage (the corporation increment) 3) £425,000 payable on 28TH 2ND 1992 (the developers contribution) 4) £2,053.14 on account of the sum of £425.000 (the payments & on account payable on any plot I.E. sold before 28.2.92
    Brevi particolari
    F/H land situate at oldbrook k/a housing development site oldbrook south west milton keynes.
    Persone aventi diritto
    • Milton Keynes Development Corporation
    Transazioni
    • 10 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0