WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED
Panoramica
Nome della società | WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00226898 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WILCON HOMES MIDLAND LIMITED | 28 nov 1988 | 28 nov 1988 |
CHOWNS LIMITED | 28 dic 1927 | 28 dic 1927 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 apr 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 09 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come amministratore in data 09 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come segretario in data 09 dic 2024 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Sayed Suleiman Ashrafi come segretario in data 09 dic 2024 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 24 apr 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Jennifer Canty come amministratore in data 24 apr 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come segretario in data 29 nov 2023 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Molly Banham come segretario in data 29 nov 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 01 set 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 01 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come segretario in data 26 ago 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Miss Molly Banham come segretario in data 26 ago 2022 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come amministratore in data 26 ago 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Alice Hannah Black come amministratore in data 26 ago 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 5 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Miss Alice Hannah Marsden il 30 mag 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 pagine | AD02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHRAFI, Sayed Suleiman | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 330347810001 | |||||||
CANTY, Jennifer | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 322288120001 | ||||
HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 330353690001 | ||||
BANHAM, Molly | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 299550800001 | |||||||
HASTINGS, Jonathan Philip | Segretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
LAWTHER, Samuel David | Segretario | Stow Cottage Spaldwick Road, Stow Longa PE18 0TL Huntingdon Cambridgeshire | British | 41835460012 | ||||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 316506030001 | |||||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 34521340004 | ||||||
NUNN, Carol Jayne | Segretario | 4 Juniper Close NN12 6XP Towcester Northamptonshire | British | Company Secretary | 116824870001 | |||||
STOTE, Tanya | Segretario | Honeyburge The Fordrough B90 1PP Solihull West Midlands | British | 113603590001 | ||||||
ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Amministratore | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 193735640001 | ||||
ANDREW, Peter Robert | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Regional Managing Director | 113503830003 | ||||
BLACK, Alice Hannah | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 264031110002 | ||||
BLACK, Ian Craig | Amministratore | 7 The Courtyard Ecton Hall NN6 0QE Ecton Northamptonshire | British | Chartered Accountant | 4579780003 | |||||
CARNEY, Christopher | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 125216670001 | ||||
CLAPHAM, Colin Richard | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 9684390001 | ||||
FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe | Amministratore | 17 Derwent Road AL5 3PA Harpenden Hertfordshire | England | British | Director | 48396030001 | ||||
GREEN, Robert David | Amministratore | 11 Whitworth Lane Loughton MK5 8EB Milton Keynes | England | British | Director | 76720550003 | ||||
HATCH, Christopher John | Amministratore | Paynes Farm New Road Woolmer Green SG3 6LE Knebworth Hertfordshire | British | Managing Director | 50577850005 | |||||
HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 257671040002 | ||||
JOHNSON, Peter Thomas | Amministratore | 34 Homewood Road AL1 4BQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 8895880004 | ||||
JORDAN, James John | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Secretary | 120602100002 | ||||
LAWTHER, Samuel David | Amministratore | Stow Cottage Spaldwick Road, Stow Longa PE18 0TL Huntingdon Cambridgeshire | British | Chartered Accountant | 41835460012 | |||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 34521340004 | ||||
MCCALLUM, Graeme Reid | Amministratore | The Poplars Whinfield Road Dodford B61 9BG Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | Company Director | 152856250001 | ||||
MCEWAN, Keith | Amministratore | 15 Sanders Road Quorn LE12 8JN Loughborough Leicestershire | England | British | Managing Director | 9631320003 | ||||
MURRIN, Jonathan Charles | Amministratore | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 115863170001 | |||||
PEACOCK, Raymond Anthony | Amministratore | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | Director | 75750250002 | ||||
PENNY, Shaun | Amministratore | 41 Micklewood Close Penkridge ST19 5JE Stafford | British | Regional Director | 58706230001 | |||||
TUTTE, John Frederick | Amministratore | Peters Barn West End, Scaldwell NN6 9JX Northampton Northamptonshire | England | British | Director | 56012720002 | ||||
WATTS, Christopher Philip | Amministratore | Halycon Lodge Field Close Ufton CV33 9PH Leamington Spa Warwickshire | British | Accountant | 83391430001 | |||||
WEIR, John Michael | Amministratore | Farndon Hill Barn Byfield NN11 6UQ Daventry Northamptonshire | Uk | British | Builder | 9417650001 | ||||
WILSON, Lynn Anthony | Amministratore | The Maltings Tithe Farm Moulton Road Holcot NN6 9SH Northampton | British | Builder | 92355200002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Connolly Limited | 06 apr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
WILCON HOMES MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 29 giu 2016 Consegnato il 14 lug 2016 | In corso | ||
Breve descrizione "Overage property". Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 04 lug 2002 Consegnato il 10 lug 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The former st crispins hospital northampton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 30 giu 2000 Consegnato il 06 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The sum of £4,860,000 due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date together with interest, costs and expenses legal and other costs (all as defined therein) | |
Brevi particolari The f/h property k/a abbey works and adjoining land, weedon road northampton t/n NN189026. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 22 mar 1999 Consegnato il 08 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £240,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for sale dated 22ND march 1999 | |
Brevi particolari Land and buildings on the south side of hancock road and east side of anthony road saltley under f/h WK49572 and land and buildings k/a all that piece or parcel of land situate in the city of birmingham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
First legal charge | Creato il 22 dic 1998 Consegnato il 04 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the legal charge | |
Brevi particolari F/H land off houghton road houghton regis dunstable bedfordshire t/nos: BD199039 (part) and BD296919. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 19 nov 1998 Consegnato il 21 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a covenant for further payment made under the legal mortgage | |
Brevi particolari Land at parchfields farm blithbury road rugeley t/n SF386534 and part SF357097 and SF358126. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed | Creato il 18 feb 1998 Consegnato il 19 feb 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 2ND july 1997 made between caroline teresa adams (1) and gallagher estates limited (2) (as novated by a deed of covenant dated 18TH february 1998 made between homes midlands limited (1) caroline teresa adams (2) and gallagher broughton limited (3)) | |
Brevi particolari F/H land adjoining broughton manor buckinghamshire as more particularly described in the deed of legal charge dated 29TH august 1997 made between gallagher broughton limited (1) and caroline teresa adams (2). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 dic 1997 Consegnato il 06 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The land situate at the development site k/a monkstone ldo at milton keynes buckingham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Joint legal charge | Creato il 16 dic 1997 Consegnato il 06 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or lovell homes limited to the chargee | |
Brevi particolari Land forming part of the development site k/a monkstone ldo at milton keynes buckingham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
First legal charge | Creato il 30 apr 1997 Consegnato il 07 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000 being the cost to the chargee of carrying out works to be done by the company under the provisions of an agreement dated 17TH april 1997 and all other monies which may be charged or incurred by the chargee in accordance with the provisions of the legal charge dated 30TH april 1997 | |
Brevi particolari All that f/h property k/a land off mill road houghton regis dunstable bedfordshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
First legal charge | Creato il 29 nov 1996 Consegnato il 03 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000.00 and all other moneys due from the company to the chargee pursuant to the terms of an agreement dated 1/10/96 and this legal charge | |
Brevi particolari F/H property k/a land off houghton road regis dunstable bedfordshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 ott 1994 Consegnato il 27 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,170,500.00 | |
Brevi particolari Approx 19.96 acres of land to the south of winchester road bedford. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 20 set 1994 Consegnato il 23 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,370,000 | |
Brevi particolari F/H property with the buildings and outbuildings at grange road banbury oxfordshre being the site of the banbury cricket club of 6 acres approx. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 10 dic 1993 Consegnato il 16 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £780000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land at home farm long lawford rugby warwickshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 nov 1992 Consegnato il 17 nov 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed (as defined) | |
Brevi particolari Property at wollaston road stourbridge west midlands. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 ott 1992 Consegnato il 23 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £672,000 and other monies due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Land forming part of top farm great doddington weelingborough northampton title no: NN138048 and plot of land to west of duke street wellingborough northampton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Joint legal charge | Creato il 05 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or lovell homes limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold land situate at and known as the mentally handicapped site monkston ldo milton keynes see form 395 ref M465C for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Joint legal charge | Creato il 05 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or lovell homes limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold land situate at monkston ldo milton keynes and known as the probation centre site see form 395 for full details ref M464C. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 05 feb 1992 Consegnato il 20 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The land value & the corporations increment payable on the sale of a dwelling or building plot (as defined in the legal charge) | |
Brevi particolari Land situate & k/a housing development site monkston ldo milton keynes (phase 1)freehold. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 05 lug 1991 Consegnato il 12 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari F/H land at grimsby green banbury, county of oxford & pursuant to an buildings & fixtures agreement dated fittings plant & machinery 21.6.91. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 22 mag 1991 Consegnato il 10 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 1) £12,500 per plot sale (plot land value) total 207 plots x £12,500 = £2,2587,500 (payable at completion of the resale of each plot) 2) 50% of the sale proceeds of plots at prices above those set out in the 2ND schedule of the mortgage (the corporation increment) 3) £425,000 payable on 28TH 2ND 1992 (the developers contribution) 4) £2,053.14 on account of the sum of £425.000 (the payments & on account payable on any plot I.E. sold before 28.2.92 | |
Brevi particolari F/H land situate at oldbrook k/a housing development site oldbrook south west milton keynes. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0