PATEN & CO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPATEN & CO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00227473
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PATEN & CO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PATEN & CO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Clb Coopers 5th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PATEN & CO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PATEN & CO. (PETERBOROUGH) LIMITED20 gen 192820 gen 1928

    Quali sono gli ultimi bilanci di PATEN & CO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per PATEN & CO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 10th Floor, the Mille 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW England a C/O Clb Coopers 5th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU in data 14 feb 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 gen 2019

    LRESSP

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2018

    22 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 002274730013 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 ott 2017

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 002274730013

    5 pagineMR05

    Bilancio redatto al 31 ott 2016

    22 pagineAA

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 002274730013

    7 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 002274730013

    7 pagineMR05

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Redefine Bdl Hotels 10th Floor the Mille 1000 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DW a 10th Floor, the Mille 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW in data 17 mar 2017

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    5 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 ott 2015

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2016

    Stato del capitale al 03 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,135,000
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 002274730013, creata il 22 gen 2016

    49 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di PATEN & CO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCAFFER, Stuart John
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    Segretario
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    British64903230004
    LAPPING, Andrew Christopher
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    Amministratore
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    United KingdomBritish113467730001
    MCCAFFER, Stuart John
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    Amministratore
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    ScotlandBritish64903230004
    SCOTT, Steven
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    Amministratore
    Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Clb Coopers 5th Floor
    ScotlandBritish95772100002
    BODGER, Barbara Alicia Mary
    35 Holywell Way
    Longthorpe
    PE3 6SS Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    35 Holywell Way
    Longthorpe
    PE3 6SS Peterborough
    Cambridgeshire
    British14712200001
    BODGER, Barbara Alicia Mary
    35 Holywell Way
    Longthorpe
    PE3 6SS Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    35 Holywell Way
    Longthorpe
    PE3 6SS Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish14712200001
    JOHNSTON, Paul Mcphie
    Sutherland Avenue
    G41 4JJ Glasgow
    7
    Scotland
    Amministratore
    Sutherland Avenue
    G41 4JJ Glasgow
    7
    Scotland
    United KingdomBritish87082600003
    KELLIE, Angela Helen
    Shatton Hall Farm
    Bamford
    S30 2BG Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    Shatton Hall Farm
    Bamford
    S30 2BG Sheffield
    Yorkshire
    British15628230001
    MORTON, Janet Angela
    7 Thorpe Avenue
    PE3 6LA Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    7 Thorpe Avenue
    PE3 6LA Peterborough
    Cambridgeshire
    British15628240001
    O'MALLEY, John
    132 Widney Manor Road
    B91 3JJ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    132 Widney Manor Road
    B91 3JJ Solihull
    West Midlands
    British84334340001
    PADLEY, John Michael
    Wheelwright Cottage Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Wheelwright Cottage Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish14712220001
    PADLEY, Priscilla Mary
    Wheelwright Cottage Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Wheelwright Cottage Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish15628250001
    PATEN, Richard Alfred, Rev
    Flat 19
    The Lindens
    PE1 2SN Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Flat 19
    The Lindens
    PE1 2SN Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish9088390004
    SANDBACH, Richard Stainton Edward
    91 Lincoln Road
    PE1 2SH Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    91 Lincoln Road
    PE1 2SH Peterborough
    Cambridgeshire
    British5218810001
    SMITH, Robert Neil
    Constable Way
    Black Notley
    CM77 8FE Braintree
    55
    Essex
    Amministratore
    Constable Way
    Black Notley
    CM77 8FE Braintree
    55
    Essex
    EnglandBritish133658120001
    WHEADON, Anthony William
    The White House 43 High Street
    St Martins
    PE9 2LP Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    The White House 43 High Street
    St Martins
    PE9 2LP Stamford
    Lincolnshire
    British14712210001
    WOODCOCK, Louis Peter
    Bath Road
    Sipson Way
    UB7 0DP West Drayton
    Holiday Inn Heathrow
    Middlesex
    Amministratore
    Bath Road
    Sipson Way
    UB7 0DP West Drayton
    Holiday Inn Heathrow
    Middlesex
    United KingdomBritish39601150005

    Chi sono le persone con controllo significativo di PATEN & CO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bdl Select Hotels Ltd
    1000 Great West Road
    TW8 9DW Brentford
    10th Floor, The Mille
    London
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1000 Great West Road
    TW8 9DW Brentford
    10th Floor, The Mille
    London
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneUk Register Of Companies
    Numero di registrazione06451748
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PATEN & CO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 gen 2016
    Consegnato il 03 feb 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The grosvenor hotel warwick road stratford upon avon warwickshire t/n WK338122.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Icg-Longbow Debt Investments No. 4 S.a R.L.
    Transazioni
    • 03 feb 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 20 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 20 mag 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 04 apr 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 31 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 15 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land t/n EX523541 and being the marks tey hotel london road colchester by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land t/n WK338122 being grosvenor house hotel warwick road stratford upon avon by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The swan hotel bedford being f/h land t/n BD99696 and land and buildings on the north side of the embankment bedford and (2) land k/a swan hotel bedford.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Langstone hotel being (1) havant albany inn northney road north common t/n HP82342 (2) havant posthouse northney road north common havant t/n HP97549 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    63 st marys road stratford upon avon t/n WK93504 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold interest in the bull hotel westgate pterborough comprised in leases dated 2.2.61, 9.12.88 and 19.10.90 with the benefit of all rights etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Underlease of the grosvenor house hotel warwick road stratford upon avon t/no;-WK338122. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H interest in land comprising car park at the bull hotel westgate peterborogh. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the bull hotel westgate peterborough t/no;-CB79690. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at fitzwilliam street peterborough t/no;-CB155627. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lease
    Creato il 17 feb 1986
    Consegnato il 28 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The george hotel george street/sheep street kettering northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Bass Holdings Limited
    Transazioni
    • 28 feb 1986Registrazione di un'ipoteca (395)

    PATEN & CO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 gen 2021Data di scioglimento
    24 gen 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Forsyth
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Praticante
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0