CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED

CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCITY WALL (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00228008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RANK CITY WALL LIMITED11 feb 192811 feb 1928

    Quali sono gli ultimi bilanci di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 dic 2018

    8 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 dic 2017

    8 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor, 30 Market Place London W1W 8AP England a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 27 nov 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Market Place London W1W 8AP England a 4th Floor, 30 Market Place London W1W 8AP in data 05 set 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Noe Group (Corporate Services) Limited come amministratore in data 30 ago 2017

    2 pagineAP02

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Market Place London W1W 8AP England a 30 Market Place London W1W 8AP in data 30 ago 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Finsbury Square London EC2P 2YU a 30 Market Place London W1W 8AP in data 30 ago 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di F&C Reit (Corporate Services) Limited come segretario in data 08 ago 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di F&C Reit (Corporate Services) Limited come amministratore in data 08 ago 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 02 mag 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Wigmore Street London W1U 1PB a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 20 gen 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 dic 2016

    LRESSP

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 set 2015 al 28 set 2015

    2 pagineAA01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 lug 2016

    Stato del capitale al 11 lug 2016

    • Capitale: GBP 26,490,138
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2015 al 29 set 2015

    2 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MEADS, Paul Graham
    Rockdene Close
    RH19 3HA East Grinstead
    15
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Rockdene Close
    RH19 3HA East Grinstead
    15
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor168880940001
    NOE GROUP (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Market Place
    W1W 8AP London
    30
    England
    Amministratore
    Market Place
    W1W 8AP London
    30
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione10609062
    235013180001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    147824490001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Amministratore
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Amministratore
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Amministratore
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Amministratore
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Amministratore
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Amministratore
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Amministratore
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    F&C REIT (CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3239672
    183276050001
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    147824490001

    CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 nov 2013
    Consegnato il 30 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aareal Bank Ag, Wiesbaden as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Assignation in security
    Creato il 05 ago 1997
    Consegnato il 06 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations monies and liabilities due or to become due from the obligants (as defined) to the chargee as trustee under the trust deed
    Brevi particolari
    All and whole the tenants interest under an agreement and lease among east kilbride development corporation city wall properties (scotland) limited and city wall properties limited of the subjects known and forming part of the plaza centre east kilbride and all the company's whole right and title under the trust agreement for full details of all charged assets please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 01 nov 1996
    Consegnato il 07 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the various documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    All and whole the tenant's interest under an agreement and lease entered into between east kilbride development corporation, city wall properties (scotland) limited and city wall properties limited of subjects k/a and forming the plaza centre, east kilbride lying in the county of lanark.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transazioni
    • 07 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 06 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal amount of and interest due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the trust deed dated 14/9/81 the first mortgage debenture stock 2019/24 and this deed
    Brevi particolari
    £3,140,000.
    Persone aventi diritto
    • Ldc Trustees Limited
    Transazioni
    • 06 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 13 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000,000 9 3/8 per cent. First mortgage debenture stock 2028 of the british land company PLC (the "parent") and all other moneys due from the parent to royal exchange trust company limited and all other persons or companies acting under the trust deed and any other deeds supplemental thereto as trustees, subject to a maximum of £1,000,000,000
    Brevi particolari
    F/Hold land/blds at bain clarkson house,harlands rd,yaywards heath,west sussex;t/no.wsx 15114; all fixtures,fittings,fixed plant/machinery....etc. See form 395.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limitedthe "Trustee"
    Transazioni
    • 13 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of substitution and charge.
    Creato il 16 nov 1987
    Consegnato il 20 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 5,000,000 due or to become due from the company and/or city wall properties limited and or merbridge properties limited to the chargee under the terms of the principal deeds
    Brevi particolari
    City wall house, eastrop basingstoke title no hp 108348 part title no hp 110271 (see doc M103/23 nuu/44).
    Persone aventi diritto
    • Royal Liver Trustees Limited
    Transazioni
    • 20 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 10 mar 1987
    Consegnato il 13 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the british land company PLC to the chargeenot exceeding sterling pounds 10,000,000
    Brevi particolari
    Easterhouse township centre, waterhouse road, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Deed of release and substitution
    Creato il 15 feb 1978
    Consegnato il 17 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Debenture stock amounting to sterling pounds 4,625,000
    Brevi particolari
    The freehold property known as brunel house the yard portsmouth.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Stare Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of release effecting substitution of security
    Creato il 10 giu 1976
    Consegnato il 23 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 secured by a trust deed dated 8/5/73 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    East kilbride shopping centre east kilbride, lanarkshire, scotland.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transazioni
    • 23 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    Standard security presented for registration at the register of sasines on the 11/6/76
    Creato il 10 giu 1976
    Consegnato il 23 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 secured by a trust deed dated 8/5/73 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    East kilbride shopping centre east kilbride, lanarkshire, scotland.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transazioni
    • 23 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    15,000,000 inclusive of £14,000,000 secured by a trust deed doc 8/5/734 deeds supplemental
    Creato il 31 dic 1975
    Consegnato il 08 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 08 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 31 dic 1975
    Consegnato il 05 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000
    Brevi particolari
    Headlease intended to be granted to the company pursuant to the provisions of an agreement act 7/8/1969.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 05 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 29 ago 1975
    Consegnato il 04 set 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Standard security presented for registration at the registar of sasines on the 29TH august 1975 and created by rank city wall limited for the purpose of securing debenture stock of the company amounting to £14,000,000 secured by a trust deed dated 1TH may 73 and deeds supplemental
    Brevi particolari
    The subjects described in a disposition by the trustees of for charles barrie in favour of united cinemas LTD dated 14TH and 16TH nov 35 & known as 1/5 paterson st & 126/128 strathmartine rd dundee.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 04 set 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 29 ago 1975
    Consegnato il 29 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 29 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 mar 1975
    Consegnato il 21 apr 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £12,350.000 debenture stock of the company secured by a trust deed dated 18TH may 1973 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Heritable subjects in the city of edinburgh extending to 6.545 acres as described in disposition by rank city wall overseas limited, to the company together with office clock thereon known as trinity park house, south trinity road, but excepting therefrom area of ground described therein extending 3886 metres west 34.138 metres on south, 29.261 metres on east and 24,544 metres on north.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD.,
    Transazioni
    • 21 apr 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 02 gen 1975
    Consegnato il 14 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co. LTD.
    Transazioni
    • 14 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 02 gen 1974
    Consegnato il 18 gen 1974
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 18 gen 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental trust deed
    Creato il 31 ott 1973
    Acquisito il 31 ott 1974
    Consegnato il 21 nov 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Debenture stock of the company amounting to £10,000,000 secured on property acquired by that company on the 31/10/74
    Brevi particolari
    The gloucester, harrington gardens, kensington, london.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co. LTD
    Transazioni
    • 21 nov 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 08 mag 1973
    Acquisito il 31 ott 1973
    Consegnato il 12 nov 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A debenture stock amounting to £5,000.000 outstanding and secured on property acquired by the company on the 31ST oct 1973
    Brevi particolari
    F/H property known as as klingfield house portsmouth.(note this property was replaced under the terms of a deed of release dated 11TH june 1976 by property at east kilbride shopping centre).
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 12 nov 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 01 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 ago 1966
    Acquisito il 29 ott 1973
    Consegnato il 15 nov 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 164,550
    Brevi particolari
    F/H part of the site birmingham garages navigation street and in site of 101 to 107 (odd) john bright street l/h part ofthe site of birmingham garages navigation street john parish.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Life Assurance Companys Limited
    Transazioni
    • 15 nov 1973Registrazione di un'ipoteca
    Disposition presented for registration in register of sasines on 15TH july 1949
    Creato il 10 mag 1949
    Consegnato il 18 lug 1949
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £1,000,000 debenture stock and a premium of 1% in certain events secured by trust deeds dated 1/1/47 and 30/11/48
    Brevi particolari
    Rutland square picture house, edinburgh, the goodwill of the business carried on therein, the whole plant, machinery, furniture, fixtures, fittings & effects present & future and all war damage claims.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 18 lug 1949Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Disposition
    Creato il 20 gen 1948
    Consegnato il 11 feb 1948
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 deb. Stock & a premium of 1% in certain events secured by a trust deed dated 1 jan 1947.
    Brevi particolari
    St. Andrew square picture house, clyde street, edinburgh & the whole fixtures, furnishings, fittings & equipment therein contained.
    Persone aventi diritto
    • Law Debenture Corporation LTD.
    Transazioni
    • 11 feb 1948Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 31 mar 1942
    Consegnato il 08 apr 1942
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further security for £450,000 secured debenture stock secured by trust deed dated 4/2/36
    Brevi particolari
    Gaumont cinema, holloway road, tufnell park together with all buildings fixtures fixed plant & machinery thereon. And all rights powers and easements appurtenant thereto.
    Persone aventi diritto
    • Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 08 apr 1942Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental trust deed
    Creato il 04 mar 1942
    Consegnato il 17 mar 1942
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further security for £2,250,000 debenture stock secured by trust deed dated 16/10/38
    Brevi particolari
    Gaumont cinema, holloway road, tufnell park together with all buildings fixtures fixed plant & machinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 17 mar 1942Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed supplemental to trust deed dated 16/10/28
    Creato il 15 ago 1938
    Consegnato il 24 ago 1938
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £2,250,000 first mortgage debenture stock and premium of 3%
    Brevi particolari
    Certain holdings of subsidiary companies in haymarket capit LTD.
    Persone aventi diritto
    • Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 24 ago 1938Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 dic 2016Inizio della liquidazione
    07 set 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alan John Roberts
    Kensington Chambers 46-50 Kensington Place
    St Helier
    JE1 1ET Jersey
    Channel Isles
    Praticante
    Kensington Chambers 46-50 Kensington Place
    St Helier
    JE1 1ET Jersey
    Channel Isles
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0