CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00228008 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
RANK CITY WALL LIMITED | 11 feb 1928 | 11 feb 1928 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 dic 2018 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 dic 2017 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor, 30 Market Place London W1W 8AP England a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 27 nov 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Market Place London W1W 8AP England a 4th Floor, 30 Market Place London W1W 8AP in data 05 set 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Noe Group (Corporate Services) Limited come amministratore in data 30 ago 2017 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Market Place London W1W 8AP England a 30 Market Place London W1W 8AP in data 30 ago 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Finsbury Square London EC2P 2YU a 30 Market Place London W1W 8AP in data 30 ago 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di F&C Reit (Corporate Services) Limited come segretario in data 08 ago 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di F&C Reit (Corporate Services) Limited come amministratore in data 08 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 02 mag 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5 Wigmore Street London W1U 1PB a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 20 gen 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 set 2015 al 28 set 2015 | 2 pagine | AA01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 11 lug 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2015 al 29 set 2015 | 2 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEADS, Paul Graham | Amministratore | Rockdene Close RH19 3HA East Grinstead 15 West Sussex United Kingdom | England | British | Solicitor | 168880940001 | ||||||||
NOE GROUP (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Amministratore | Market Place W1W 8AP London 30 England |
| 235013180001 | ||||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Segretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Segretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Segretario | Wigmore Street W1U 1PB London 5 |
| 147824490001 | ||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||||||
BERRY, David Charles | Amministratore | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
GUNSTON, Michael Ian | Amministratore | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3079890002 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
KALMAN, Stephen Lionel | Amministratore | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||||||
METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman And Managing Director | 41694870001 | ||||||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 | ||||||||
ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||||||
VANDEVIVERE, Jean-Marc | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 170947050001 | ||||||||
WEBB, Nigel Mark | Amministratore | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 58059360001 | ||||||||
WESTON SMITH, John Harry | Amministratore | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||||||
F&C REIT (CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Amministratore | Wigmore Street W1U 1PB London 5 United Kingdom |
| 183276050001 | ||||||||||
F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Amministratore | Wigmore Street W1U 1PB London 5 United Kingdom |
| 147824490001 |
CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 18 nov 2013 Consegnato il 30 nov 2013 | In corso | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation in security | Creato il 05 ago 1997 Consegnato il 06 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations monies and liabilities due or to become due from the obligants (as defined) to the chargee as trustee under the trust deed | |
Brevi particolari All and whole the tenants interest under an agreement and lease among east kilbride development corporation city wall properties (scotland) limited and city wall properties limited of the subjects known and forming part of the plaza centre east kilbride and all the company's whole right and title under the trust agreement for full details of all charged assets please refer to form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland | Creato il 01 nov 1996 Consegnato il 07 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the various documents (as defined therein) | |
Brevi particolari All and whole the tenant's interest under an agreement and lease entered into between east kilbride development corporation, city wall properties (scotland) limited and city wall properties limited of subjects k/a and forming the plaza centre, east kilbride lying in the county of lanark.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed | Creato il 31 ott 1996 Consegnato il 06 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal amount of and interest due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the trust deed dated 14/9/81 the first mortgage debenture stock 2019/24 and this deed | |
Brevi particolari £3,140,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 29 apr 1993 Consegnato il 13 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000,000 9 3/8 per cent. First mortgage debenture stock 2028 of the british land company PLC (the "parent") and all other moneys due from the parent to royal exchange trust company limited and all other persons or companies acting under the trust deed and any other deeds supplemental thereto as trustees, subject to a maximum of £1,000,000,000 | |
Brevi particolari F/Hold land/blds at bain clarkson house,harlands rd,yaywards heath,west sussex;t/no.wsx 15114; all fixtures,fittings,fixed plant/machinery....etc. See form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of substitution and charge. | Creato il 16 nov 1987 Consegnato il 20 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 5,000,000 due or to become due from the company and/or city wall properties limited and or merbridge properties limited to the chargee under the terms of the principal deeds | |
Brevi particolari City wall house, eastrop basingstoke title no hp 108348 part title no hp 110271 (see doc M103/23 nuu/44). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 10 mar 1987 Consegnato il 13 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the british land company PLC to the chargeenot exceeding sterling pounds 10,000,000 | |
Brevi particolari Easterhouse township centre, waterhouse road, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of release and substitution | Creato il 15 feb 1978 Consegnato il 17 feb 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Debenture stock amounting to sterling pounds 4,625,000 | |
Brevi particolari The freehold property known as brunel house the yard portsmouth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of release effecting substitution of security | Creato il 10 giu 1976 Consegnato il 23 giu 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 secured by a trust deed dated 8/5/73 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari East kilbride shopping centre east kilbride, lanarkshire, scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security presented for registration at the register of sasines on the 11/6/76 | Creato il 10 giu 1976 Consegnato il 23 giu 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 secured by a trust deed dated 8/5/73 and deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari East kilbride shopping centre east kilbride, lanarkshire, scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
15,000,000 inclusive of £14,000,000 secured by a trust deed doc 8/5/734 deeds supplemental | Creato il 31 dic 1975 Consegnato il 08 gen 1976 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 31 dic 1975 Consegnato il 05 gen 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 | |
Brevi particolari Headlease intended to be granted to the company pursuant to the provisions of an agreement act 7/8/1969. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 29 ago 1975 Consegnato il 04 set 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Standard security presented for registration at the registar of sasines on the 29TH august 1975 and created by rank city wall limited for the purpose of securing debenture stock of the company amounting to £14,000,000 secured by a trust deed dated 1TH may 73 and deeds supplemental | |
Brevi particolari The subjects described in a disposition by the trustees of for charles barrie in favour of united cinemas LTD dated 14TH and 16TH nov 35 & known as 1/5 paterson st & 126/128 strathmartine rd dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Series of debentures | Creato il 29 ago 1975 Consegnato il 29 ago 1975 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 24 mar 1975 Consegnato il 21 apr 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing £12,350.000 debenture stock of the company secured by a trust deed dated 18TH may 1973 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari Heritable subjects in the city of edinburgh extending to 6.545 acres as described in disposition by rank city wall overseas limited, to the company together with office clock thereon known as trinity park house, south trinity road, but excepting therefrom area of ground described therein extending 3886 metres west 34.138 metres on south, 29.261 metres on east and 24,544 metres on north. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Series of debentures | Creato il 02 gen 1975 Consegnato il 14 gen 1975 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Series of debentures | Creato il 02 gen 1974 Consegnato il 18 gen 1974 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 31 ott 1973 Acquisito il 31 ott 1974 Consegnato il 21 nov 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Debenture stock of the company amounting to £10,000,000 secured on property acquired by that company on the 31/10/74 | |
Brevi particolari The gloucester, harrington gardens, kensington, london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 08 mag 1973 Acquisito il 31 ott 1973 Consegnato il 12 nov 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito A debenture stock amounting to £5,000.000 outstanding and secured on property acquired by the company on the 31ST oct 1973 | |
Brevi particolari F/H property known as as klingfield house portsmouth.(note this property was replaced under the terms of a deed of release dated 11TH june 1976 by property at east kilbride shopping centre). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 18 ago 1966 Acquisito il 29 ott 1973 Consegnato il 15 nov 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 164,550 | |
Brevi particolari F/H part of the site birmingham garages navigation street and in site of 101 to 107 (odd) john bright street l/h part ofthe site of birmingham garages navigation street john parish. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Disposition presented for registration in register of sasines on 15TH july 1949 | Creato il 10 mag 1949 Consegnato il 18 lug 1949 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing £1,000,000 debenture stock and a premium of 1% in certain events secured by trust deeds dated 1/1/47 and 30/11/48 | |
Brevi particolari Rutland square picture house, edinburgh, the goodwill of the business carried on therein, the whole plant, machinery, furniture, fixtures, fittings & effects present & future and all war damage claims. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Disposition | Creato il 20 gen 1948 Consegnato il 11 feb 1948 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000 deb. Stock & a premium of 1% in certain events secured by a trust deed dated 1 jan 1947. | |
Brevi particolari St. Andrew square picture house, clyde street, edinburgh & the whole fixtures, furnishings, fittings & equipment therein contained. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 31 mar 1942 Consegnato il 08 apr 1942 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further security for £450,000 secured debenture stock secured by trust deed dated 4/2/36 | |
Brevi particolari Gaumont cinema, holloway road, tufnell park together with all buildings fixtures fixed plant & machinery thereon. And all rights powers and easements appurtenant thereto. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 04 mar 1942 Consegnato il 17 mar 1942 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further security for £2,250,000 debenture stock secured by trust deed dated 16/10/38 | |
Brevi particolari Gaumont cinema, holloway road, tufnell park together with all buildings fixtures fixed plant & machinery thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed supplemental to trust deed dated 16/10/28 | Creato il 15 ago 1938 Consegnato il 24 ago 1938 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing £2,250,000 first mortgage debenture stock and premium of 3% | |
Brevi particolari Certain holdings of subsidiary companies in haymarket capit LTD. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0