00230111 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società00230111 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00230111
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 00230111 LIMITED?

    • (6110) /

    Dove si trova 00230111 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bulman House Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 00230111 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POWELL DUFFRYN SHIPPING LIMITED 31 ott 198631 ott 1986
    STEPHENSON CLARKE (SHIPPING) LIMITED30 apr 192830 apr 1928

    Quali sono gli ultimi bilanci di 00230111 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 00230111 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma04 lug 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 00230111 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 00230111 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagineREST-CVL

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed stephenson clarke shipping\certificate issued on 21/05/20
    pagineCERTNM

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 ago 2013

    23 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    9 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Eldon Court Percy Street Newcastle upon Tyne NE99 1TD* in data 01 ago 2012

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di 00230111 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMPBELL, Russell Kenneth
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    Segretario
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    British26948290004
    CAMPBELL, Russell Kenneth
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish26948290004
    GILMOUR, Barry Edward Kerr
    Heatherlands House
    East Road
    NE65 8FY Longhorsley
    Northumberland
    Amministratore
    Heatherlands House
    East Road
    NE65 8FY Longhorsley
    Northumberland
    United KingdomBritish20361920009
    PLANT, William Allan
    1 Barnard Court
    Woodstone Village
    DH4 6TS Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Barnard Court
    Woodstone Village
    DH4 6TS Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish87465680003
    CHRISTIAN, Kevin
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Segretario
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    British54761610001
    MAHONY, Peter John
    8 Harlesden Road
    Harold Hill
    RM3 9HT Romford
    Essex
    Segretario
    8 Harlesden Road
    Harold Hill
    RM3 9HT Romford
    Essex
    British31909050001
    ANDREWS, William George
    Two Acres Cottage Middleton Road
    GU15 3TT Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Two Acres Cottage Middleton Road
    GU15 3TT Camberley
    Surrey
    British58542770001
    CHRISTIAN, Kevin
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Amministratore
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish54761610001
    KINGSLEY-SMITH, Trevor
    Dyke Row Cottage
    Newbrough
    NE47 5BE Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Dyke Row Cottage
    Newbrough
    NE47 5BE Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish68419630005
    MCLEAN, Robert Urquhart
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British29101050002
    MCLEAN, Robert Urquhart
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British29101050002
    PEACOCK, Gary Joseph
    1 Kiln Rise
    Whickham
    NE16 5QN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Kiln Rise
    Whickham
    NE16 5QN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish163677680001
    PEILE, Charles Henry Whitaker
    The Old Rectory
    Simonburn
    NE48 3AR Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    The Old Rectory
    Simonburn
    NE48 3AR Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish103171190001
    POWELL, Michael John Alexander
    Pondfield
    376 Sandhurst Lane
    TN25 4PF Ashford
    Kent
    Amministratore
    Pondfield
    376 Sandhurst Lane
    TN25 4PF Ashford
    Kent
    British25791770002
    SHUTTLEWORTH, David Andrew
    158 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    158 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British67100520005
    WALKER, Geoffrey
    Ivy House 11 King Street
    PO10 7AX Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    Ivy House 11 King Street
    PO10 7AX Emsworth
    Hampshire
    British918890001
    WATKINS, David Tyrrell
    Redheugh
    Tarset
    NE48 1NB Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Redheugh
    Tarset
    NE48 1NB Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish15566730001

    00230111 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 25 nov 2011
    Consegnato il 30 nov 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 30 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Second priority statutory ship mortgage
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 10 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    M.V.newcastle official no 9091931 and her boats and appurtenances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second priority statutory ship mortgage
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    100% shares in the vessel M.V. durrington official number 390778 and her boats and appurtenances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second priority statutory ship mortgage
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    100% shares in the vessel M.V. storrington official number 399033 and her boats and appurtenances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A second deed of assignment
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. newcastle official number 9191931 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A second deed of assignment
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. durrington official number 390778 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A second deed of assignment
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. storrington official number 399033 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A second deed of covenants
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. storrington official number 399033 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A second deed of covenants
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. durrington official number 390778 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A second deed of covenants
    Creato il 25 lug 2011
    Consegnato il 05 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. newcastle official number 9191931 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of covenants
    Creato il 09 giu 2008
    Consegnato il 21 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assign the earnings, insurances and requisition compensation see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First priority statutory ship mortgage
    Creato il 09 giu 2008
    Consegnato il 21 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgagor assigns the mortgage over 100% of the shares of the vessel being mv newcastle ex mv sandy official no. 9191931 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment
    Creato il 09 giu 2008
    Consegnato il 21 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The earnings insurances and requisition compensation see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Statutory mortgage
    Creato il 05 ago 2005
    Consegnato il 19 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    64/64THS shares of and in M.V. kielder registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 737083.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 05 ago 2005
    Consegnato il 19 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged property being the ship, the earnings and the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.birling registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 377461.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.durrington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 390778.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.v sea amethyst registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 722397.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.donnington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 365896.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.dallington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 365968.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 02 apr 2009
    • 27 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.steyning registerd in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 705450.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.harting registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 390920.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.emerald registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 377571.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Statutory mortgage
    Creato il 15 set 1997
    Consegnato il 30 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.storrington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 399033.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment
    Creato il 13 set 1997
    Consegnato il 03 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    The ship (as defined) as it is constructed; the shipbuilding contract (as defined) including the right to take delivery of the ship and the refund guarantees (as defined) including all sums at any time payable to the company pursuant to or as damages or agreed compensation for breach of, or by way of payment in respect of any termination or amendment or any of them. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    00230111 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 ago 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan David Kelly
    Tenon House Ferryboat Lane
    SR5 3JN Sunderland
    Tyne And Wear
    Praticante
    Tenon House Ferryboat Lane
    SR5 3JN Sunderland
    Tyne And Wear
    Gordon Smythe Goldie
    Tait Walker
    Bulman House
    NE3 3LS Regent Centre, Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Tait Walker
    Bulman House
    NE3 3LS Regent Centre, Gosforth
    Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0