EUROPA PUBLICATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EUROPA PUBLICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00230964 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EUROPA PUBLICATIONS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EUROPA PUBLICATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di EUROPA PUBLICATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per EUROPA PUBLICATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Emily Louise Martin il 03 ago 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 28 giu 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rupert John Joseph Hopley il 01 mar 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Rupert John Joseph Hopley come amministratore in data 01 nov 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Elizabeth Jacobs come amministratore in data 16 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John William Burton come amministratore in data 31 ago 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Richard Wright il 19 ago 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Roger Graham Horton il 11 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Emily Louise Martin come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Kerswell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 27 set 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Adam Christopher Walker il 05 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Stephen Rigby il 05 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Scissione delle azioni al 02 set 2010 | 5 pagine | SH02 | ||||||||||
Scissione delle azioni al 02 set 2010 | 5 pagine | SH02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EUROPA PUBLICATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Emily Louise | Segretario | 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House United Kingdom | 160502330001 | |||||||
| WOOLLARD, Julie Louise | Segretario | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | British | 139159370002 | ||||||
| HOPLEY, Rupert John Joseph | Amministratore | 6300 Zug Gubelstrasse 11 Switzerland | Switzerland | British | 164632060002 | |||||
| HORTON, Roger Graham | Amministratore | Mill Lane Shiplake RG9 3LY Henley-On-Thames Rivermead Oxfordshire United Kingdom | England | British | 56485660003 | |||||
| RIGBY, Peter Stephen | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 69164290007 | |||||
| WALKER, Adam Christopher | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 129368430002 | |||||
| WRIGHT, Gareth Richard | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 131115190002 | |||||
| CALLABY, Andrea Mary | Segretario | 5 Thornton Drive CO4 5WB Colchester Essex | British | 70352690002 | ||||||
| FOYE, Anthony Martin | Segretario | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | British | 99515780001 | ||||||
| HICKFORD, Colin James | Segretario | 23 Thornash Close Horsell GU21 4UP Woking Surrey | British | 27692940001 | ||||||
| MILTON, Michael Robin | Segretario | Tudor Court Finch Lane Knotty Green HP9 2TL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 9149150001 | ||||||
| RICHMOND, Sonia Anna | Segretario | 8 Viscount Gardens KT14 6HE Byfleet Surrey | British | 118535490002 | ||||||
| THOMASSON, Jeffrey Scott | Segretario | 24 Webster Road SE16 4DF London | American | 64473410003 | ||||||
| BURTON, John William | Amministratore | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London | United Kingdom | British | 113684810001 | |||||
| CONIBEAR, Jonathan James Garnham | Amministratore | The Grange Mill Street OX5 2SY Islip Oxon | United Kingdom | British | 258970950001 | |||||
| DESMOND, James Philip | Amministratore | 11 Grasmere Road N10 2DH London | England | British | 73339390001 | |||||
| FOYE, Anthony Martin | Amministratore | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | United Kingdom | British | 99515780001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Amministratore | Casa Maria Spaniard's End Hampstead NW3 7JG London | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| HUGHES, Rodney Martin | Amministratore | 8 Kerdistone Close Little Heath EN6 1LG Potters Bar Hertfordshire | British | 27669690001 | ||||||
| HUTTON, Jeremy John | Amministratore | Stagden Cross House High Easter CM1 4QY Chelmsford Essex | British | 50613140001 | ||||||
| JACKSON, Peter George Clark | Amministratore | 44 West Drive Cheam SM2 7NA Sutton Surrey | British | 27669700001 | ||||||
| JACOBS, Rachel Elizabeth | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | United Kingdom | British | 92334500004 | |||||
| KELLY, Paul Francis | Amministratore | 59 Argyle Gardens RM14 3HH Upminster Essex | British | 57049650001 | ||||||
| KERSWELL, Mark Henry | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 82609620003 | |||||
| MARTIN, Clive Haydn, Sir | Amministratore | Weatherbury 16 Heath Road EN6 1LN Potters Bar Hertfordshire | England | British | 7690350001 | |||||
| MCGINLEY, Patrick Anthony | Amministratore | 6 Hazelmere Road Petts Wood BR5 1PB Orpington Kent | British | 27669710001 | ||||||
| MILTON, Michael Robin | Amministratore | The Hollies Soldridge Road Medstead GU34 5JF Alton Hampshire | British | 9149150002 | ||||||
| NEAL, Stephen Bryan | Amministratore | 5 Acer Avenue TN2 5JQ Tunbridge Wells Kent | British | 23978960001 | ||||||
| OLIVER, Alan Geoffrey | Amministratore | 23 Beresford Road Chingford E4 6ED London | British | 27669720001 | ||||||
| QUINNEY, John | Amministratore | Button Hide Seven Hills Road KT11 1ER Cobham Surrey | British | 9149160001 | ||||||
| R, Peter | Amministratore | Appledown House The Croft GL7 4BB Fairford Gloucestershire | British | 125327660001 | ||||||
| SELVEY, Anthony Rochford | Amministratore | 14 Monterey Close DA5 2BX Bexley Kent | British | 6037980001 | ||||||
| SMITH, David John | Amministratore | 10 South Close RG40 2DJ Wokingham Berkshire | England | British | 81852060001 | |||||
| THOMASSON, Jeffrey Scott | Amministratore | 24 Webster Road SE16 4DF London | England | American | 64473410003 |
EUROPA PUBLICATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 08 mag 1987 Consegnato il 14 mag 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 26 feb 1986 Consegnato il 04 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all other monies due to citibank na. Under the terms of a composite guarantee and debenture dated 30.9.85. | |
Brevi particolari (Please see doc M120). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0