BOXES HOLDINGS LIMITED

BOXES HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBOXES HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00233208
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BOXES HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BOXES HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Severn Paper Mill
    Harbour Road Trading Estate
    BS20 7DJ Portishead
    Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BOXES HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOXES PLC30 ago 199430 ago 1994
    BOXES HOLDINGS LIMITED27 lug 198727 lug 1987
    BOXES LIMITED08 set 192808 set 1928

    Quali sono gli ultimi bilanci di BOXES HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BOXES HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A1N4V3OH

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ott 2012

    Stato del capitale al 11 ott 2012

    • Capitale: GBP 324,053
    SH01
    X1JBUP7S

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA
    A1IEOBUQ

    Cessazione della carica di Patrick Gerard Mullaney come amministratore in data 31 ago 2012

    1 pagineTM01
    X1GO90P4

    Cessazione della carica di John Joseph Fitzgerald come amministratore in data 31 ago 2012

    1 pagineTM01
    X1GO90FD

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    X67TRYRJ

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA
    AY7VUXYZ

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    X7V0SPXD

    Dettagli del direttore cambiati per Patrick Gerard Mullaney il 27 set 2010

    2 pagineCH01
    X7V0RPXC

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA
    AYOHOO0P

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA
    A2SQCFEZ

    Bilancio annuale redatto al 27 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XMWADE5L

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    10 pagineAA
    ARADD4EJ

    legacy

    5 pagine363a
    XXE993TM

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    10 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    25 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    13 pagine155(6)b

    legacy

    13 pagine155(6)b

    Chi sono gli amministratori di BOXES HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NICHOLLS, James Andrew
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    Segretario
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    BritishAccountant74242880001
    NICHOLLS, James Andrew
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    Amministratore
    15 The Quays
    Cumberland Road
    BS1 6UQ Bristol
    EnglandBritishAccountant74242880001
    O'NEILL, Colman
    110 Shrewsbury Lawn
    Cabinteely
    18 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    110 Shrewsbury Lawn
    Cabinteely
    18 Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector & Group Controller45448600001
    BERGIN, Liam Gerard
    17 Chesterfield View
    Castlenock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Segretario
    17 Chesterfield View
    Castlenock
    IRISH Dublin 15
    Ireland
    Irish36702870001
    HATTER, David
    25 Long Down
    GU31 4PD Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    25 Long Down
    GU31 4PD Petersfield
    Hampshire
    British39383120001
    HERCULIS, Nicholas
    141 Wades Hill
    N21 1EQ London
    Segretario
    141 Wades Hill
    N21 1EQ London
    British8053050001
    MACKEY, Wallace John Chalmers
    Riverdell
    29 Admiral Way
    HP4 1TE Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    Riverdell
    29 Admiral Way
    HP4 1TE Berkhamsted
    Hertfordshire
    New ZealandChartered Accountant44545310001
    BARHAM, Robert James
    15 Sherwood Place
    RG8 8RZ Purley On Thames
    Berkshire
    Amministratore
    15 Sherwood Place
    RG8 8RZ Purley On Thames
    Berkshire
    BritishSales Director90879040001
    CARMICHAEL, James
    The Old Stable Yard
    Peveril Road
    LE17 5NQ Ashby Magna
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Stable Yard
    Peveril Road
    LE17 5NQ Ashby Magna
    Leicestershire
    BritishDirector88088510001
    FITZGERALD, John Joseph
    33 Bracken Hey
    BB7 1LW Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    33 Bracken Hey
    BB7 1LW Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomIrishExecutive94760710001
    GARFIELD, Philip Jacob
    6 Mannor Hall Avenue
    NW4 1NX London
    Amministratore
    6 Mannor Hall Avenue
    NW4 1NX London
    BritishCompany Director22947870001
    GEE, Derek David
    7 West Heath Close
    Platts Lane
    NW3 7NJ Hampstead
    London
    Amministratore
    7 West Heath Close
    Platts Lane
    NW3 7NJ Hampstead
    London
    BritishCompany Director32385580001
    HATTER, David
    25 Long Down
    GU31 4PD Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    25 Long Down
    GU31 4PD Petersfield
    Hampshire
    BritishFinance Director39383120001
    JERMAN, Allen James Crawford
    14 Hartopp Road
    Fouroaks
    B74 2RQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    14 Hartopp Road
    Fouroaks
    B74 2RQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive154902080001
    LUND, Henry
    325 Chestnut Street Suite 909
    Philadelphia Pa
    19106 Usa
    Amministratore
    325 Chestnut Street Suite 909
    Philadelphia Pa
    19106 Usa
    IrishDirector45449190001
    MACKEY, Wallace John Chalmers
    Riverdell
    29 Admiral Way
    HP4 1TE Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Riverdell
    29 Admiral Way
    HP4 1TE Berkhamsted
    Hertfordshire
    New ZealandChartered Accountant44545310001
    MCDERMOTT, Norbert
    2002 Lantern Lane
    Oreland 19097
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    2002 Lantern Lane
    Oreland 19097
    Pennsylvania
    Usa
    IrishChief Executive59125180001
    MULLANEY, Patrick Gerard
    142 Graham Road
    Ranmoor
    S10 3DR Sheffield
    Amministratore
    142 Graham Road
    Ranmoor
    S10 3DR Sheffield
    EnglandIrishGeneral Manager191035430001
    STEELE, Paul Thomas
    Catalan Lodge Ballam Road
    Westby Wrea Green
    PR4 3PN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Catalan Lodge Ballam Road
    Westby Wrea Green
    PR4 3PN Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director2825250001
    TANYAR, Feyzoullah Yalkin
    Homewood House
    The Ridgeway
    EN6 4AX Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Homewood House
    The Ridgeway
    EN6 4AX Cuffley
    Hertfordshire
    BritishCompany Director33720300001
    VON GREYERZ, Egon
    The Oaks
    Letty Green
    SG14 2NZ Hertford
    Amministratore
    The Oaks
    Letty Green
    SG14 2NZ Hertford
    SwissCompany Director71638600001

    BOXES HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 12 lug 2007
    Consegnato il 30 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 30 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 29 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other obligor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all of the real property, by way of first fixed charge all estates or interests in any real property, all plant and machinery equipment computers vehicles and other chattels, all of the charged deposits, all investments and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C. (The Security Agent) for Itself and on Behalf of the Securedcreditors
    Transazioni
    • 29 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second stage debenture
    Creato il 23 nov 1999
    Consegnato il 07 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due on any account whatsoever from the company to secured parties (or any of them) wheter collectively or individually under the finance doucments (or any of them) and under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 set 1995
    Consegnato il 20 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 dic 1987
    Consegnato il 23 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 mag 1987
    Consegnato il 22 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    41 dace road l/b of tower hamlets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 feb 1987
    Consegnato il 16 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 mar 1984
    Consegnato il 16 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 lug 1975
    Consegnato il 04 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. (See doc 100 for details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Inst of charge
    Creato il 08 ago 1958
    Consegnato il 21 ago 1958
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    51 & 53, dace rd, bow, london. Title no. 65444 (see doc 55 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1958Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Instrument of charge under land regn: act 1925.
    Creato il 13 nov 1946
    Consegnato il 26 nov 1946
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    41, dace road, old ford, london. Title no. 147475.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1946Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Instrument of charge as confirmed & notified by a resolution passed at a meeting of the members of boxes limited on 15TH nov 1949.
    Creato il 13 nov 1946
    Consegnato il 23 nov 1946
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    41 dace road, old ford, london. Title no. 147475.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1946Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0