CHAS.ROSE & CO.LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHAS.ROSE & CO.LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00235418 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 17 gen 2020
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 79 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 002354180010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 19 ago 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE in data 08 set 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Punch Taverns (Rh) Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francesca Appleby come segretario in data 29 ago 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Amministratore | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627400001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Segretario | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175487970001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161623700001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Amministratore | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| CONSTANTINE, Peter Anthony | Amministratore | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 114160540001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FORDE, David | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| JONES, Bruce Abbott | Amministratore | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | 29595900002 | ||||||
| KEMP, Deborah Jane | Amministratore | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| TANNAHILL, David James | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 | |||||
| WHITEHEAD, Gordon William George | Amministratore | Rosedale 24 Jacks Lane ST14 8LW Marchington Staffordshire | British | 13507460001 | ||||||
| WILFORD, Nicholas James | Amministratore | The Virgate Church Street Swepstone Coalville LE6 7SA Leicester Leicestershire | British | 33328990001 | ||||||
| WILKINSON, Anthony Eric | Amministratore | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | 4656080002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29 ago 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Punch Taverns (Rh) Limited | 06 apr 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CHAS.ROSE & CO.LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 08 ott 2014 Consegnato il 15 ott 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Third supplemental deed of charge | Creato il 03 nov 2003 Consegnato il 20 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 08 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in to and under the f/h or l/h property comprising in the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; and all estates or interests in such property and allbuildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 08 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 28 giu 2000 Consegnato il 15 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Brevi particolari All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 05 ott 1999 Consegnato il 21 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to any transaction party under each transaction document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage the property defined as abbots way south drive sothway plymouth devon, alsager arms 4 sandbach rd south alsager stoke-on-trent staffs, anchor high st little paxton st neots huntingdon cambs (for full list of all property charged see schedule to form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 mag 1942 Consegnato il 13 mag 1942 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3000 | |
Brevi particolari Central hotel castle road scarborough. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge (supplemental to legal charge dated 7TH jany 1929 for securing all moneys due etc to barclays bank LTD) | Creato il 26 mar 1941 Consegnato il 06 apr 1941 | Soddisfatta integralmente | ||
Brevi particolari Land and the tennyson arms dean road scarborough yorks. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 07 gen 1929 Consegnato il 12 gen 1929 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys etc. | |
Brevi particolari Brewery and premises in castlegate malton york the nags head inn and no 28 oxford st scarborough the borough arms and 11 union st and 23 and 24 bedford st scarborough the black swan inn no 25 queen st scarborough. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 24 dic 1928 Consegnato il 04 gen 1929 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2100 | |
Brevi particolari Inn hotel & premises in wheelgate malton york golden lion inn premises 3 cottages lana in great borugh york. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0