REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00237095
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DCS GROUP LIMITED23 ago 200623 ago 2006
    NESCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED COMPANY31 dic 197831 dic 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    6 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    legacy

    6 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduction in additional paid in capital 14/12/2014
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2014

    Stato del capitale al 15 gen 2014

    • Capitale: GBP 8,650,757
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Carlan Cooper come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Terry Wallace Jones come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Norman Tommy Barras come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Dan Steven Agan come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Robert Theron Brockman come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Robert Maxey Nalley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Moss come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Segretario
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    American121496770001
    AGAN, Dan Steven
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053880001
    BARRAS, Norman Tommy
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053860001
    BROCKMAN, Robert Theron
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican158497330001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121495910001
    COOPER, Carlan Max
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    UsaUnited States136536270001
    JONES, Terry Wallace
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053830001
    NALLEY, Robert Maxey
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    Amministratore
    1200 Bristol Road South,
    Northfield, Birmingham
    B31 2RW West Midlands
    United StatesAmerican84053700001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BYGRAVE, Susan Jane
    2 The Mill
    Hertingfordbury
    SG14 2SB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario
    2 The Mill
    Hertingfordbury
    SG14 2SB Hertford
    Hertfordshire
    British114989650001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Segretario
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Segretario
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    AMIES, Colin Macdonald
    Manor House
    Docking
    PE31 8WA Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    Manor House
    Docking
    PE31 8WA Kings Lynn
    Norfolk
    United KingdomBritish35493030002
    ARROWSMITH, Robert George
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    Amministratore
    8 Brendon Drive
    KT10 9EQ Esher
    United KingdomBritish70780350004
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Amministratore
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    United KingdomBritish89866330001
    COCKBURN, Stephen John
    Marshalls Manor
    Cuckfield
    RH17 5EL Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Marshalls Manor
    Cuckfield
    RH17 5EL Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish59813890001
    CONVEY, Sean
    Ford House Castle Road
    CV8 1NG Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Ford House Castle Road
    CV8 1NG Kenilworth
    Warwickshire
    Irish12327180001
    DE KRETSER, Christopher Robin
    Nesco House
    Jos Road
    Bukuru
    Plateau State
    Nigeria
    Amministratore
    Nesco House
    Jos Road
    Bukuru
    Plateau State
    Nigeria
    NigeriaBritish37395790001
    FORSYTH, Andrew James
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Well House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5NG Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish64591610001
    GESWEIN, Gregory Thomas
    3625 Wood Hollow
    Dayton
    Ohio 45429
    Usa
    Amministratore
    3625 Wood Hollow
    Dayton
    Ohio 45429
    Usa
    American114993100001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    British94654870001
    GUJRAL, Ben
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Churchfield Lodge
    Churchfield Path
    EN8 9EG Cheshunt
    Hertfordshire
    British94654870001
    LEES, Jonathan Charles
    Longbrook House
    Church Road
    SL4 4SE Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Longbrook House
    Church Road
    SL4 4SE Windsor
    Berkshire
    British97165530001
    LODGE, Robin Wilfred Ian
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    Amministratore
    6 Chemin Du Vieux Motty
    Yens
    1169
    Switzerland
    SwitzerlandBritish154369990002
    MINER, Selcan
    24 Naraguta Avenue
    Jos
    Plateau State
    Nigeria
    Amministratore
    24 Naraguta Avenue
    Jos
    Plateau State
    Nigeria
    NigeriaNigerian39753930001
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Amministratore
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121496770001
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish10307790002
    ROBINSON, Timothy Michael
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Wells Farmhouse
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    EnglandBritish154155330001
    SAVAGE, John Richard
    Primrose Bank Brooks Lane
    Bosley
    SK11 0PU Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Primrose Bank Brooks Lane
    Bosley
    SK11 0PU Macclesfield
    Cheshire
    British61675390001
    SKETCHLEY, Mark
    Flat 2
    17 Sheffield Terrace
    W8 7NQ London
    Amministratore
    Flat 2
    17 Sheffield Terrace
    W8 7NQ London
    British11596370001
    SPENCE, Raymond Leslie
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    British46677090001
    SUTTON, Michael Alan
    25a Westbourne Road
    Birkdale
    PR8 2HZ Southport
    Merseyside
    Amministratore
    25a Westbourne Road
    Birkdale
    PR8 2HZ Southport
    Merseyside
    British7436190002
    VENTURA, Douglas Michael
    3840 Winning Stakes Way
    Mason
    Ohio 45040
    Usa
    Amministratore
    3840 Winning Stakes Way
    Mason
    Ohio 45040
    Usa
    American111985510001
    WILLIAMS, Robert George
    Daneport Lodge
    30 Church Lane
    HG3 1NQ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Daneport Lodge
    30 Church Lane
    HG3 1NQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish95071890001

    REYNOLDS & REYNOLDS AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 mar 2004
    Consegnato il 01 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares and all related rights all rights in respect of any amount standing to the credit of the account and the debt represented by it all rights in respect of the dcs loan agreement and the call option agreement the right to nay receivables floating charge all assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 12 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 giu 2000
    Consegnato il 13 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 ago 1997
    Consegnato il 03 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over deposit
    Creato il 21 mag 1996
    Consegnato il 29 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of acct/no 01438579 and all rights,interest and benefits thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 04 lug 1995
    Consegnato il 14 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank of scotland treasury services PLC.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0