ERON INVESTMENTS LIMITED

ERON INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàERON INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00237658
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ERON INVESTMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova ERON INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ERON INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ERON INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Louise Miller come amministratore in data 01 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Elizabeth Miles come amministratore in data 01 gen 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Arnaouti come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Louise Miller come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Arnaouti il 16 gen 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ls Company Secretaries Limited il 10 gen 2017

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Ls Director Limited il 10 gen 2017

    1 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Land Securities Management Services Limited il 10 gen 2017

    1 pagineCH02

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 10 gen 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP .05
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2015

    Stato del capitale al 22 lug 2015

    • Capitale: GBP .05
    SH01

    Nomina di Mr Michael Arnaouti come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Adrian Michael De Souza come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 lug 2014

    Stato del capitale al 18 lug 2014

    • Capitale: GBP .05
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ERON INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Segretario
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4365193
    159674790001
    MILES, Elizabeth
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor235498150001
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    74974580001
    LS DIRECTOR LIMITED
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04299372
    133814600001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Segretario
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    JONES, Laurance Aubrey
    242 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Segretario
    242 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    British13653250002
    ARNAOUTI, Michael
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary539040004
    DE BARR, Robert Henry
    Watermark Thames Lawn
    St Peter Street
    SL7 1QA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Watermark Thames Lawn
    St Peter Street
    SL7 1QA Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor14885390006
    DE SOUZA, Adrian Michael
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor158381390001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Amministratore
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary14674480002
    GRIFFITHS, Michael Robert
    Maidirin Rua
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    Amministratore
    Maidirin Rua
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    EnglandBritishChartered Surveyor13422390003
    HENDERSON, Ian James
    Crouch House
    TN8 5LQ Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Crouch House
    TN8 5LQ Edenbridge
    Kent
    EnglandUnited KingdomChartered Surveyor14674060001
    HUNT, Peter John, Sir
    37 Devonshire Mews West
    W1N 1FQ London
    Amministratore
    37 Devonshire Mews West
    W1N 1FQ London
    BritishChartered Surveyor13653440001
    MATHIESON, William
    14 Quickswood
    Primrose Hill
    NW3 3SE London
    Amministratore
    14 Quickswood
    Primrose Hill
    NW3 3SE London
    BritishChartered Surveyor37425010001
    MILLER, Louise
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary199935770001
    MURRAY, James Ian Keith
    8 Pines Road
    BR1 2AA Bickley
    Kent
    Amministratore
    8 Pines Road
    BR1 2AA Bickley
    Kent
    BritishChartered Accountant13422400003
    REDSHAW, Keith
    2 Pound Farm Close
    KT10 8EX Esher
    Surrey
    Amministratore
    2 Pound Farm Close
    KT10 8EX Esher
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor85333010001
    SALWAY, Francis William
    Nash House
    25 Mount Sion
    TN1 1TZ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Nash House
    25 Mount Sion
    TN1 1TZ Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Surveyor72491970003
    STRANGE, Alfred Richard Frank
    25 Hollingbourne Gardens
    Ealing
    W13 8EN London
    Amministratore
    25 Hollingbourne Gardens
    Ealing
    W13 8EN London
    BritishChartered Surveyor13422420001
    LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Amministratore
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    100069790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ERON INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Victoria Street
    SW1E 5JL London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3934750
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ERON INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Obligor floating charge agreement
    Creato il 03 nov 2004
    Consegnato il 16 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from finco and the company and each obligor to the chargee and all monies due or to become due from the obligors to the note trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all present and future assets and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Land Securities Capital Markets PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security trust and intercreditor deed
    Creato il 03 nov 2004
    Consegnato il 16 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any obligor secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interests in 1) the original mortgaged properties 2) any real property 3) all plant machinery and other chattels 4) the obligor accounts 5) all shares and all dividends 6) all rights under any agreement 7) all intellectual property rights 8) all interest in any eligible investments 9) all goodwill 10) all uncalled share capital 11) all monetary claims and related rights. By way of assignment all rental income, all proceeds receivable and all obligor transaction documents. By way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 16 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of release and substitution
    Creato il 28 ott 1999
    Consegnato il 29 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deeds dated 29TH july 1955 and 28TH july 1955
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 7/9 pilgrim street and 10/13 ludgate broadway london EC4. T/no. Ln 221398.
    Persone aventi diritto
    • Legal and General Assurance Society Limted
    Transazioni
    • 29 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 01 ott 1991
    Consegnato il 04 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £200,000,000, 10 per cent. First mortgage debenture stock 2027 (the "stock") of land securities PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed
    Brevi particolari
    Freehold land known as ling house, 10-13 dominion street in the london borough of islington title no ln 170275 (see for full details doc M68).
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 dic 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assurance
    Creato il 31 mar 1989
    Consegnato il 04 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 10% first mortgage debenture stock 2025 of land securities PLC and all other moneys due or to become due under the terms of the terms of the trust deed dated 8/11/85 and supplemental deeds thereto
    Brevi particolari
    All that f/h land & premises k/a 10 to 13 ludgate broadway and 7 & 9 pilgrim street in the city of london title no ln 221398.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0