CMPI HOLDINGS LIMITED

CMPI HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCMPI HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00239142
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CMPI HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UTRAVEL.CO.UK LIMITED12 lug 200012 lug 2000
    UNITED BUSINESS MEDIA LIMITED28 giu 200028 giu 2000
    MILLER FREEMAN UK LIMITED08 apr 199808 apr 1998
    MILLER FREEMAN PLC01 giu 199501 giu 1995
    MORGAN - GRAMPIAN P L C30 apr 192930 apr 1929

    Quali sono gli ultimi bilanci di CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Carl Sheldon Adrian il 07 dic 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Crosswall Nominees Limited il 04 dic 2018

    1 pagineCH02

    Indirizzo della sede legale modificato da 240 Blackfriars Road London SE1 8BF a 5 Howick Place London SW1P 1WG in data 06 dic 2018

    1 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Crosswall Nominees Limited il 04 dic 2018

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Unm Investments Limited il 04 dic 2018

    1 pagineCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2016

    Stato del capitale al 08 gen 2016

    • Capitale: GBP .995
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ago 2015

    Stato del capitale al 18 ago 2015

    • Capitale: GBP .995459
    SH01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Crosswall Nominees Limited il 16 feb 2015

    1 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Carl Adrian il 16 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Unm Investments Limited il 16 feb 2015

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Crosswall Nominees Limited il 16 feb 2015

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UY a 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF in data 17 apr 2015

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione950209
    992770004
    ADRIAN, Carl Sheldon
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish134006860001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione950209
    992770004
    UNM INVESTMENTS LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1219152
    48157320003
    PURSER, Jean Dorothy Anne
    The Dumbles
    7 Ashdown View
    TN22 3HX Nutley
    East Sussex
    Segretario
    The Dumbles
    7 Ashdown View
    TN22 3HX Nutley
    East Sussex
    British94669070001
    SECKER, James
    Berwyn 1 Links Close
    TN6 1QW Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Berwyn 1 Links Close
    TN6 1QW Crowborough
    East Sussex
    British1219420001
    SIMPSON, Mark Andrew Goodman
    Crockford House Snow Hill
    Crawley Down
    RH10 3EE Crawley
    West Sussex
    Segretario
    Crockford House Snow Hill
    Crawley Down
    RH10 3EE Crawley
    West Sussex
    British56280120001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Segretario
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    ARNOLD, Anthony Burton
    Oldbury Farm Southend Road
    Great Wakering
    SS3 0PJ Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    Oldbury Farm Southend Road
    Great Wakering
    SS3 0PJ Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritish8572820001
    ARNOLD, Stanley Richard
    Great Bubhurst Farm
    Bubhurst Lane Frittenden
    TN17 2BD Cranbrook
    Kent
    Amministratore
    Great Bubhurst Farm
    Bubhurst Lane Frittenden
    TN17 2BD Cranbrook
    Kent
    British34857830001
    BAKER, David Arthur
    Oakwood Shoreham Road
    Otford
    TN14 5RN Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Oakwood Shoreham Road
    Otford
    TN14 5RN Sevenoaks
    Kent
    British6265440001
    BRAZIER, John Ansell
    Little Croft 22 Norbury Way
    KT23 4RY Great Bookham
    Surrey
    Amministratore
    Little Croft 22 Norbury Way
    KT23 4RY Great Bookham
    Surrey
    EnglandBritish53359450001
    CAMPBELL, James Milne
    22 Lower Hill Road
    KT19 8LT Epsom
    Surrey
    Amministratore
    22 Lower Hill Road
    KT19 8LT Epsom
    Surrey
    British49487790001
    CONLON, Denis
    Woodstock Westmore Road
    Tatsfield
    TN16 2BJ Westerham
    Kent
    Amministratore
    Woodstock Westmore Road
    Tatsfield
    TN16 2BJ Westerham
    Kent
    British8471710001
    CUNNINGHAM, Paul
    110 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    Amministratore
    110 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    British17122880004
    DE CARLE, John Brian
    Folly Hill Cottage
    Friezley Lane
    TN17 2LL Cranbrook
    Kent
    Amministratore
    Folly Hill Cottage
    Friezley Lane
    TN17 2LL Cranbrook
    Kent
    British8317060001
    DOWNING, Brian George Kirby
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    British8426380001
    ELLINGS, Clive Bryan
    Priors Lea
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Priors Lea
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66808150001
    ELTON, Graham Clive
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish40436370002
    ELTON, Graham Clive
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish40436370002
    FERGUSON, Ailsa Murray
    18 Hosack Road
    SW17 7QP London
    Amministratore
    18 Hosack Road
    SW17 7QP London
    British69565050001
    FOSTER, Maurice Curtis
    White House Farm
    Ivy Hatch
    TN15 0NN Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    White House Farm
    Ivy Hatch
    TN15 0NN Sevenoaks
    Kent
    British8173280001
    FREEMAN, Marshall William
    PO BOX 645
    94528 Diablo
    California
    Usa
    Amministratore
    PO BOX 645
    94528 Diablo
    California
    Usa
    American11882820001
    GRAY, Bernard Peter
    Apartment 35 Blk B
    3rd Floor 10 Wild Street
    WC2B 4RL London
    Amministratore
    Apartment 35 Blk B
    3rd Floor 10 Wild Street
    WC2B 4RL London
    British108397670001
    JAKES, Clifford Duncan
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    British8426370001
    KING, Harold Leslie
    17 Wildcroft Manor
    Wildcroft Road
    SW15 3TS London
    Amministratore
    17 Wildcroft Manor
    Wildcroft Road
    SW15 3TS London
    British14996700001
    LEVY, Rupert James
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    Amministratore
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    British57681630002
    LLOYD, Julian Stuart
    6 Queens Gate Villas
    Victoria Park Road
    E9 7BU London
    Amministratore
    6 Queens Gate Villas
    Victoria Park Road
    E9 7BU London
    British59624160002
    LOMAX, Diana
    17 Parsons Green Lane
    SW6 4HL London
    Amministratore
    17 Parsons Green Lane
    SW6 4HL London
    British49719540003
    MCALEENAN, Patrick David
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    78
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    78
    EnglandBritish14226510001
    MELVILLE, Iain Boyd
    34 Waterlow Road
    RH2 7EX Reigate
    Surrey
    Amministratore
    34 Waterlow Road
    RH2 7EX Reigate
    Surrey
    British34669410002
    MICHAEL, Roger Lucas
    22 Greenways
    WD5 0EU Abbots Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Greenways
    WD5 0EU Abbots Langley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish99335210001
    NAUGHTON, Shane Paul
    41 Neville House
    19 Page Street, Westminster
    SW1P 4JX London
    Amministratore
    41 Neville House
    19 Page Street, Westminster
    SW1P 4JX London
    Irish124972750001
    NUGEE, Andrew
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    Amministratore
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    British78161450001
    NUGEE, Andrew
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    Amministratore
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    British78161450001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    30 giu 2016
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    No
    Forma giuridicaUnlimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione152298
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CMPI HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 06 feb 1984
    Consegnato il 16 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge & a charge dated 31-10-1983.
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the amount & all interest of the company therein both present & future at lloyds bank PLC designated "morgan-grampian PLC" re-"the far pavilions" and numbered 0933717.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 31 ott 1983
    Consegnato il 30 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 26-10-83 or under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Agreement, rights, and the benefit of the guarantee see doc for details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Facility letter
    Creato il 26 ott 1983
    Consegnato il 03 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee dated 31-10/83
    Brevi particolari
    Fixed charge over all monies then or thereafter standing to the credit of account designated "morgan-grampian PLC" re "the far pavilions" (see doc M209).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 30 giu 1982
    Consegnato il 08 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 26 feb 1982
    Consegnato il 05 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 10 ago 1978
    Consegnato il 10 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee s under the terms of a guarantee dated 10TH august 1982
    Brevi particolari
    All book debts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • European American Banking Corporation
    Transazioni
    • 10 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 02 ago 1971
    Consegnato il 03 ago 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    28/31, essex st. City of westminster and vaults beneath essex st.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 03 ago 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 giu 1969
    Consegnato il 07 lug 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    36, 37, 39 essex st & 2, 3, devereux court - 248596 together with machinery & fixtures, & floating charge on implements (see doc 106 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 07 lug 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 27 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0