CMPI HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CMPI HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00239142 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CMPI HOLDINGS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5 Howick Place SW1P 1WG London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| UTRAVEL.CO.UK LIMITED | 12 lug 2000 | 12 lug 2000 |
| UNITED BUSINESS MEDIA LIMITED | 28 giu 2000 | 28 giu 2000 |
| MILLER FREEMAN UK LIMITED | 08 apr 1998 | 08 apr 1998 |
| MILLER FREEMAN PLC | 01 giu 1995 | 01 giu 1995 |
| MORGAN - GRAMPIAN P L C | 30 apr 1929 | 30 apr 1929 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Carl Sheldon Adrian il 07 dic 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Crosswall Nominees Limited il 04 dic 2018 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 240 Blackfriars Road London SE1 8BF a 5 Howick Place London SW1P 1WG in data 06 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Crosswall Nominees Limited il 04 dic 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Unm Investments Limited il 04 dic 2018 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Crosswall Nominees Limited il 16 feb 2015 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Carl Adrian il 16 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Unm Investments Limited il 16 feb 2015 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Crosswall Nominees Limited il 16 feb 2015 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UY a 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF in data 17 apr 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Segretario | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 992770004 | ||||||||||
| ADRIAN, Carl Sheldon | Amministratore | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 134006860001 | |||||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Amministratore | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 992770004 | ||||||||||
| UNM INVESTMENTS LIMITED | Amministratore | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 48157320003 | ||||||||||
| PURSER, Jean Dorothy Anne | Segretario | The Dumbles 7 Ashdown View TN22 3HX Nutley East Sussex | British | 94669070001 | ||||||||||
| SECKER, James | Segretario | Berwyn 1 Links Close TN6 1QW Crowborough East Sussex | British | 1219420001 | ||||||||||
| SIMPSON, Mark Andrew Goodman | Segretario | Crockford House Snow Hill Crawley Down RH10 3EE Crawley West Sussex | British | 56280120001 | ||||||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Segretario | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||||||
| ARNOLD, Anthony Burton | Amministratore | Oldbury Farm Southend Road Great Wakering SS3 0PJ Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 8572820001 | |||||||||
| ARNOLD, Stanley Richard | Amministratore | Great Bubhurst Farm Bubhurst Lane Frittenden TN17 2BD Cranbrook Kent | British | 34857830001 | ||||||||||
| BAKER, David Arthur | Amministratore | Oakwood Shoreham Road Otford TN14 5RN Sevenoaks Kent | British | 6265440001 | ||||||||||
| BRAZIER, John Ansell | Amministratore | Little Croft 22 Norbury Way KT23 4RY Great Bookham Surrey | England | British | 53359450001 | |||||||||
| CAMPBELL, James Milne | Amministratore | 22 Lower Hill Road KT19 8LT Epsom Surrey | British | 49487790001 | ||||||||||
| CONLON, Denis | Amministratore | Woodstock Westmore Road Tatsfield TN16 2BJ Westerham Kent | British | 8471710001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Paul | Amministratore | 110 Chestnut Grove SW12 8JJ London | British | 17122880004 | ||||||||||
| DE CARLE, John Brian | Amministratore | Folly Hill Cottage Friezley Lane TN17 2LL Cranbrook Kent | British | 8317060001 | ||||||||||
| DOWNING, Brian George Kirby | Amministratore | 35 Badingham Drive Fetcham KT22 9EU Leatherhead Surrey | British | 8426380001 | ||||||||||
| ELLINGS, Clive Bryan | Amministratore | Priors Lea The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 66808150001 | |||||||||
| ELTON, Graham Clive | Amministratore | Palmers Farm Hawkenbury Road TN3 9AD Tunbridge Wells Kent | England | British | 40436370002 | |||||||||
| ELTON, Graham Clive | Amministratore | Palmers Farm Hawkenbury Road TN3 9AD Tunbridge Wells Kent | England | British | 40436370002 | |||||||||
| FERGUSON, Ailsa Murray | Amministratore | 18 Hosack Road SW17 7QP London | British | 69565050001 | ||||||||||
| FOSTER, Maurice Curtis | Amministratore | White House Farm Ivy Hatch TN15 0NN Sevenoaks Kent | British | 8173280001 | ||||||||||
| FREEMAN, Marshall William | Amministratore | PO BOX 645 94528 Diablo California Usa | American | 11882820001 | ||||||||||
| GRAY, Bernard Peter | Amministratore | Apartment 35 Blk B 3rd Floor 10 Wild Street WC2B 4RL London | British | 108397670001 | ||||||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Amministratore | Littlehay Burley BH24 4AG Ringwood Hampshire | British | 8426370001 | ||||||||||
| KING, Harold Leslie | Amministratore | 17 Wildcroft Manor Wildcroft Road SW15 3TS London | British | 14996700001 | ||||||||||
| LEVY, Rupert James | Amministratore | 25 Muswell Avenue N10 2EB London | British | 57681630002 | ||||||||||
| LLOYD, Julian Stuart | Amministratore | 6 Queens Gate Villas Victoria Park Road E9 7BU London | British | 59624160002 | ||||||||||
| LOMAX, Diana | Amministratore | 17 Parsons Green Lane SW6 4HL London | British | 49719540003 | ||||||||||
| MCALEENAN, Patrick David | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6UR London 78 | England | British | 14226510001 | |||||||||
| MELVILLE, Iain Boyd | Amministratore | 34 Waterlow Road RH2 7EX Reigate Surrey | British | 34669410002 | ||||||||||
| MICHAEL, Roger Lucas | Amministratore | 22 Greenways WD5 0EU Abbots Langley Hertfordshire | United Kingdom | British | 99335210001 | |||||||||
| NAUGHTON, Shane Paul | Amministratore | 41 Neville House 19 Page Street, Westminster SW1P 4JX London | Irish | 124972750001 | ||||||||||
| NUGEE, Andrew | Amministratore | 47 Breer Street SW6 3HE London | British | 78161450001 | ||||||||||
| NUGEE, Andrew | Amministratore | 47 Breer Street SW6 3HE London | British | 78161450001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubmg Holdings | 30 giu 2016 | Blackfriars Road SE1 8BF London 240 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CMPI HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 06 feb 1984 Consegnato il 16 feb 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge & a charge dated 31-10-1983. | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of the amount & all interest of the company therein both present & future at lloyds bank PLC designated "morgan-grampian PLC" re-"the far pavilions" and numbered 0933717. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 31 ott 1983 Consegnato il 30 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 26-10-83 or under the terms of the charge | |
Brevi particolari Agreement, rights, and the benefit of the guarantee see doc for details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Facility letter | Creato il 26 ott 1983 Consegnato il 03 nov 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee dated 31-10/83 | |
Brevi particolari Fixed charge over all monies then or thereafter standing to the credit of account designated "morgan-grampian PLC" re "the far pavilions" (see doc M209). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Creato il 30 giu 1982 Consegnato il 08 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All sums standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Creato il 26 feb 1982 Consegnato il 05 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brevi particolari All sums standing to the credit of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 10 ago 1978 Consegnato il 10 ago 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee s under the terms of a guarantee dated 10TH august 1982 | |
Brevi particolari All book debts and other debts present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 02 ago 1971 Consegnato il 03 ago 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 28/31, essex st. City of westminster and vaults beneath essex st.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 giu 1969 Consegnato il 07 lug 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 36, 37, 39 essex st & 2, 3, devereux court - 248596 together with machinery & fixtures, & floating charge on implements (see doc 106 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0