HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00240039 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SWAN NATIONAL LEASING LIMITED | 01 apr 1997 | 01 apr 1997 |
| SWAN NATIONAL LIMITED | 08 lug 1994 | 08 lug 1994 |
| VMH TRANSPORT SERVICES LIMITED | 10 dic 1993 | 10 dic 1993 |
| EURODOLLAR LEASING LIMITED | 22 giu 1992 | 22 giu 1992 |
| G.M.(VEHICLE HIRING)LIMITED | 03 giu 1929 | 03 giu 1929 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Katherine Dean come segretario in data 24 lug 2013 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 24 lug 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Richard Andrew Carter come amministratore in data 14 nov 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Adrian Timothy Rigby come amministratore in data 22 mag 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Robert Francis Carver come amministratore in data 22 mag 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gavin Paul Hewitt il 20 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Gavin Paul Hewitt come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Adrian Timothy Rigby come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Brookes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Noel Quinn come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Malcolm James Brookes il 07 gen 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Malcolm James Brookes il 09 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Maher come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Hollie Rheanna Wood come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Noel Paul Quinn il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAN, Katherine | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180094270001 | |||||||
| CARTER, Richard Andrew | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 173634300001 | |||||
| CARVER, Robert Francis | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 167169940001 | |||||
| HEWITT, Gavin Paul | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 162283890002 | |||||
| RUSSELL-BROWN, Michael John | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 109954540001 | |||||
| BAYER, George William | Segretario | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Segretario | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MAIR, James Stewart | Segretario | 7 Padgate Close Scraptoft LE7 9UL Leicester Leicestershire | British | 8864270001 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Segretario | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Segretario | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Segretario | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154741220001 | |||||||
| BOTTOMLEY, Stephen Andrew | Amministratore | Liverton House Roundwood Lane RH16 1SJ Lindfield West Sussex | British | 60768490002 | ||||||
| BROOKES, Malcolm James | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 61727900006 | |||||
| CLAYTON, Laeonard | Amministratore | Clements Cottage Forge Lane West Peckham ME18 5JP Maidstone Kent | British | 47316150001 | ||||||
| CLAYTON, Leonard Francis | Amministratore | 5 The Crofts Banbury Road CV37 7NF Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 58398630002 | ||||||
| CORK, Raymond Michael | Amministratore | Kniveton DE6 1JG Ashbourne Kniveton Wood Farm | United Kingdom | British | 129809740001 | |||||
| EVANS, Geoffrey William | Amministratore | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Amministratore | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 12 Aspins Way Bromsgrove B61 0UW Birmingham | British | 28497420007 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Amministratore | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| LANE, Robert David | Amministratore | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| MOSLEY, Ian Christopher | Amministratore | Middlewood House Jordans Way, Jordans HP9 2SP Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 81842870001 | |||||
| PICKEN, Graham Edward | Amministratore | 60 Church Road Aspley Heath Woburn Sands MK17 8TA Milton Keynes | British | 144947830001 | ||||||
| QUINN, Noel Paul | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 123627420002 | |||||
| QUINN, Noel Paul | Amministratore | 10 Besford Grove Shirley B90 4YU Solihull West Midlands | British | 72093050001 | ||||||
| RIGBY, Adrian Timothy | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 138880420001 | |||||
| SMITHSON, Keith Victor | Amministratore | The Stables 3 Old Manor Court Welton NN11 5HA Daventry Northamptonshire | Irish | 72729280002 | ||||||
| STEIN, Wallace George William | Amministratore | 10 Gibbet Hill Road CV4 7AJ Coventry West Midlands | England | British | 99602760001 |
HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 29 mar 1988 Consegnato il 06 apr 1988 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The interest of the co in motor vehicles supplied by the mortgage & the company on leasing agreements (see 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 29 nov 1982 Consegnato il 17 dic 1982 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All monies benefits rights & choses under hiring agreements all bebefits of securities etc in connection with hiring agreements interest of the company in motor vehicles (see doc M78 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 gen 1981 Consegnato il 25 gen 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land on south east side of katherine street ashton under lyne greater manchester title no gm 211144. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture confirmed rectified by a resolution dated 11/12/80 | Creato il 26 mag 1977 Consegnato il 23 dic 1980 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or ro all on any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 02 goodwill bookdebts with all buildings fixtures fixed plant and machinery and floating charge (see doc.M75). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0