HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED

HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00240039
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SWAN NATIONAL LEASING LIMITED01 apr 199701 apr 1997
    SWAN NATIONAL LIMITED08 lug 199408 lug 1994
    VMH TRANSPORT SERVICES LIMITED10 dic 199310 dic 1993
    EURODOLLAR LEASING LIMITED22 giu 199222 giu 1992
    G.M.(VEHICLE HIRING)LIMITED03 giu 192903 giu 1929

    Quali sono gli ultimi bilanci di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Katherine Dean come segretario in data 24 lug 2013

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 24 lug 2013

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mag 2013

    Stato del capitale al 15 mag 2013

    • Capitale: GBP 600
    SH01

    Nomina di Richard Andrew Carter come amministratore in data 14 nov 2012

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Adrian Timothy Rigby come amministratore in data 22 mag 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Robert Francis Carver come amministratore in data 22 mag 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Gavin Paul Hewitt il 20 apr 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Nomina di Gavin Paul Hewitt come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Adrian Timothy Rigby come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Malcolm Brookes come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Noel Quinn come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Malcolm James Brookes il 07 gen 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Malcolm James Brookes il 09 feb 2011

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Sarah Maher come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Hollie Rheanna Wood come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Noel Paul Quinn il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180094270001
    CARTER, Richard Andrew
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish173634300001
    CARVER, Robert Francis
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish167169940001
    HEWITT, Gavin Paul
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish162283890002
    RUSSELL-BROWN, Michael John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish109954540001
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Segretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MAIR, James Stewart
    7 Padgate Close
    Scraptoft
    LE7 9UL Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    7 Padgate Close
    Scraptoft
    LE7 9UL Leicester
    Leicestershire
    British8864270001
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Segretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154741220001
    BOTTOMLEY, Stephen Andrew
    Liverton House
    Roundwood Lane
    RH16 1SJ Lindfield
    West Sussex
    Amministratore
    Liverton House
    Roundwood Lane
    RH16 1SJ Lindfield
    West Sussex
    British60768490002
    BROOKES, Malcolm James
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish61727900006
    CLAYTON, Laeonard
    Clements Cottage Forge Lane
    West Peckham
    ME18 5JP Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Clements Cottage Forge Lane
    West Peckham
    ME18 5JP Maidstone
    Kent
    British47316150001
    CLAYTON, Leonard Francis
    5 The Crofts
    Banbury Road
    CV37 7NF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    5 The Crofts
    Banbury Road
    CV37 7NF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British58398630002
    CORK, Raymond Michael
    Kniveton
    DE6 1JG Ashbourne
    Kniveton Wood Farm
    Amministratore
    Kniveton
    DE6 1JG Ashbourne
    Kniveton Wood Farm
    United KingdomBritish129809740001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Amministratore
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Amministratore
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    12 Aspins Way
    Bromsgrove
    B61 0UW Birmingham
    Amministratore
    12 Aspins Way
    Bromsgrove
    B61 0UW Birmingham
    British28497420007
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Amministratore
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Amministratore
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    MOSLEY, Ian Christopher
    Middlewood House
    Jordans Way, Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Middlewood House
    Jordans Way, Jordans
    HP9 2SP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish81842870001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Amministratore
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish123627420002
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    RIGBY, Adrian Timothy
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish138880420001
    SMITHSON, Keith Victor
    The Stables 3 Old Manor Court
    Welton
    NN11 5HA Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Stables 3 Old Manor Court
    Welton
    NN11 5HA Daventry
    Northamptonshire
    Irish72729280002
    STEIN, Wallace George William
    10 Gibbet Hill Road
    CV4 7AJ Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    10 Gibbet Hill Road
    CV4 7AJ Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish99602760001

    HSBC VEHICLE SERVICES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 29 mar 1988
    Consegnato il 06 apr 1988
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The interest of the co in motor vehicles supplied by the mortgage & the company on leasing agreements (see 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Charge
    Creato il 29 nov 1982
    Consegnato il 17 dic 1982
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All monies benefits rights & choses under hiring agreements all bebefits of securities etc in connection with hiring agreements interest of the company in motor vehicles (see doc M78 for full details).
    Persone aventi diritto
    • General Motors Acceptance Corporation (U.K.)Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 22 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal charge
    Creato il 08 gen 1981
    Consegnato il 25 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on south east side of katherine street ashton under lyne greater manchester title no gm 211144.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee and debenture confirmed rectified by a resolution dated 11/12/80
    Creato il 26 mag 1977
    Consegnato il 23 dic 1980
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or ro all on any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    02 goodwill bookdebts with all buildings fixtures fixed plant and machinery and floating charge (see doc.M75).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 22 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0