DONVALE PROPERTY LIMITED

DONVALE PROPERTY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDONVALE PROPERTY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00240401
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DONVALE PROPERTY LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova DONVALE PROPERTY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Bell & Buxton Telegraph House
    High Street
    S1 2GA Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DONVALE PROPERTY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    G & J HALL LIMITED03 lug 200803 lug 2008
    B AND J HALL LIMITED30 giu 200830 giu 2008
    G. & J. HALL LIMITED18 giu 192918 giu 1929

    Quali sono gli ultimi bilanci di DONVALE PROPERTY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DONVALE PROPERTY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 05 ott 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Declare dividend 10/08/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da G & J Hall Burgess Road Sheffield S9 3WD a C/O Bell & Buxton Telegraph House High Street Sheffield S1 2GA in data 17 dic 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    25 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2015 al 31 dic 2015

    3 pagineAA01

    Nomina di Mr John Richard Edwards come segretario in data 01 feb 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Mark Towning come amministratore in data 31 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Mark Towning come segretario in data 31 gen 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 17 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2016

    Stato del capitale al 13 gen 2016

    • Capitale: GBP 1,136,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da G & J Hall Ltd Burgess Road Sheffield S9 3WD a G & J Hall Burgess Road Sheffield S9 3WD in data 13 gen 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di DONVALE PROPERTY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDWARDS, John Richard
    Carsick Hill Crescent
    S10 3LS Sheffield
    65
    England
    Segretario
    Carsick Hill Crescent
    S10 3LS Sheffield
    65
    England
    204710480001
    EDWARDS, John Richard
    High Street
    S1 2GA Sheffield
    C/O Bell & Buxton Telegraph House
    England
    Amministratore
    High Street
    S1 2GA Sheffield
    C/O Bell & Buxton Telegraph House
    England
    EnglandBritishDirector21666370002
    EDWARDS, Peter David
    High Street
    S1 2GA Sheffield
    C/O Bell & Buxton Telegraph House
    England
    Amministratore
    High Street
    S1 2GA Sheffield
    C/O Bell & Buxton Telegraph House
    England
    EnglandBritishCompany Director75195470005
    BRIGGS, Anthony John
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    British3305550001
    EDWARDS, Peter David
    The Cottage Moorlands
    Frogatt Hope Valley
    S1 2GA Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    The Cottage Moorlands
    Frogatt Hope Valley
    S1 2GA Sheffield
    South Yorkshire
    British75195470001
    TOWNING, William Mark
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall
    England
    Segretario
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall
    England
    BritishCompany Secretary71235470002
    ADLINGTON, Maurice
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall Ltd
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector49651960002
    ADLINGTON, Maurice
    9 Craven Road
    Newbold
    S41 7HJ Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    9 Craven Road
    Newbold
    S41 7HJ Chesterfield
    Derbyshire
    United KingdomBritishSales Director49651960002
    APPLEBY, Herbert
    12 Woodvale Road
    S10 3EX Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    12 Woodvale Road
    S10 3EX Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSolicitor3386660001
    BOOTH, Raymond
    47 Rowan Tree Road
    Killamarsh
    S21 1FS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    47 Rowan Tree Road
    Killamarsh
    S21 1FS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector102970540001
    BOOTH, Raymond
    47 Rowan Tree Road
    Killamarsh
    S21 1FS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    47 Rowan Tree Road
    Killamarsh
    S21 1FS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishEngineer102970540001
    BRIGGS, Anthony John
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector3305550001
    EDWARDS, Walter Noel
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall Ltd
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector3305570001
    FLETCHER, Douglas Leslie
    143 High Storrs Road
    S11 7LG Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    143 High Storrs Road
    S11 7LG Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant3526330001
    HULLEY, Reginald
    17 Robin Hood Chase
    Stannington
    S6 6FH Sheffield
    Amministratore
    17 Robin Hood Chase
    Stannington
    S6 6FH Sheffield
    BritishSteel Manufacturer3314600001
    MARRIOTT, James Barry
    36 Park Head Road
    S11 9RB Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    36 Park Head Road
    S11 9RB Sheffield
    South Yorkshire
    BritishWorks Director3305590001
    NETTLESHIP, Brian Richard
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall Ltd
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector36874230001
    NETTLESHIP, Brian Richard
    373 Burncross Road
    Burncross
    S35 1SB Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    373 Burncross Road
    Burncross
    S35 1SB Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishEngineer36874230001
    TOWNING, William Mark
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall
    England
    Amministratore
    Burgess Road
    S9 3WD Sheffield
    G & J Hall
    England
    EnglandBritishDirector71235470002
    TOWNING, William Mark
    23 Greenacres Close
    S18 1WE Dronfield
    Derbyshire
    Amministratore
    23 Greenacres Close
    S18 1WE Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Secretary71235470002

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per DONVALE PROPERTY LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    17 dic 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    DONVALE PROPERTY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 set 2014
    Consegnato il 15 ott 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Land and buildings at ferguson street sheffield.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 giu 2014
    Consegnato il 17 giu 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Land and buildings at burgess road, zion lane and ferguson street, sheffield S9 3WD.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2014
    Consegnato il 19 giu 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Land and buildings at burgess road, zion lane and ferguson street, sheffield S9 3WD.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    All assets debenture
    Creato il 04 apr 2012
    Consegnato il 07 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2012
    Consegnato il 12 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • John Richard Edwards
    Transazioni
    • 12 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2012
    Consegnato il 12 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Peter David Edwards
    Transazioni
    • 12 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2012
    Consegnato il 12 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Catherine Ruth Jones
    Transazioni
    • 12 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 mar 2012
    Consegnato il 12 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Water Noel Edwards
    Transazioni
    • 12 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and all equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Catherine Ruth Jones
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and all equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter David Edwards
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and all equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Richard Edwards
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and all equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Walter Noel Edwards
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 13 dic 2004
    Consegnato il 15 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge over all goodwill,intellectual property,book debts,contracts,plant machinery equipment and stock in trade of the company including (I) f/hold land and buildings on south side of burgess rd,sheffield;SYK98913; (ii) f/hold and/blds on west side of burgess rd,sheffield; SYK5469; (iii) f/hold land on south east side of ferguson st,sheffield; SYK5609. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Donvale Holdings Limited
    Transazioni
    • 15 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 dic 2004
    Consegnato il 15 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south side of burgess road sheffield t/n SYK98913 f/h land and buildings on the west side of burgess road sheffield t/n SYK5469 f/h land and buildings on the south east side of ferguson street sheffield t/n SYK56094 for further details of the properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed
    Creato il 19 apr 1984
    Consegnato il 27 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 18/9/74
    Brevi particolari
    First fixed charge on all the book debts & other debts of the company present & future.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 lug 1981
    Consegnato il 09 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of burgess road sheffield south yorkshire title no syk 98913 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams and Glyn's Bank LTD
    Transazioni
    • 09 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1975
    Consegnato il 13 giu 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on west side of burgess road allercliffe sheffield south, yorkshire, together with all fixtures whatsoever now or at anytime hereafter affixed other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. all fixed and movable plant and machinery and fixtures implements and utensils from time to time therein or thereon.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank LTD.
    Transazioni
    • 13 giu 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 set 1974
    Consegnato il 27 set 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited.
    Transazioni
    • 27 set 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0