WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00240816 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher James Giles come amministratore in data 05 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore in data 05 set 2011 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di David Charles Geoffrey Foster come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Bartholomew come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Allan Robson come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Christopher James Giles come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per David Charles Geoffrey Foster il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard James Bartholomew il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Allan Robson il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 10 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2007 | 16 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2006 | 18 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Segretario | 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA | British | 52040210003 | ||||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Amministratore | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 52040210004 | |||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Amministratore | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham D90 | United Kingdom | British | 63620010002 | |||||
| FENNELL, Sonia | Segretario | Gilliver Cottage Gilliver Lane Clipston On The Wolds NG12 5PD Nottingham | British | 9591230004 | ||||||
| OLIVER, Michael John | Segretario | 31 Westgate NG25 0JN Southwell Nottinghamshire | British | 9290020001 | ||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Amministratore | Fern Cottage 34 School Lane Old Woodhouse LE12 8UJ Loughborough Leicestershire | British | 45937360002 | ||||||
| BARTHOLOMEW, Richard James | Amministratore | 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA | England | British | 136899890001 | |||||
| CRUM, Richard Leslie | Amministratore | 95 Main Street Calverton NG14 6FG Nottingham | British | 78773350002 | ||||||
| EDWARDS, Anthony Clive | Amministratore | 28 Carter Gate NG1 1GL Nottingham Nottinghamshire | British | 15706300001 | ||||||
| EVANS, Peter Jonathan | Amministratore | 9 Pinfold Bingham NG13 8ER Nottingham | British | 43653670001 | ||||||
| GARDNER, Robert Lyle | Amministratore | Redhill House NG22 0BS Newark Notts | England | British | 126736940001 | |||||
| GILES, Christopher James | Amministratore | 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA | England | British | 149729660001 | |||||
| GRIMSDELL, Colin Raymond | Amministratore | Pine Lodge Guinevere Avenue, Stretton DE13 0FZ Burton On Trent Staffordshire | British | 66708640001 | ||||||
| LEWIS, Anne Valerie | Amministratore | Oaklands Eyres Lane Gotham NG11 0LQ Nottingham Nottinghamshire | British | 45237810001 | ||||||
| MARTINDALE, Michael Ernest | Amministratore | Hillcott Main Street NG12 5QQ Wysall Nottingham | British | 29516770001 | ||||||
| ROBSON, Allan | Amministratore | 1 Thane Road West, Nottingham NG2 3AA | England | British | 76137950002 | |||||
| RUDDELL, Michael Frith | Amministratore | Hillcroft 109 High Street WR12 7AL Broadway Worcestershire | Irish | 9723520002 | ||||||
| VASISHTA, Veer Sagar | Amministratore | 337 High Street Cottenham CB4 8TX Cambridge Cambridgeshire | British | 89021810002 | ||||||
| WEBSTER, Ian James Sheldon | Amministratore | 18 Curlew Wharf Castle Marina NG7 1GU Nottingham | British | 79095590002 |
WHITES PROPERTY COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of release and substitution | Creato il 13 nov 1981 Consegnato il 18 nov 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from timothy whites limited to the chargee under the terms of a trust deed dated 14 july 1967. | |
Brevi particolari 7/9 calverley road tunbridge wells kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Disposition dated 6.3.56 and minute of agreement dated 6TH and 8TH march 1956 | Creato il 21 mar 1956 Consegnato il 21 mar 1956 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing £500,000 due from the company to the chargee and secured by a charge dated 1.3.56 | |
Brevi particolari 40, queensferry street, edinburgh, midlothian, together with the fixtures and fittings. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge and disposition dated 6.3.56 & minute of agreement sealed 6 and 8-3-56 registered pursuant to an order of court dated 26.4.57. | Creato il 01 mar 1956 Acquisito il 28 dic 1956 Consegnato il 03 mag 1957 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing £500,000 due from whites property company limited and secured collaterally on property acquired by the company | |
Brevi particolari F/H properties known as 1, market place, durham; 61/, roman r, bow, london; 24, horsemarket, barnard castle, durham; 8, high street, horncastle york l/h property known as 34 new st, huddersfield heritable property known as: 228 & 230 high st, kirkcaldy. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memo of deposit | Creato il 17 gen 1930 Consegnato il 04 feb 1930 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Various properties (see doc 17 for detais). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0