REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00241037 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 26 Whitehall Road LS12 1BE Leeds |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED | 25 mar 1998 | 25 mar 1998 |
DRAKEWOOD LIMITED | 14 apr 1992 | 14 apr 1992 |
THE CAERPHILLY ADVERTISER LIMITED | 15 mag 1991 | 15 mag 1991 |
ROTHWELL ADVERTISER PRESS LIMITED | 13 lug 1929 | 13 lug 1929 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 28 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David John King il 01 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Mccall il 01 lug 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ashley Gilroy Mark Highfield il 01 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David John King come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Grant Murray come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Cammiade come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * P O Box 168 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 1RF* in data 06 dic 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Fry come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Grant Murray come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Daniel Cammiade come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Paterson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCALL, Peter | Segretario | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 147147280001 | |||||||
HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 164400440001 | ||||
KING, David John | Amministratore | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 179020430001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Segretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
COOPER, Philip Richard | Segretario | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | Company Director | 131295290001 | |||||
HILL, Robert Christopher | Segretario | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | British | Company Secretary | 72684940002 | |||||
MILNES, Ann | Segretario | 5 Dawsons Meadow Farsley LS28 5TU Pudsey West Yorkshire | British | Company Secretary | 59652640002 | |||||
YEOMANS, Graham Arthur | Segretario | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | 602760001 | ||||||
CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Segretario | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||
AUCKLAND, Stephen Andrew | Amministratore | The Croft 12 Town End Lane HD8 0NA Lepton Huddersfield | British | Director | 81185280001 | |||||
BOWDLER, Timothy John | Amministratore | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | Company Director | 37521870002 | ||||
CAMMIADE, Danny | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | Chief Operating Officer | 251394160001 | ||||
FRY, John Anthony | Amministratore | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | Chief Executive | 136914890001 | ||||
HILL, Robert Christopher | Amministratore | 9 Kingsley Close Sandal WF2 7EB Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 72684940002 | ||||
LAVERICK, Susan Christine | Amministratore | Sycamore Cottage Park Lane, Emley HD8 9SS Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 99591930001 | ||||
LAWLER, Thomas Philip | Amministratore | Glenlair Cottage 15 Nab Lane BD18 4EH Shipley West Yorkshire | British | Director | 7475760001 | |||||
MURRAY, Grant | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 159877110001 | ||||
OAKLEY, Christopher John | Amministratore | Random Wood Ling Lane, Scarcroft LS14 3HY Leeds West Yorkshire | British | Director | 68410390001 | |||||
PATERSON, Stuart Randall | Amministratore | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Company Director | 64281400001 | ||||
TOULMIN, George Michael | Amministratore | The West Wing Thorp Arch Hall LS23 7AW Wetherby West Yorkshire | British | Director | 9253330001 | |||||
WELCH, Thomas Henry | Amministratore | Wyvern Underhill Brockweir NP6 7NQ Chepstow Gwent | British | Managing Director | 59881590004 | |||||
YEOMANS, Graham Arthur | Amministratore | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | Company Secretary | 602760001 | |||||
CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Amministratore | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||
UNM INVESTMENTS LIMITED | Amministratore | Ludgate House 245 Blackfriars Road SE1 9UY London | 48157320003 |
REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Creato il 03 feb 1987 Consegnato il 06 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 24 lug 1981 Consegnato il 03 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold premises at lamberts yard, rothwell.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Indenture | Creato il 05 ott 1970 Consegnato il 26 ott 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £590.15 | |
Brevi particolari Ford corsair 2000 1968 pum 332G. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0