REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED

REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00241037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    26 Whitehall Road
    LS12 1BE Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED25 mar 199825 mar 1998
    DRAKEWOOD LIMITED14 apr 199214 apr 1992
    THE CAERPHILLY ADVERTISER LIMITED15 mag 199115 mag 1991
    ROTHWELL ADVERTISER PRESS LIMITED13 lug 192913 lug 1929

    Quali sono gli ultimi bilanci di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2013

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John King il 01 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Peter Mccall il 01 lug 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ashley Gilroy Mark Highfield il 01 lug 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 lug 2014

    Stato del capitale al 29 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2012

    8 pagineAA

    Nomina di Mr David John King come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Grant Murray come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 08 mag 2013

    SH01

    Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Cammiade come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * P O Box 168 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 1RF* in data 06 dic 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Fry come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Grant Murray come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Daniel Cammiade come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Paterson come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Segretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    147147280001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Executive Officer164400440001
    KING, David John
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Amministratore
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer179020430001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Segretario
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Segretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    BritishCompany Director131295290001
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary72684940002
    MILNES, Ann
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Dawsons Meadow
    Farsley
    LS28 5TU Pudsey
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary59652640002
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Segretario
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    British602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Segretario
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    AUCKLAND, Stephen Andrew
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    Amministratore
    The Croft 12 Town End Lane
    HD8 0NA Lepton
    Huddersfield
    BritishDirector81185280001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Amministratore
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director37521870002
    CAMMIADE, Danny
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    EnglandBritishChief Operating Officer251394160001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Amministratore
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritishChief Executive136914890001
    HILL, Robert Christopher
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Kingsley Close
    Sandal
    WF2 7EB Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Secretary72684940002
    LAVERICK, Susan Christine
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sycamore Cottage
    Park Lane, Emley
    HD8 9SS Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director99591930001
    LAWLER, Thomas Philip
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Glenlair Cottage 15 Nab Lane
    BD18 4EH Shipley
    West Yorkshire
    BritishDirector7475760001
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Amministratore
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritishChief Financial Officer159877110001
    OAKLEY, Christopher John
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Random Wood
    Ling Lane, Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector68410390001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director64281400001
    TOULMIN, George Michael
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The West Wing
    Thorp Arch Hall
    LS23 7AW Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector9253330001
    WELCH, Thomas Henry
    Wyvern
    Underhill Brockweir
    NP6 7NQ Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    Wyvern
    Underhill Brockweir
    NP6 7NQ Chepstow
    Gwent
    BritishManaging Director59881590004
    YEOMANS, Graham Arthur
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    Amministratore
    13 Beagle Ridge Drive
    Acomb
    YO2 3JH York
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary602760001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Amministratore
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    UNM INVESTMENTS LIMITED
    Ludgate House
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Amministratore
    Ludgate House
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    48157320003

    REGIONAL INDEPENDENT NEWSPAPERS SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 feb 1987
    Consegnato il 06 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 lug 1981
    Consegnato il 03 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises at lamberts yard, rothwell.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 03 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Indenture
    Creato il 05 ott 1970
    Consegnato il 26 ott 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £590.15
    Brevi particolari
    Ford corsair 2000 1968 pum 332G.
    Persone aventi diritto
    • F.W. Development
    Transazioni
    • 26 ott 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 26 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0