2 CARE

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società2 CARE
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 00242188
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 2 CARE?

    • Strutture residenziali di assistenza per persone con difficoltà di apprendimento, disturbi mentali e abuso di sostanze (87200) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova 2 CARE?

    Indirizzo della sede legale
    80 Holloway Road
    N7 8JG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 2 CARE?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    S.O.S.SOCIETY(THE)06 set 192906 set 1929

    Quali sono gli ultimi bilanci di 2 CARE?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per 2 CARE?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Rimozione di una società come proprietario sociale

    2 pagineHC02

    Nomina di Mr Brian Leslie Glicksman come amministratore in data 17 mar 2016

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2016, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    29 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Powell il 25 giu 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Diane French come amministratore in data 10 giu 2015

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 3

    2 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di 2 CARE?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRINDLE, David John
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishJournalist100058320001
    CAREN, Derek Patrick
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director171432050001
    GLICKSMAN, Brian Leslie
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    EnglandBritishRetired101418510001
    HARRISON, Charlotte Anne, Doctor
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Great BritainBritishPsychiatrist155675280001
    LAKHANI, Rajesh
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant134288970001
    POWELL, Alan
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishNone9996530003
    WATSON, Claire
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishConsultant55099600002
    O'SULLIVAN, Elizabeth Caroline Ruth
    7 Osterley Park View Road
    W7 2HG London
    Segretario
    7 Osterley Park View Road
    W7 2HG London
    British2380350001
    APETROAIE, Neculai
    23 Stanley Road
    TW3 1YA Hounslow
    Middlesex
    Amministratore
    23 Stanley Road
    TW3 1YA Hounslow
    Middlesex
    BritishSocial Services54255800001
    ARMSTRONG, June Patricia
    Arkle New Street
    HR8 2EL Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Arkle New Street
    HR8 2EL Ledbury
    Herefordshire
    BritishRetired4447700002
    ASHBY, Robert Leslie
    65 Corkscrew Hill
    BR4 9BA West Wickham
    Kent
    Amministratore
    65 Corkscrew Hill
    BR4 9BA West Wickham
    Kent
    BritishConsultant Surveyor24775530001
    BUXTON, William Arnold George, The Reverend
    The Old House
    45 The Mint
    TN31 7EN Rye
    East Sussex
    Amministratore
    The Old House
    45 The Mint
    TN31 7EN Rye
    East Sussex
    BritishRetired28420900002
    CHAMPERNOWNE, Wilhelmina Barbara Maria
    20 Manor Court
    CB3 9BE Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    20 Manor Court
    CB3 9BE Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishRetired Teacher24775540001
    CLARKE, Rosemary
    21 Deanhill Court
    SW14 7DJ London
    Amministratore
    21 Deanhill Court
    SW14 7DJ London
    BritishRetired Speech Therapist24775550001
    CONSTANTINIDI, Sheila Mary
    Marsh Mills House Wargrave Road
    RG9 3HY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Marsh Mills House Wargrave Road
    RG9 3HY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishHousewife24775560001
    COOMBES, William
    Vardalu Pet Hotel
    Watford Road
    WD6 3BG Elstree
    Herts
    Amministratore
    Vardalu Pet Hotel
    Watford Road
    WD6 3BG Elstree
    Herts
    BritishKennels Manager/Owner24775630001
    CORLEY, Peter Francis
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158580290001
    CROSS, Derek William
    Brenchley Road
    Brenchley
    TN12 7PB Tonbridge
    11
    Kent
    England
    Amministratore
    Brenchley Road
    Brenchley
    TN12 7PB Tonbridge
    11
    Kent
    England
    United KingdomBritishRetired23580870001
    CROSS, Jennifer Ann
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishSocial Worker23580860001
    DE ROEMER, Martin Charles
    Overwey
    Tilford
    GU10 2BS Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Overwey
    Tilford
    GU10 2BS Farnham
    Surrey
    BritishRetired Stockbroker13557760001
    ENNIS, Charles Henry Burkinshaw
    39 Perrymead Street
    SW6 3SN London
    Amministratore
    39 Perrymead Street
    SW6 3SN London
    BritishRetired3669860001
    FINCH, Ernest John
    Vimeiro
    20 Sovereign Drive
    GU15 1PJ Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Vimeiro
    20 Sovereign Drive
    GU15 1PJ Camberley
    Surrey
    BritishCommercial Executive65997730001
    FITZGERALD, Adrian James Andrew, Sir
    16 Clareville Street
    SW7 5AW London
    Amministratore
    16 Clareville Street
    SW7 5AW London
    United KingdomBritishBorough Councillor17707260001
    FRENCH, Diane
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Performance & Quality155617730001
    GILLIES, Crawford Scott
    19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    Amministratore
    19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    BritishManagement Consultant42352800001
    GLICKSMAN, Brian Leslie
    18 Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    Surrey
    Amministratore
    18 Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    Surrey
    EnglandBritishRetired Civil Servant101418510001
    GLICKSMAN, Jacqueline Patricia
    Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    11
    Surrey
    Great Britain
    Amministratore
    Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    11
    Surrey
    Great Britain
    United KingdomBritishRetired156518410001
    HARRIS, Susan
    Five Chimneys
    Mill Road
    TN36 4EJ Winchelsea
    East Sussex
    Amministratore
    Five Chimneys
    Mill Road
    TN36 4EJ Winchelsea
    East Sussex
    BritishRetired Lecturer88110850002
    HAWKEN, Gillian
    17 Foxgrove Road
    BR3 2AR Beckenham
    Kent
    Amministratore
    17 Foxgrove Road
    BR3 2AR Beckenham
    Kent
    BritishTeacher24775620001
    HOLDER, Edward John Ring
    Windy Ridge
    7 Shear Hill
    GU31 4BQ Petersfield
    Hants
    Amministratore
    Windy Ridge
    7 Shear Hill
    GU31 4BQ Petersfield
    Hants
    BritishRetired Chartered Accountant24775610001
    HOLDER, Richard John, Dr
    48 College Street
    GU31 4AF Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    48 College Street
    GU31 4AF Petersfield
    Hampshire
    EnglishArchitectural Historian59623710003
    HYSEL, Margaret
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Amministratore
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive158579790001
    JONES, David Llewelyn Edwards
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    West Sussex
    Amministratore
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    West Sussex
    EnglandBriitishRetired83141830002
    JONES, Jean
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    11
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    11
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishRetired156746880001
    JUDGE, Percy William
    Redroofs Lawn Road
    BR3 1RH Beckenham
    Kent
    Amministratore
    Redroofs Lawn Road
    BR3 1RH Beckenham
    Kent
    BritishBank Manager35927690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di 2 CARE?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Richmond Fellowship
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    England
    06 apr 2016
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Guarantee
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Acts
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione00662712
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    2 CARE ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 24 lug 2001
    Consegnato il 13 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16 carlton drive putney l/b of wandsworth t/no.LN214041.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 23 mag 2001
    Consegnato il 06 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re 2 care business premium account (or treasurers deposit) account number 90758140. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 11 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cotswold house, church road, cainscross, gloucestershire t/no: GR119311.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed supplemental to a legal charge
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 11 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the legal charge dated 30TH november 1995
    Brevi particolari
    All the goodwill of the business carried on from time to time at the mortgaged property k/a cotswold house, church road, cainscross gloucestershire t/no : GR119311. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed supplemental to the legal charge dated 31ST october 1995
    Creato il 31 ott 1995
    Consegnato il 13 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the legal charge dated 31ST october 1995
    Brevi particolari
    All the goodwill of the business carried on from time to time at the mortgaged property k/a 2 & 4 albert road cosham portsmouth t/n HP313922.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1995
    Consegnato il 13 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 & 4 albert road cosham portsmouth hampshire t/n HP313922.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed supplemental to a legal charge
    Creato il 14 ago 1995
    Consegnato il 24 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the legal charge of even date
    Brevi particolari
    All the goodwill of the business carried on from time to time at the f/h property k/a longforth nursing home longforth road wellington somerset t/n st 39188.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 14 ago 1995
    Consegnato il 24 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Longforth nursing home longforth road wellington somerset t/n st 39188.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1992
    Consegnato il 29 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement and the charge
    Brevi particolari
    F/H winston house brooklands avenue cambridge t/n P176301.
    Persone aventi diritto
    • The Housing Corporation
    Transazioni
    • 29 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1991
    Consegnato il 26 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and property situate at and k/a 272 colney hatch lane friern barnet, l/borough of barnet t/no:- ngl 676091.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 1987
    Consegnato il 27 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    36/38 kensington park road l/b of kensington & chelsea T.n's 167346 310325.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment & legal charge
    Creato il 21 set 1979
    Consegnato il 26 set 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 263, camden road, islington, london title no. 257437.
    Persone aventi diritto
    • The Housing Corporation of Maple House
    Transazioni
    • 26 set 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 23 ago 1978
    Consegnato il 29 ago 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 55,000 and all other monies due or to become due from th e borrower to the chargee supplemental to a legal charge dated 10/8/76
    Brevi particolari
    Hill house high street, elstree in the london borough of barnett.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor, Aldermen and Burgesses of the London Borough of Barnett
    Transazioni
    • 29 ago 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 ago 1976
    Consegnato il 12 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing sterling pounds 7,569 and further advances not exceeding sterling pounds 25,000 in the aggregate therewith.
    Brevi particolari
    Hill house high street, elstree, london borough of barnet.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor Alderman and Burgesses of Barnet.
    Transazioni
    • 12 ago 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 15 nov 1967
    Consegnato il 22 nov 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 12,000.
    Brevi particolari
    1, southlands grove, bickley, bromley.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company LTD.
    Transazioni
    • 22 nov 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0