WILSON CONNOLLY LIMITED
Panoramica
Nome della società | WILSON CONNOLLY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00244804 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WILSON CONNOLLY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WILSON CONNOLLY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WILSON CONNOLLY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WILCON HOMES LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
WILCON CONSTRUCTION LIMITED | 02 gen 1930 | 02 gen 1930 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WILSON CONNOLLY LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WILSON CONNOLLY LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 apr 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per WILSON CONNOLLY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come segretario in data 09 dic 2024 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Sayed Suleiman Ashrafi come segretario in data 09 dic 2024 | 2 pagine | AP03 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 11 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 24 apr 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Jennifer Canty come amministratore in data 24 apr 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2024 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 09 ott 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 09 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 13 pagine | AA | ||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 55 | 2 pagine | MR05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 15 pagine | AA | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 pagine | AD03 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 pagine | AD02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Colin Richard Clapham come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 31 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Ian Graham Connor come amministratore in data 25 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Sarah Judith Thornley come amministratore in data 25 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 20 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di WILSON CONNOLLY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHRAFI, Sayed Suleiman | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 330347940001 | |||||||
CANTY, Jennifer | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 322288120001 | ||||
CONNOR, Ian Graham | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 193626080001 | ||||
HASTINGS, Jonathan Philip | Segretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
LAWTHER, Samuel David | Segretario | Stow Cottage Spaldwick Road, Stow Longa PE18 0TL Huntingdon Cambridgeshire | British | 41835460012 | ||||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 34521340004 | ||||||
NUNN, Carol Jayne | Segretario | 4 Juniper Close NN12 6XP Towcester Northamptonshire | British | 116824870001 | ||||||
STOTE, Tanya | Segretario | Honeyburge The Fordrough B90 1PP Solihull West Midlands | British | 113603590001 | ||||||
ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Amministratore | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 193735640001 | ||||
ANDREW, Peter Robert | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Regional Managing Director | 113503830003 | ||||
BANNISTER, William Henry | Amministratore | 28 Riverside Road West Moors BH22 0LQ Ferndown Dorset | United Kingdom | British | Director | 58990140003 | ||||
BEAL, Ian Paul | Amministratore | Meadowbank 10 Stagswood BH31 6PX Verwood Dorset | British | Director | 71260780003 | |||||
BELL, Darren | Amministratore | 5 Brookway Wrea Green PR4 2NU Preston | United Kingdom | British | Managing Director | 73256080001 | ||||
BENSON, Deborah Clare | Amministratore | 30 Wardie Square EH5 1EU Edinburgh Lothian | British | Managing Director | 52845300004 | |||||
BLACK, Ian Craig | Amministratore | 7 The Courtyard Ecton Hall NN6 0QE Ecton Northamptonshire | British | Chartered Accountant | 4579780003 | |||||
BROOMFIELD, Matthew | Amministratore | 3 Link Drive Brampton PE28 4FE Huntingdon Cambridgeshire | British | Director | 80131820001 | |||||
BURGESS, Alan Robert | Amministratore | 1 Pinetops Forest Road RH12 4HU Horsham West Sussex | England | British | Company Director | 79587600001 | ||||
CARNEY, Christopher | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 125216670001 | ||||
CHANDRAN, Vikranth | Amministratore | Carlton Avenue East Wembley HA9 8QB London 227 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 139652640001 | ||||
CLAPHAM, Colin Richard | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 9684390001 | ||||
COKER, John Edwin | Amministratore | Brambly Hedge 3 Somersall Willows S40 3SR Chesterfield Derbyshire | England | British | Company Director | 100513680001 | ||||
DICKERSON, Graham Leslie | Amministratore | St Aubuns Cricketfield Lane CM23 2SR Bishops Stortford Herts | England | British | Managing Director | 127266390001 | ||||
EDGINGTON, Richard Alan | Amministratore | Ashleigh Main Road Great Haywood ST18 0SU Stafford | England | British | Managing Director | 81884240001 | ||||
FAULKNER, Jeffrey Dean | Amministratore | 1 The Cherries Euxton PR7 6NG Chorley Lancashire | British | Director | 77563410003 | |||||
FLOOD, Robert William | Amministratore | Cloisters Road Winterbourne BS33 1QP Bristol Brinksworth Leaze | England | British | Managing Director | 134877050001 | ||||
FOULKES, Christopher Andrew | Amministratore | 76 Muirhill Limpley Stoke BA2 7FB Bath Avon | United Kingdom | British | None | 33941280001 | ||||
FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe | Amministratore | 17 Derwent Road AL5 3PA Harpenden Hertfordshire | England | British | Managing Director | 48396030001 | ||||
GREEN, Robert David | Amministratore | 11 Whitworth Lane Loughton MK5 8EB Milton Keynes | England | British | Director | 76720550003 | ||||
GREENING, Malcolm David | Amministratore | 181 Burley Lane Quarndon DE22 5JS Derby Derbyshire | British | Company Director | 58648450001 | |||||
GRIFFITHS, Melvyn Robert | Amministratore | Bethal House Pytchley Court Crown Lane NN6 7AL West Haddon Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 113395580001 | ||||
HATCH, Christopher John | Amministratore | 19 Welwyn Hall Gardens AL6 9LF Welwyn Hertfordshire | British | Company Director | 50577850006 | |||||
HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 257671040002 | ||||
HOLLAND-KAYE, William John | Amministratore | 39 Britannia Road SW6 2HJ London | British | Managing Director | 110518040001 | |||||
JOHNSON, Peter Thomas | Amministratore | 34 Homewood Road AL1 4BQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Accountant | 8895880004 | ||||
KENRICK, Joanne Louise | Amministratore | Flat 9 53 Rosslyn Hill Hampstead NW3 5UH London | British | Director | 75636150002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WILSON CONNOLLY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Connolly Holdings Limited | 06 apr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
WILSON CONNOLLY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 03 lug 2009 Consegnato il 16 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each guarantor or borrower or chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. 34 turnpike road, red lodge, freckenahm part t/no SK80912. Insurances and other contracts see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 27 ott 2003 Consegnato il 30 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3,308,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The freehold land situated at upton rocks widnes chesire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 24 ott 2003 Consegnato il 30 ott 2003 | In corso | Importo garantito £2,450,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The freehold land and premises known as part of nunnery fields hospital nunnery fields canterbury kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 21 ott 2003 Consegnato il 28 ott 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The whole of the l/h land being 146 orrell road, orrell t/no GM607707. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 set 2003 Consegnato il 11 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land at wychwood village, crewe, cheshire,. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 06 ago 2003 Consegnato il 13 ago 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h property situate and k/a coryton house 27 pendwyallt road coryton cardiff. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 lug 2003 Consegnato il 09 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,908,750.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All that f/h property situate at manor farm crescent off brook way bradley stoke south glos containing approx 7.6 acres. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 giu 2003 Consegnato il 24 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The freehold land known as and forming part of woodlands memorial ground blackpool road ansdell lytham st annes. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 mag 2003 Consegnato il 03 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3,429,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land on the east side of southend road hornchurch essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 apr 2003 Consegnato il 10 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land comprising old stowupland park stowmarket suffolk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 apr 2003 Consegnato il 03 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land comprising old stowupland park, stowmarket, suffolk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 apr 2003 Consegnato il 29 apr 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Scholes park farm and scholes lodge farm scholes leeds west yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 23 apr 2003 Consegnato il 01 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The sum of £2,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H property k/a the woodlands park hotel wellington road timperley cheshire t/no: GM171621. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 apr 2003 Consegnato il 16 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that freehold property under t/n's CH423380 and CH423391 and the rights interest and estate in the land described in the statutory declarations of david stone and derek nuttall dated 25 march 2003. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 apr 2003 Consegnato il 16 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the northwich victoria football club company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that freehold property known as or being the football stadium and land at the drill field northwich cheshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 mar 2003 Consegnato il 09 apr 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the land at medway trading estate hart street maidstone kent t/no K583305. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 mar 2003 Consegnato il 29 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito One million six hundred thousand pounds (£1,600,000) due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land on the south east side of hart street, maidstone, kent t/n K583305. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 dic 2002 Consegnato il 06 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £21,660,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land at orsett hospital rowley road basildon essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 ott 2002 Consegnato il 08 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £750,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land to the rear of tidings hill halstead essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 ago 2002 Consegnato il 31 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property k/a land to the south of clay lane, fishbourne, nr chichester, west sussex t/no. WSX257370. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 giu 2002 Consegnato il 18 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land at county way, trowbridge, wiltshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 22 mag 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land at lee mill,ivybridge,devon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 apr 2002 Consegnato il 02 mag 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land lying to the south of codicote road, wheathampstead, hertfordshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 mar 2002 Consegnato il 26 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land and buildings on the north east side of carver street, birmingham, forming part of the land t/n WM467585. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 21 dic 2001 Consegnato il 04 gen 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that freehold land lying to the south of codicote road wheathampstead hertfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0