WILSON CONNOLLY LIMITED

WILSON CONNOLLY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILSON CONNOLLY LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00244804
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di WILSON CONNOLLY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILCON HOMES LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    WILCON CONSTRUCTION LIMITED02 gen 193002 gen 1930

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILSON CONNOLLY LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al03 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma17 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al03 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Michael Andrew Lonnon come segretario in data 09 dic 2024

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Sayed Suleiman Ashrafi come segretario in data 09 dic 2024

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 24 apr 2024

    1 pagineTM01

    Nomina di Jennifer Canty come amministratore in data 24 apr 2024

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2024 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin come amministratore in data 09 ott 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 09 ott 2023

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    13 pagineAA

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 55

    2 pagineMR05

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    15 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Colin Richard Clapham come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come amministratore in data 31 ott 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Ian Graham Connor come amministratore in data 25 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sarah Judith Thornley come amministratore in data 25 ott 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASHRAFI, Sayed Suleiman
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    330347940001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    CONNOR, Ian Graham
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193626080001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Segretario
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    LAWTHER, Samuel David
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460012
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British34521340004
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    STOTE, Tanya
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    British113603590001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BANNISTER, William Henry
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishDirector58990140003
    BEAL, Ian Paul
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    Amministratore
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    BritishDirector71260780003
    BELL, Darren
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Amministratore
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    United KingdomBritishManaging Director73256080001
    BENSON, Deborah Clare
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    BritishManaging Director52845300004
    BLACK, Ian Craig
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    Amministratore
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant4579780003
    BROOMFIELD, Matthew
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector80131820001
    BURGESS, Alan Robert
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director79587600001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CHANDRAN, Vikranth
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    Amministratore
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant139652640001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    COKER, John Edwin
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director100513680001
    DICKERSON, Graham Leslie
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    Amministratore
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    EnglandBritishManaging Director127266390001
    EDGINGTON, Richard Alan
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    Amministratore
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    EnglandBritishManaging Director81884240001
    FAULKNER, Jeffrey Dean
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    BritishDirector77563410003
    FLOOD, Robert William
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    Amministratore
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    EnglandBritishManaging Director134877050001
    FOULKES, Christopher Andrew
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    Amministratore
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    United KingdomBritishNone33941280001
    FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director48396030001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Amministratore
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    GREENING, Malcolm David
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director58648450001
    GRIFFITHS, Melvyn Robert
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector113395580001
    HATCH, Christopher John
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director50577850006
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    HOLLAND-KAYE, William John
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    Amministratore
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    BritishManaging Director110518040001
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    KENRICK, Joanne Louise
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    Amministratore
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    BritishDirector75636150002

    Chi sono le persone con controllo significativo di WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione832629
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WILSON CONNOLLY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 03 lug 2009
    Consegnato il 16 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each guarantor or borrower or chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. 34 turnpike road, red lodge, freckenahm part t/no SK80912. Insurances and other contracts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited (the Security Agent) as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 16 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 01 lug 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 04 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 27 ott 2003
    Consegnato il 30 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,308,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The freehold land situated at upton rocks widnes chesire.
    Persone aventi diritto
    • The Council of the Borough of Halton
    Transazioni
    • 30 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 30 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    £2,450,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold land and premises known as part of nunnery fields hospital nunnery fields canterbury kent.
    Persone aventi diritto
    • East Kent Hospitals National Health Service Trust
    Transazioni
    • 30 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 21 ott 2003
    Consegnato il 28 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole of the l/h land being 146 orrell road, orrell t/no GM607707.
    Persone aventi diritto
    • Steven John Burness and Rita Ann Burness
    Transazioni
    • 28 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 11 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at wychwood village, crewe, cheshire,.
    Persone aventi diritto
    • Countryside Properties PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property situate and k/a coryton house 27 pendwyallt road coryton cardiff.
    Persone aventi diritto
    • Royal Mail Group PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 2003
    Consegnato il 09 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,908,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that f/h property situate at manor farm crescent off brook way bradley stoke south glos containing approx 7.6 acres.
    Persone aventi diritto
    • South Gloucestershire District Council
    Transazioni
    • 09 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 24 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold land known as and forming part of woodlands memorial ground blackpool road ansdell lytham st annes.
    Persone aventi diritto
    • Fylde Rugby Union Football Club Limited
    Transazioni
    • 24 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 03 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,429,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land on the east side of southend road hornchurch essex.
    Persone aventi diritto
    • Maylands Green Estate Co Limited & Romford Construction Company Limited
    Transazioni
    • 03 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 2003
    Consegnato il 10 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land comprising old stowupland park stowmarket suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 2003
    Consegnato il 03 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land comprising old stowupland park, stowmarket, suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    Transazioni
    • 03 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Scholes park farm and scholes lodge farm scholes leeds west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Scholes Park Developments Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2022Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 2003
    Consegnato il 01 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £2,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a the woodlands park hotel wellington road timperley cheshire t/no: GM171621.
    Persone aventi diritto
    • Brian Norris Walker
    Transazioni
    • 01 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold property under t/n's CH423380 and CH423391 and the rights interest and estate in the land described in the statutory declarations of david stone and derek nuttall dated 25 march 2003. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northwich Victoria Football Club Company Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the northwich victoria football club company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold property known as or being the football stadium and land at the drill field northwich cheshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the land at medway trading estate hart street maidstone kent t/no K583305.
    Persone aventi diritto
    • Bernard Christopher Norman Roger Holmes
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 29 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    One million six hundred thousand pounds (£1,600,000) due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land on the south east side of hart street, maidstone, kent t/n K583305.
    Persone aventi diritto
    • Cathedral Medway Limited
    Transazioni
    • 29 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 06 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £21,660,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at orsett hospital rowley road basildon essex.
    Persone aventi diritto
    • Basildon and Thurrock General Hospitals National Health Service Trust
    Transazioni
    • 06 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ott 2002
    Consegnato il 08 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £750,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land to the rear of tidings hill halstead essex.
    Persone aventi diritto
    • G E Cook & Sons Limited
    Transazioni
    • 08 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 2002
    Consegnato il 31 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a land to the south of clay lane, fishbourne, nr chichester, west sussex t/no. WSX257370.
    Persone aventi diritto
    • Seaward Homes (South) Limited
    Transazioni
    • 31 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 2002
    Consegnato il 18 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at county way, trowbridge, wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Swan Hill Developments Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 22 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at lee mill,ivybridge,devon.
    Persone aventi diritto
    • Peter Joseph Cane and William John Cane
    Transazioni
    • 22 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 18 apr 2002
    Consegnato il 02 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land lying to the south of codicote road, wheathampstead, hertfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sainsbury's Supermarkets Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 26 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side of carver street, birmingham, forming part of the land t/n WM467585.
    Persone aventi diritto
    • Midland and City Limited, Baystone Associates Limited, and Lampol Developments Limited Togethertrading as Ppk Partnership
    Transazioni
    • 26 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 04 gen 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold land lying to the south of codicote road wheathampstead hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Sainsburys Supermarkets Limited
    Transazioni
    • 04 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0