CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00247624 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE CAPITAL PROJECTS LIMITED | 10 mag 2004 | 10 mag 2004 |
| MCALPINE CAPITAL PROJECTS LIMITED | 07 ott 2003 | 07 ott 2003 |
| ALFRED MCALPINE CONSTRUCTION LIMITED | 28 nov 1984 | 28 nov 1984 |
| SIR ALFRED MCALPINE & SON LIMITED | 25 apr 1930 | 25 apr 1930 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 apr 2019 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 01 mag 2019 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 apr 2018 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 23 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion (Am) Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 09 ago 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 2 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come segretario in data 25 giu 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 18 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Robin Herzberg come amministratore in data 18 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adam Green come amministratore in data 18 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Westley Maffei come segretario in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Francis George come segretario in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Hayward come amministratore in data 06 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 31 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio modificato di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AAMD | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Hayward il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORSTER, Garry James | Segretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Segretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| LEE, Christopher Michael | Segretario | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | 133709330001 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183610001 | |||||||
| MATTHEWS, Karen Margaret | Segretario | Avalon 12 Noctorum Avenue L43 9SA Birkenhead Merseyside | British | 38721010001 | ||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Westgate Noctorum Lane,Noctorum L43 9UA Wirral Merseyside | British | 1195620001 | ||||||
| PIRNIE, Christopher Robert | Segretario | 109a Queensway W2 4BS London | British | 65954860002 | ||||||
| ROUT, Peter John | Segretario | 82 Long Lane Aughton L39 5BN Ormskirk Lancashire | British | 40617960001 | ||||||
| SCURR, John Coan | Segretario | 5 The Croft Church Park Euxton PR7 6LH Chorley Lancashire | British | 3213200001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BALDWIN, Richard Keith, Dr | Amministratore | The Shaugh TN7 4DP Upper Hartfield East Sussex | United Kingdom | British | 37207590001 | |||||
| BLOOMFIELD, Paul Martin | Amministratore | 63 Motspur Park KT3 6PT New Malden Surrey | United Kingom | British | 58021150001 | |||||
| BLYTHEN, Robert Charles | Amministratore | The Laurels Pant Lane Gresford LL12 8HB Wrexham Clwyd | British | 8601540001 | ||||||
| BOOTH, Karen Jane | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| DEAS, David Thomson | Amministratore | Spruce Cottage CW4 8NP Goostrey Cheshire | British | 843170001 | ||||||
| DOCKERY, Joseph Edward | Amministratore | Steephurst Harestone Hill CR3 6BG Caterham Surrey | British | 6201520001 | ||||||
| DOUGHTY, Stuart John | Amministratore | Bradley Farm House Kinlet DY12 3BU Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 31394540001 | |||||
| GILL, Matthew Clement Hugh | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 160968480002 | |||||
| GOULSTON, Stephen | Amministratore | 28 Salisbury Road Blashford BH24 1AS Ringwood Hampshire | British | 92887410001 | ||||||
| GREEN, Adam Richard | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 129918780001 | |||||
| GREENWOOD, Mark | Amministratore | The Rubble Hole Little London Kings Court GL5 5DX Stroud | British | 98276400001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Amministratore | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HAYWARD, Alan | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HULMES, Peter Mcphee | Amministratore | 5 Badgers Close Christleton CH3 7BR Chester Cheshire | England | British | 17198990001 | |||||
| HUME, Jeffrey | Amministratore | 38 Burdon Lane SM2 7PT Cheam Surrey | United Kingdom | British | 58948740002 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Amministratore | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| JONES, Marcus Faughey | Amministratore | Lindridge House Forton Road TF10 7JR Newport Shropshire | England | British | 69189090002 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | 2 West Grove SE10 8QT London Flat 3 | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Amministratore | 153 Sneyd Lane Essington WV11 2DX Wolverhampton | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| MCALPINE, Robert James | Amministratore | Tilstone Lodge Tilstone Fearnall CW6 9HS Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 6627970001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Am) Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 01 apr 1980 Consegnato il 15 apr 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 | |
Brevi particolari Land at bulls cross farm bulls cross. Waltham cross. Herts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CARILLION CAPITAL PROJECTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0