NORTH BRITISH BUS LIMITED

NORTH BRITISH BUS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORTH BRITISH BUS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00248119
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORTH BRITISH BUS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NORTH BRITISH BUS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORTH BRITISH BUS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CROSVILLE MOTOR SERVICES LIMITED15 mag 193015 mag 1930

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH BRITISH BUS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per NORTH BRITISH BUS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park, Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mag 2012

    Stato del capitale al 04 mag 2012

    • Capitale: GBP 2,800,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 03 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 03 mag 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NORTH BRITISH BUS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Amministratore
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    DODD, John Hamilton
    Staplewood
    Nether Wallop
    SO20 8EQ Stockbridge
    Hampshire
    Segretario
    Staplewood
    Nether Wallop
    SO20 8EQ Stockbridge
    Hampshire
    British3919220001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    British67622780002
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MCENHILL, Peter Raymond
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Burroughs Hill
    Duck Lane, Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    British65346840001
    MILLS, Adam Francis
    The Old Vicarage
    Great Durnford
    SP4 6AZ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Great Durnford
    SP4 6AZ Salisbury
    Wiltshire
    British4058810001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    STANLEY, Richard Morgan Oliver, The Honourable
    Wood End House
    Ridgeway Lane
    SO41 8AA Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Wood End House
    Ridgeway Lane
    SO41 8AA Lymington
    Hampshire
    British37521320001
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish48937720001
    VANDERZEE, Robin Edward Charles
    Mulberry Barn Wolferstan Drive
    Bishopdown
    SP1 3XZ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Mulberry Barn Wolferstan Drive
    Bishopdown
    SP1 3XZ Salisbury
    Wiltshire
    British58224710001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    British2719600006

    NORTH BRITISH BUS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 15 giu 1995
    Consegnato il 28 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower to the first national bank of boston as agent and trustee for each of the beneficiaries (as defined in the deed) under the terms of the loan agreement and by the company to the first national bank of boston as agent and trustee for each of the beneficiaries (as defined in the deed) under the terms of the group guarantee (of even dates with the loan agreement and all supplemental agreements of it between the agent,the company and the charging guarantors) in the manner agreed under the loan agreement
    Brevi particolari
    25,000 ordinary shares of £1 each in arrowline (travel) limited and 2,000 ordinary non voting shares in arrowline (travel) limited as listed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston (The "Agent")
    Transazioni
    • 28 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 13 apr 1995
    Consegnato il 27 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower to the chargee under the terms of the loan agreement and by the company to the the first national bank of boston as agent and trustee for each of the beneficiaries (as defined in the deed) under the terms of the group guarantee (of even dates with the loan agreement and all supplemental agreements of it between the agent, the company and the charging guarantors) in the manner agreed under the loan agreement
    Brevi particolari
    The shares or other secuities deposited by the company with the agent and the company undertook that any bonus, stock or shares or other new securities of a similar nature which may at any time during the currency of the charge be issued in respect of the securities shall be deposited with or transfered to the agent or trustees for or nominees of the agent and shall thereupon become part of the securities and all rights monies or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option or otherwise in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston as Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries (Asdefined in the Deed)
    Transazioni
    • 27 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creato il 15 ago 1994
    Consegnato il 31 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 04 mag 1994
    Consegnato il 17 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston("the Agent")
    Transazioni
    • 17 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containg fixed and floating charges
    Creato il 10 dic 1992
    Consegnato il 16 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    01.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 dic 1992
    Consegnato il 14 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 14 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1992
    Consegnato il 15 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in clause 1.1.7. of the legal charge
    Brevi particolari
    Bus depot at delamere street, crewe, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Lynton PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental agreement
    Creato il 16 apr 1992
    Consegnato il 23 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 17TH july 1989 and this charge
    Brevi particolari
    Bus depot at delamere street, crewe, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Lynton PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 mag 1989
    Consegnato il 23 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see more 395 - M532C-. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston.
    Transazioni
    • 23 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 mar 1988
    Consegnato il 13 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from A.T. L. (western) limited to the chargee onany account whatsoever.
    Brevi particolari
    The properties specified on form M395, together with fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. (See form M395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston.
    Transazioni
    • 13 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NORTH BRITISH BUS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0