NORTH BRITISH BUS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NORTH BRITISH BUS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00248119 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NORTH BRITISH BUS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NORTH BRITISH BUS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NORTH BRITISH BUS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CROSVILLE MOTOR SERVICES LIMITED | 15 mag 1930 | 15 mag 1930 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH BRITISH BUS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per NORTH BRITISH BUS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park, Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 14 set 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Turner come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 03 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 03 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NORTH BRITISH BUS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Segretario | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Amministratore | Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 | England | British | 161250030001 | |||||
| DODD, John Hamilton | Segretario | Staplewood Nether Wallop SO20 8EQ Stockbridge Hampshire | British | 3919220001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Segretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| WATT, Gordon George | Segretario | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | British | 67622780002 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Segretario | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BAYFIELD, Stephen | Amministratore | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| JONES, Michael Adrian | Amministratore | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Amministratore | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Amministratore | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MCENHILL, Peter Raymond | Amministratore | Burroughs Hill Duck Lane, Laverstock SP1 1PU Salisbury Wiltshire | British | 65346840001 | ||||||
| MILLS, Adam Francis | Amministratore | The Old Vicarage Great Durnford SP4 6AZ Salisbury Wiltshire | British | 4058810001 | ||||||
| RAY, John Alfred | Amministratore | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| STANLEY, Richard Morgan Oliver, The Honourable | Amministratore | Wood End House Ridgeway Lane SO41 8AA Lymington Hampshire | British | 37521320001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 48937720001 | |||||
| VANDERZEE, Robin Edward Charles | Amministratore | Mulberry Barn Wolferstan Drive Bishopdown SP1 3XZ Salisbury Wiltshire | British | 58224710001 | ||||||
| WATT, Gordon George | Amministratore | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | 67622780002 | |||||
| WILLIAMS, Dawson Thomas | Amministratore | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | 2719600006 |
NORTH BRITISH BUS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creato il 15 giu 1995 Consegnato il 28 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower to the first national bank of boston as agent and trustee for each of the beneficiaries (as defined in the deed) under the terms of the loan agreement and by the company to the first national bank of boston as agent and trustee for each of the beneficiaries (as defined in the deed) under the terms of the group guarantee (of even dates with the loan agreement and all supplemental agreements of it between the agent,the company and the charging guarantors) in the manner agreed under the loan agreement | |
Brevi particolari 25,000 ordinary shares of £1 each in arrowline (travel) limited and 2,000 ordinary non voting shares in arrowline (travel) limited as listed in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 13 apr 1995 Consegnato il 27 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each borrower to the chargee under the terms of the loan agreement and by the company to the the first national bank of boston as agent and trustee for each of the beneficiaries (as defined in the deed) under the terms of the group guarantee (of even dates with the loan agreement and all supplemental agreements of it between the agent, the company and the charging guarantors) in the manner agreed under the loan agreement | |
Brevi particolari The shares or other secuities deposited by the company with the agent and the company undertook that any bonus, stock or shares or other new securities of a similar nature which may at any time during the currency of the charge be issued in respect of the securities shall be deposited with or transfered to the agent or trustees for or nominees of the agent and shall thereupon become part of the securities and all rights monies or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option or otherwise in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge and set-off over credit balances | Creato il 15 ago 1994 Consegnato il 31 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 04 mag 1994 Consegnato il 17 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture containg fixed and floating charges | Creato il 10 dic 1992 Consegnato il 16 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 01. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 10 dic 1992 Consegnato il 14 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 mag 1992 Consegnato il 15 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in clause 1.1.7. of the legal charge | |
Brevi particolari Bus depot at delamere street, crewe, cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental agreement | Creato il 16 apr 1992 Consegnato il 23 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 17TH july 1989 and this charge | |
Brevi particolari Bus depot at delamere street, crewe, cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 03 mag 1989 Consegnato il 23 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Please see more 395 - M532C-. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 25 mar 1988 Consegnato il 13 apr 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from A.T. L. (western) limited to the chargee onany account whatsoever. | |
Brevi particolari The properties specified on form M395, together with fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. (See form M395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
NORTH BRITISH BUS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0