FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED

FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00249180
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WHITECHAPEL CORPORATE SERVICES LIMITED23 gen 199823 gen 1998
    TRIMFARE (2) LIMITED18 feb 199418 feb 1994
    SYD ABRAMS LIMITED01 lug 193001 lug 1930

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 giu 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 dic 2010

    5 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    7 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 53-61 College Road Harrow Middlesex HA1 1FB in data 17 dic 2009

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 dic 2009

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FN SECRETARY LIMITED
    53-61 College Road
    HA1 1FB Harrow
    Middlesex
    Segretario
    53-61 College Road
    HA1 1FB Harrow
    Middlesex
    88740300002
    FIRST NATIONAL CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    53-61 College Road
    HA1 1FB Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    53-61 College Road
    HA1 1FB Harrow
    Middlesex
    79989520002
    FERRIS, Michael James
    Zitrey
    Cox Hill
    CM6 2HL Great Easton
    Essex
    Segretario
    Zitrey
    Cox Hill
    CM6 2HL Great Easton
    Essex
    British114444730001
    GALVIN, Martin Christopher
    1 Duke Street
    SK13 8JD Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    1 Duke Street
    SK13 8JD Glossop
    Derbyshire
    British16555430001
    PAWSON, Michael Andrew
    14 Laurence Court
    Woodlesford
    LS26 8QY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    14 Laurence Court
    Woodlesford
    LS26 8QY Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector8181070001
    SMYTH, Margaret
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director74350280001
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Segretario
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    ABRAMS, Brian
    18 Wentworth Avenue
    Whitefield
    M45 7GQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    18 Wentworth Avenue
    Whitefield
    M45 7GQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director16555480001
    ABRAMS, Eric
    5 Wells Avenue
    Prestwich
    M25 0GN Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    5 Wells Avenue
    Prestwich
    M25 0GN Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director6655950001
    ABRAMS, Steven Mark
    33 Delahays Drive
    Hale
    WA15 8DR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    33 Delahays Drive
    Hale
    WA15 8DR Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director16555440001
    ABRAMS, Violet
    Flat 12 Devonshire Court
    New Hall Road
    M7 4JT Salford
    Lancashire
    Amministratore
    Flat 12 Devonshire Court
    New Hall Road
    M7 4JT Salford
    Lancashire
    BritishRetired3025280002
    HOCKEY MORLEY, Gary
    69 Westbury Road
    HA6 3DA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    69 Westbury Road
    HA6 3DA Northwood
    Middlesex
    BritishRetail Marketing Director78595520001
    PAWSON, Michael Andrew
    8 East Ridge View
    Garforth
    LS25 2PN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 East Ridge View
    Garforth
    LS25 2PN Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant8181070002
    SMYTH, Margaret
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Swansway
    Mereside Road, Mere
    WA16 6QR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director74350280001
    SMYTH, Michael
    Brookdale Brookbottom
    Riding Gate Harwood
    BL2 4DL Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Brookdale Brookbottom
    Riding Gate Harwood
    BL2 4DL Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director33134410001
    STUDHOLME, Dennis
    Moorlands 89 Chapeltown Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Moorlands 89 Chapeltown Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director13723760003
    TYLDSLEY, William Andrew
    Hermosa
    Troutbeck Close Hawkshaw
    BL8 4LJ Bury
    Greater Manchester
    Amministratore
    Hermosa
    Troutbeck Close Hawkshaw
    BL8 4LJ Bury
    Greater Manchester
    United KingdomBritishCompany Director36851690001

    FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 09 lug 1990
    Consegnato il 26 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and l/h land on the south west side of bury new road and sites of 207/217 and 217A, 219 and 221 bury new road salford greater manchester t/no:- la 64564 and la 70797. by way of a fixed charge over all the plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1988
    Consegnato il 30 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of f/h land and buildings at the rear of 153/187 barton lane eccles, salford greater manchester. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 20 ago 1987
    Consegnato il 01 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 01 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 12 giu 1987
    Consegnato il 24 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a consignment agreement dated 12.6.87
    Brevi particolari
    All the charger's interest (if any) in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any monies received therefor.
    Persone aventi diritto
    • P S a Wholesale Limited
    Transazioni
    • 24 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 1987
    Consegnato il 06 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a 276292 bury new road higher broughton salford greater manchester fixed charge plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 06 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 gen 1986
    Consegnato il 21 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 275000
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north east side or bury new road, higher broughton known as 276/292 bury new road, higher broughton, salford, greater manchester, title no. Gm 114471.
    Persone aventi diritto
    • B. Abramsthe Trustees of the Syd Abram Retirement Benefitt Scheme
    • E. Abramsthe Trustees of the Syd Abrams Retirement Benefi
    • Tt Scheme
    Transazioni
    • 21 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 nov 1983
    Consegnato il 22 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Company's right to receive payment or return of all money held for the company by general motors acceptance corporation (UK) limited.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 22 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 03 nov 1983
    Consegnato il 10 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment by the company to the charge of the companys right to receive repayments or return of all markets may from time to time be or become deu or owing to or reed for the company by gerarae motors acceptance corporation (UK) LTD. On the accounts maintained by the company the gmac or in respect of with in accordance with & subject to the terms of the buck deposit agreement between vauxhall motors LTD, gmac & the company.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited.
    Transazioni
    • 10 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 20 gen 1982
    Consegnato il 26 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing the moneys secured by a debenture dated 29TH march 1978.
    Brevi particolari
    All book debts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 ago 1978
    Consegnato il 29 ago 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the west of waterloo road, manchester, greater manchester. Title no la 70280 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bill os sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 29 ago 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 apr 1978
    Consegnato il 11 mag 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at waterloo rd cheetham manchester title no. La 59915 & la 70280 all estates or interest in any freehold or lease hold property of the company present & future, all stocks shares or other securities all book and other debts present future goodwill of the company floating charge undertaking and all other property and assets present & future.
    Persone aventi diritto
    • Brown, Shipley & Co. Limited
    Transazioni
    • 11 mag 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mar 1978
    Consegnato il 14 apr 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all the freehold and leasehold property of the company with all fixtures & fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant & machinery, first fixed charge on the goodwill and uncalled capital of the company and all other freehold & leashold property of the company. First floating charge on the undertaking and all other property & assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank Limited.
    Transazioni
    • 14 apr 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FIRST NATIONAL (TRIMFARE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 dic 2009Inizio della liquidazione
    26 ott 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    Grant Thornton
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Praticante
    Grant Thornton
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0