ENSEMBLE CLOTHING LIMITED

ENSEMBLE CLOTHING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENSEMBLE CLOTHING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00261096
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENSEMBLE CLOTHING LIMITED?

    • fabbricazione di altri indumenti per donne (14132) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ENSEMBLE CLOTHING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ZOLFO COOPER
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENSEMBLE CLOTHING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CCL CORPORATE WORKWEAR LIMITED03 dic 201203 dic 2012
    THE CO-OPERATIVE CLOTHING LIMITED05 mar 200805 mar 2008
    ROBERT HOWARTH LIMITED23 mag 198823 mag 1988
    ROBERT HOWARTH (NEW HEY) LIMITED14 dic 193114 dic 1931

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENSEMBLE CLOTHING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per ENSEMBLE CLOTHING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagine4.72

    Nomina di un liquidatore volontario

    9 pagine600

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 giu 2015

    20 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Terry George Stannard come amministratore in data 30 set 2014

    2 pagineTM01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Stephenson Road Stephenson Industrial Estate Washington Tyne and Wear NE37 3HR a C/O Zolfo Cooper the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB in data 28 gen 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 set 2014

    Stato del capitale al 23 set 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Cessazione della carica di Nicholas James O'donovan come amministratore in data 30 lug 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Wilkinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Nomina di Mr Nicholas James O'donovan come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Zoe Willingham come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Shane William Bray come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Terry George Stannard come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    21 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Co-Operative House Unit 3 Rutherford Road Stephenson Industrial Estate Washington Tyne and Wear NE37 3HX United Kingdom* in data 04 ott 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ott 2013

    Stato del capitale al 03 ott 2013

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ENSEMBLE CLOTHING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLEN, John Carl
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Segretario
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    179621220001
    ALLEN, John Carl
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Amministratore
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish132967150001
    BRAY, Shane William
    Granary Close
    Kibworth
    LE8 0HZ Leicester
    2
    England
    Amministratore
    Granary Close
    Kibworth
    LE8 0HZ Leicester
    2
    England
    EnglandBritish137331200001
    MARCHANT, Barry Guy
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Amministratore
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish129756410001
    PALMER, Simon Anthony
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Amministratore
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish166215030001
    WILLINGHAM, Zoe
    Poplar Hill
    IP14 2AX Stowmarket
    82
    Suffolk
    England
    Amministratore
    Poplar Hill
    IP14 2AX Stowmarket
    82
    Suffolk
    England
    EnglandBritish181958210001
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Segretario
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    SELLERS, Caroline Jane
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    Segretario
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    British45801060004
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    ALLAN, Stephen Murray
    89 Whitburn Road
    Cleadon
    SR6 7QY Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    89 Whitburn Road
    Cleadon
    SR6 7QY Sunderland
    Tyne & Wear
    British71153380001
    AUSTIN, Mike
    Heron Close
    Steeton
    BD20 6UN Keighley
    6
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Heron Close
    Steeton
    BD20 6UN Keighley
    6
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish128557010001
    CARROLL, James Mcardle
    2 Thropton Close
    Leam Lane
    NE10 8SP Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    2 Thropton Close
    Leam Lane
    NE10 8SP Gateshead
    Tyne & Wear
    British58842910001
    HOWARTH, Thomas James
    112 Woodplumpton Road
    Woodplumpton
    PR4 0LJ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    112 Woodplumpton Road
    Woodplumpton
    PR4 0LJ Preston
    Lancashire
    British27577930001
    HUGHES, Dennis Trevor
    7 Meadow Court
    Darrhhall Ponteland
    NE20 9RB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    7 Meadow Court
    Darrhhall Ponteland
    NE20 9RB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish109764460001
    MORGAN, Zoe Jeanette
    Pumphouse Lane
    B97 5PH Upper Bentley
    Raglis Cottage
    Worcestershire
    Amministratore
    Pumphouse Lane
    B97 5PH Upper Bentley
    Raglis Cottage
    Worcestershire
    EnglandBritish139424250001
    O'DONOVAN, Nicholas James
    Epworth Court
    Quorn
    LE12 8FR Loughborough
    10
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Epworth Court
    Quorn
    LE12 8FR Loughborough
    10
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish148050490002
    PRESCOTT, William Alan
    Woodlea 11 Wellington Road
    Atherton
    M49 9HE Manchester
    Amministratore
    Woodlea 11 Wellington Road
    Atherton
    M49 9HE Manchester
    British8101580001
    SCOTT, Claire Samantha
    c/o Co-Operative House
    Rutherford Road
    Stephenson Industrial Estate
    NE37 3HX Washington
    Unit 3
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Co-Operative House
    Rutherford Road
    Stephenson Industrial Estate
    NE37 3HX Washington
    Unit 3
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish146599070001
    SLOCOMBE, Paul Richard
    16 Doves Croft
    ME9 8LQ Tunstall
    Kent
    Amministratore
    16 Doves Croft
    ME9 8LQ Tunstall
    Kent
    British119988930001
    STANNARD, Terry George
    Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Larchwood
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Larchwood
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish140573740001
    TACON, Christine Mary
    Blakelow Farm
    Blakelow Road
    SK11 7ED Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Blakelow Farm
    Blakelow Road
    SK11 7ED Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish76748660003
    WILKINSON, Mark
    The Limes 57 Sutton Road
    NG17 8GY Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Limes 57 Sutton Road
    NG17 8GY Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    EnglandBritish58842860002
    WILSON, Brian Grant
    North View
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    North View
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish64217870001

    ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 03 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 02 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 23 nov 2012
    Consegnato il 30 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as the co-operative clothing limited or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, receivables, uncalled capital see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 23 nov 2012
    Consegnato il 28 nov 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Specialist Businesses Holdings Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 28 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)

    ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 gen 2015Inizio dell'amministrazione
    03 giu 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah O'Toole
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    03 giu 2015Inizio della liquidazione
    02 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah O'Toole
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Liquidatore proposto
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Liquidatore proposto
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Sarah O'Toole
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Liquidatore proposto
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0