CAPB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00262511
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPB LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAPB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    GRIFFINS
    Tavistock House South Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CA PREMIER BANKING LIMITED23 lug 200123 lug 2001
    ROBERT FLEMING & CO.LIMITED06 feb 193206 feb 1932

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CAPB LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2015

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2014

    10 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2 Triton Square Regent's Place London NW1 3AN* in data 20 giu 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ca premier banking LIMITED\certificate issued on 15/05/13
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name15 mag 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 26 apr 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Stato del capitale al 14 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    7 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Santander Secretariat Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Abbey National Nominees Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Derek John Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jessica Petrie come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Jessica Frances Petrie come amministratore

    3 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Shaun Patrick Coles il 10 nov 2011

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Scott Linsley come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per David Martin Green il 31 mag 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CAPB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3072288
    171739990001
    COLES, Shaun Patrick
    Triton Square
    Regents Place
    NW1 3AN London
    2
    Amministratore
    Triton Square
    Regents Place
    NW1 3AN London
    2
    United KingdomBritishCompany Secretary95706540002
    GREEN, David Martin
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant157202700001
    LEWIS, Derek John
    B01)
    Santander Uk Plc 2 Triton Square, Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretariat (Ts6
    United Kingdom
    Amministratore
    B01)
    Santander Uk Plc 2 Triton Square, Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretariat (Ts6
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary34423910002
    LIONE, Christine Amelia
    52 Addison Road
    E11 2RG London
    Segretario
    52 Addison Road
    E11 2RG London
    British65685130001
    STONE, Celia Eileen Susan
    170a Moor Lane
    Cranham
    RM14 1HE Upminster
    Essex
    Segretario
    170a Moor Lane
    Cranham
    RM14 1HE Upminster
    Essex
    British34397540002
    ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED
    2 Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    Abbey National House
    Segretario
    2 Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    Abbey National House
    133895950001
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Segretario
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    ROBERT FLEMMING CORPORATE SERVICES LIMITED
    10 Aldermanbury
    EC2V 7RF London
    Segretario
    10 Aldermanbury
    EC2V 7RF London
    75422360001
    ARCHIBALD, John Gordon
    Greenways
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    Amministratore
    Greenways
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    EnglandBritishMerchant Banker86989460001
    ARMSTRONG, Andrew Charles
    9 Royal Bay Apartments
    La Rue Horman, Grouville
    JE3 9EJ Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    9 Royal Bay Apartments
    La Rue Horman, Grouville
    JE3 9EJ Jersey
    Channel Islands
    BritishMerchant Banker77620750001
    ASHTON, Charles James
    Park Road
    CM8 3PS Rivenhall
    Rivenhall Place
    Essex
    Amministratore
    Park Road
    CM8 3PS Rivenhall
    Rivenhall Place
    Essex
    United KingdomBritishCorporate Finance139012420002
    BAINES, Michael George Coriat Talbot
    Pound Cottage
    Little Somerford
    SN15 5JW Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Pound Cottage
    Little Somerford
    SN15 5JW Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishInvestment Banker75994140001
    BALL, Simon Peter
    Glendalough 19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    Amministratore
    Glendalough 19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    BritishChief Finance Officer78766980001
    BANKS, William Lawrence
    Ridgebourne
    HR5 3EG Kington
    Herefordshire
    Amministratore
    Ridgebourne
    HR5 3EG Kington
    Herefordshire
    United KingdomBritishMerchant Banker36083600002
    BARTON, Malcolm Peter Speight
    Sydenhams
    GL6 7BU Bisley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Sydenhams
    GL6 7BU Bisley
    Gloucestershire
    United KingdomBritishInvestment Banker45376130004
    BRADLEY, Philip Herbert Gilbert
    30 Smith Terrace
    SW3 4DH London
    Amministratore
    30 Smith Terrace
    SW3 4DH London
    EnglandIrishCorporate Finance Executive30045470002
    BREAME, John Alan
    42 Ruskin Drive
    BR6 9RR Orpington
    Kent
    Amministratore
    42 Ruskin Drive
    BR6 9RR Orpington
    Kent
    BritishDirector Treasury30045480001
    BRIANT, Julian Gerard Hugh
    Little Tylers 26 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Amministratore
    Little Tylers 26 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    BritishCorporate Finance Director58558290001
    BROWN, Adam David
    25 Parkside
    AL6 9DQ Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    25 Parkside
    AL6 9DQ Welwyn
    Hertfordshire
    BritishInvestment Banker52863320001
    BRUCE, James Henry Morys
    1 St. Peters Square
    W1 9AB London
    Amministratore
    1 St. Peters Square
    W1 9AB London
    BritishMerchant Banker94088510001
    BRYAN, Jonathan Paul
    36 First Avenue
    HP7 9BL Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    36 First Avenue
    HP7 9BL Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglishStock Lending Director38599520001
    BURKE, Andrew Lindsay
    25 Kilmaine Road
    SW6 7JU London
    Amministratore
    25 Kilmaine Road
    SW6 7JU London
    United KingdomIrishBanker43083790001
    BUTT, Nicholas Alec Geoffrey
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    Amministratore
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    BritishCorporate Financier30045500001
    BUTT, Nicholas Alec Geoffrey
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    Amministratore
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    BritishCorporate Financier30045500001
    CHAMBERS, Antony Craven
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishBanker94516690001
    CHWEIDAN, Russell
    Kilbrachen 6 Meadway Close
    NW11 7BA London
    Amministratore
    Kilbrachen 6 Meadway Close
    NW11 7BA London
    BritishBanker47267810002
    COALES, William Oliver Alexander
    32 Stockwell Park Road
    SW9 0AJ London
    Amministratore
    32 Stockwell Park Road
    SW9 0AJ London
    EnglandBritishCorporate Financier41286830001
    COLE, Jonathan Mark
    38 Norroy Road
    Putney
    SW15 1PF London
    Amministratore
    38 Norroy Road
    Putney
    SW15 1PF London
    BritishBanker47267770001
    CONNOR, Janet
    Cavanaghs Cottage
    18 Bedford Road
    NN7 1DR Denton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Cavanaghs Cottage
    18 Bedford Road
    NN7 1DR Denton
    Northamptonshire
    BritishRetail Marketing Director77312440001
    CONSTABLE, Peter John
    38 Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    38 Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    BritishInvestment Banker4562100001
    COOPER, Robert Hamilton
    5 Farrington Place
    BR7 6BE Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    5 Farrington Place
    BR7 6BE Chislehurst
    Kent
    BritishMerchant Banker11632250001
    COTTRELL, Christopher
    Tickners Ravenscroft Farm Spode Lane
    Cowden
    TN8 7HW Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Tickners Ravenscroft Farm Spode Lane
    Cowden
    TN8 7HW Edenbridge
    Kent
    BritishBusiness Manager53152470001
    CRAIG, Colin James
    3 Kersley Street
    Battersea
    SW11 4PR London
    Amministratore
    3 Kersley Street
    Battersea
    SW11 4PR London
    BritishDirector/Middle East Business7793240001
    DAVIS, Roger William John
    Maytree House
    161 Clarence Road
    SL4 5AP Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Maytree House
    161 Clarence Road
    SL4 5AP Windsor
    Berkshire
    BritishCorporate Financier77101740001

    CAPB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security deed
    Creato il 22 giu 2000
    Consegnato il 05 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of security
    Creato il 03 dic 1999
    Consegnato il 23 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a participation agreement of even date or this charge
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's right title and interest in the following: a loan agreement dated 3/12/99, a debenture dated 20/5/97, a rental income account assignment dated 3/12/99 and others as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 23 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 23 set 1999
    Consegnato il 01 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts obligations and liabilities due or to become due from the company and/or the nominee to the chargee on any account whatsoever out of or in connection with the facility agreement ; the security deed or any assured payment by the bank (all as defined in the deed)
    Brevi particolari
    All sums and payments now and from time to time hereafter receivable by the nominee or for the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Declaration of pledge of securities and claims
    Creato il 22 dic 1997
    Consegnato il 29 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A.and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A.banque generale du luxembourg S.A.banque internationale a luxembourg S.A.credit commercial de france kredietbank N.V.kredietbank S.A.luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Brevi particolari
    (I) all present and future securities, bonds, notes, certificates of deposit, instruments or rights representing property rights or claims (including a right not represented by a writing) as well as all other debentures which may be pledged in the same form as securities according to luxemborg law ("securities");. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Bruxelles Lambert S.A.
    • Banque Generale Du Luxemborg S.A.
    • Citibank N.A.
    • Union Bank of Switzerlandthe Composition of the Syndicate May Periodically Change and the Term Guarantor Refers to the Syndicate of Banks from Time to Time
    • The Guarantormeaning a Syndicate of Banks Whose Lead Bank Iscitibank N.A. Brussels Branch, and Whose Members Include:
    • Kredietbank N.V.
    • Banque Internationale a Luxemborg S.A
    • Credit Commercial De France
    • Kredietbank S.A. Luxemburgeoise
    Transazioni
    • 29 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 11 mag 1990
    Consegnato il 24 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with & held by the chargee in the account (s) in the name of the company in the books of the chargee denominated "adr pre-release collateral account(s)" together with the debts arising there from or in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 24 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 11 mag 1990
    Consegnato il 24 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the security agreement
    Brevi particolari
    All adrs which are at the date of the security agreement or might at any time thereafter be in or which might at any time thereafter be delivered into, the possession of the chargee or that of its agents, representatives or correspondents & held for the account of the company (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 24 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collaleral agreement
    Creato il 21 feb 1989
    Consegnato il 27 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All collateral:- being all of the borrowers right title at interest in and to all securities clearance accounts (see form 395 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 27 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 mag 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 25 lug 1988
    Consegnato il 26 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transazioni
    • 26 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 apr 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAPB LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2013Inizio della liquidazione
    27 ago 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Ashley Goldfarb
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    Praticante
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0