VERIPLAST UK LIMITED

VERIPLAST UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVERIPLAST UK LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00264527
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VERIPLAST UK LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VERIPLAST UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VERIPLAST UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MONO CONTAINERS LIMITED15 apr 193215 apr 1932

    Quali sono gli ultimi bilanci di VERIPLAST UK LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2013
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2014
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per VERIPLAST UK LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 mar 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 mar 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per VERIPLAST UK LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per VERIPLAST UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagineREST-CVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    10 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 apr 2016

    10 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Point Westgate Leeds West Yorkshire LS1 2AX a 29 Park Square West Leeds LS1 2PQ in data 29 mar 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 apr 2015

    11 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2014

    Stato del capitale al 24 mar 2014

    • Capitale: GBP 6,861,168
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX United Kingdom* in data 28 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    21 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 ott 2011

    • Capitale: GBP 6,861,168
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Bilancio redatto al 03 apr 2011

    20 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Veriplast International Dragonville Estate Durham Co Durham DH1 2RL* in data 30 nov 2011

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2012 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Nomina di Dieter Bergner come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philipe Langelier come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 28 mar 2010

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Philipe Andre Rene Langelier come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di VERIPLAST UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HART, Christopher
    Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    29
    Segretario
    Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    29
    British135520940001
    BERGNER, Dieter
    Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    29
    Amministratore
    Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    29
    GermanyDutch161017630001
    HART, Christopher
    Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    29
    Amministratore
    Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    29
    NetherlandsBritish135520940002
    DAWSON, Stephen Robin
    Malita
    Rickmanhill Road
    CR5 3LA Chipstead
    Surrey
    Segretario
    Malita
    Rickmanhill Road
    CR5 3LA Chipstead
    Surrey
    British102972940001
    GRANVILLE, Stephen Geoffrey
    27 Lunedale Avenue
    Tollesby
    TS5 7LA Middlesbrough
    Segretario
    27 Lunedale Avenue
    Tollesby
    TS5 7LA Middlesbrough
    British81158220001
    MCKAY, William Trevor
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    Segretario
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    British588890001
    AUGEREAU, Jean Michel
    Poseidon
    Michaels Field
    SA3 4JB Mumbles
    Swansea
    Amministratore
    Poseidon
    Michaels Field
    SA3 4JB Mumbles
    Swansea
    French81842280001
    BERNARD, Gilles
    20 Allee De L'Enclos
    38240
    Meylan
    France
    Amministratore
    20 Allee De L'Enclos
    38240
    Meylan
    France
    French133876950001
    BRIAN, Malcolm
    Edgewood Red Lane
    OX9 4BN Chinnor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Edgewood Red Lane
    OX9 4BN Chinnor
    Oxfordshire
    British29415320001
    CATERER, Ian John
    Woodlea Percy Lane
    DH1 4HE Durham
    Amministratore
    Woodlea Percy Lane
    DH1 4HE Durham
    British62124850001
    CLARKSON, Philip
    5 Ingham Terrace
    NE41 8DS Wylam
    Northumberland
    Amministratore
    5 Ingham Terrace
    NE41 8DS Wylam
    Northumberland
    British65589500001
    COUSERGUE, Cyrille
    8 Rue De La Plaine, 95600
    Aubonne
    France
    Amministratore
    8 Rue De La Plaine, 95600
    Aubonne
    France
    French131156700001
    CUNLIFFE, Andrew Harvey
    Easter Cottage
    27 Cedar Street
    LE15 8QS Braunston
    Leicestershire
    Amministratore
    Easter Cottage
    27 Cedar Street
    LE15 8QS Braunston
    Leicestershire
    EnglandBritish103722290001
    DAVEY, Michael John
    225 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    Amministratore
    225 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LE London
    United KingdomBritish976330001
    DAWSON, Stephen Robin
    Malita
    Rickmanhill Road
    CR5 3LA Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Malita
    Rickmanhill Road
    CR5 3LA Chipstead
    Surrey
    EnglandBritish102972940001
    EDWARDS, David Michael
    3 Highgate
    DH1 4GA Durham
    Amministratore
    3 Highgate
    DH1 4GA Durham
    British85213540001
    EDWARDS, David Michael
    3 Highgate
    DH1 4GA Durham
    Amministratore
    3 Highgate
    DH1 4GA Durham
    British85213540001
    GOMEZ, Raul Pacios
    8 Rue Claude Debussy
    Essert
    90850
    France
    Amministratore
    8 Rue Claude Debussy
    Essert
    90850
    France
    Spanish120034790001
    GRANVILLE, Stephen Geoffrey
    27 Lunedale Avenue
    Tollesby
    TS5 7LA Middlesbrough
    Amministratore
    27 Lunedale Avenue
    Tollesby
    TS5 7LA Middlesbrough
    British81158220001
    HALL, Elaine
    20 Homedale
    NE42 5AN Prudhoe
    Northumberland
    Amministratore
    20 Homedale
    NE42 5AN Prudhoe
    Northumberland
    British34561000003
    KELLY, Ronald
    22 Meadow View
    SL7 3PA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Meadow View
    SL7 3PA Marlow
    Buckinghamshire
    British8649490001
    KEY, John Michael, Dr.
    10 Chapmans Court
    Catterick Village
    DL10 7UE Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Chapmans Court
    Catterick Village
    DL10 7UE Richmond
    North Yorkshire
    EnglandBritish105107140001
    LANGELIER, Philipe Andre Rene
    Le Garay De La Croix
    Monistrol Sur Loire
    43 120
    France
    Amministratore
    Le Garay De La Croix
    Monistrol Sur Loire
    43 120
    France
    FranceFrench158292670001
    LANGLANDS, Gary Ronald
    121 Kinloch Street
    DD7 7HE Carnoustie
    Angus
    Scotland
    Amministratore
    121 Kinloch Street
    DD7 7HE Carnoustie
    Angus
    Scotland
    British43148240001
    MASSON, Eric Marcel Marie Jacques
    18 Allee Du Gaillet
    Meyland
    38240
    France
    Amministratore
    18 Allee Du Gaillet
    Meyland
    38240
    France
    French120035220001
    MITCHELL, James
    61 Windsor Drive
    Cleadon Village
    SR6 7SU Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    61 Windsor Drive
    Cleadon Village
    SR6 7SU Sunderland
    Tyne & Wear
    British43848360001
    MITCHELL, Philip Garnet
    Cherry Tree Close Pannal Ash Road
    HG2 9AL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Cherry Tree Close Pannal Ash Road
    HG2 9AL Harrogate
    North Yorkshire
    British8512990001
    O'CONNOR, William
    14 Lancaster Avenue
    M46 9EJ Atherton
    Greater Manchester
    Amministratore
    14 Lancaster Avenue
    M46 9EJ Atherton
    Greater Manchester
    United KingdomBritish85145420001
    O'LEARY, Mark Joseph Christopher
    14 Meadow View
    SL7 3PA Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Amministratore
    14 Meadow View
    SL7 3PA Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Irish43800040002
    RIMELL, Peter John
    Elmfield The Lendings
    Starforth
    DL12 9AB Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    Elmfield The Lendings
    Starforth
    DL12 9AB Barnard Castle
    County Durham
    British42214300002
    ROBINSON, John David, Dr
    The Grove Cadger Bank
    Lanchester
    DH7 0HD Durham
    County Durham
    Amministratore
    The Grove Cadger Bank
    Lanchester
    DH7 0HD Durham
    County Durham
    British24895080001
    SCHMITT, Remy
    10 Boulevard Emile Augier, 75016
    Paris
    France
    Amministratore
    10 Boulevard Emile Augier, 75016
    Paris
    France
    French131156740001
    SMADJA, Olivier Georges
    3 Rue De Planit
    FOREIGN Sainte Foy Les Lyon
    69110
    France
    Amministratore
    3 Rue De Planit
    FOREIGN Sainte Foy Les Lyon
    69110
    France
    French100503720001
    TOMASOV, Thierry
    9 Avenue Bedoyere
    Garches
    92380
    France
    Amministratore
    9 Avenue Bedoyere
    Garches
    92380
    France
    FranceFrench101382570003
    WALFORD, Anthony William Cecil
    Toque House Salters Meadow
    Beacon Hill
    HP10 8NH Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Toque House Salters Meadow
    Beacon Hill
    HP10 8NH Penn
    Buckinghamshire
    British2198510001

    VERIPLAST UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 25 mar 2010
    Consegnato il 03 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any obligor to the chargee
    Brevi particolari
    F/H properties k/a land and buildings on the east side of dragon lane dragonville industrial estate durham t/n DU127705 land lying to the north east of the A181 dragonville durham t/n DU161927 and land lying to the east of dragon lane gilesgate moor t/n DU118937 and all rights and interest in all plant and equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 03 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 2010
    Consegnato il 01 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the east side of dragon lane dragonville industrial estate durham t/no DU127705, f/h land lying to the north east of the A181 dragonville durham t/no DU161927, f/h land lying to the east side of dragon lane gilesgate moor t/no DU118937; right and interest in all plant and equipment. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bmo Capital Markets Financing, Inc.
    Transazioni
    • 01 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 05 mar 2010
    Consegnato il 12 mar 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 24 gen 2007
    Consegnato il 03 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligiors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charges all its securities,all loan capital,all amounts realised,all its diocuments of title. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 03 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bnp Paribas as Security Agent and Including Its Successors and Any Permitted Transferees
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creato il 16 dic 2005
    Consegnato il 29 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge entire right title and interest in and to the deposit and all rights and benefits accruing to or arisng in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession to a debenture dated 2 july 2004
    Creato il 02 ago 2004
    Consegnato il 10 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to a) the real property b) the tangible moveable property c) the accounts d) the intellectual property e) any goodwill. Assigns a) the proceeds of any insurance policy and all related rights b) all rights and claims in relation to any assigned account. By way of floating charge the assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 10 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 ago 2004
    Consegnato il 05 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the comapny to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at pikelaw place skelmersdale lancashire t/no LA508640 and LA508641 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 05 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 31 mar 1987
    Consegnato il 14 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Inter-company letter of set off
    Creato il 01 ago 1983
    Consegnato il 18 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 14 apr 1981
    Consegnato il 21 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings on the far east side of dragon lane, dragonville estate, durham title no. Du 65505.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage of chattels
    Creato il 31 mar 1981
    Consegnato il 06 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £42,574
    Brevi particolari
    New van damlid printing line model 4600L serial no. 01/10/0-4. vacuum wheel universal restacker with variable speed drive & control set of 4 wheels, counter ejector serial no. 501/04/0/18.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 05 gen 1981
    Consegnato il 06 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Huskey model T388P two stage, injection moulding machine. Husky, container stacker consisting of:- in-press conveyor vibratory feed through elevating conveyor, counting chute storage table, serial no. 6247 and charge by way of legal mortgage insofar as such goods & fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Limited.
    Transazioni
    • 06 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 13 mar 1980
    Consegnato il 13 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets preent and future including goodwill bookdebts and uncalled capital. (See doc M145).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1980Registrazione di un'ipoteca

    VERIPLAST UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 apr 2014Inizio della liquidazione
    26 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Frederick Wilson
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    Praticante
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0