LIMCO GPE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LIMCO GPE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00264964 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LIMCO GPE LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova LIMCO GPE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 33 Cavendish Square London W1G 0PW |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LIMCO GPE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LIMCO GPE PUBLIC LIMITED COMPANY | 17 apr 2013 | 17 apr 2013 |
| LIMCO GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 01 mar 1982 | 01 mar 1982 |
| LONDON INVESTMENT & MORTGAGE CO.LIMITED(THE) | 29 apr 1932 | 29 apr 1932 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LIMCO GPE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per LIMCO GPE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 19 apr 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome e ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT11 | ||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 13 pagine | MAR | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata | 2 pagine | RR02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicholas James Sanderson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Drakesmith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Thompson il 30 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Timon Drakesmith il 30 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Toby Augustine Courtauld il 30 lug 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LIMCO GPE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Desna Lee | Segretario | 33 Cavendish Square London W1G 0PW | British | 62162550004 | ||||||
| COURTAULD, Toby Augustine | Amministratore | 33 Cavendish Square London W1G 0PW | United Kingdom | British | 46882260005 | |||||
| SANDERSON, Nicholas James | Amministratore | 33 Cavendish Square London W1G 0PW | United Kingdom | British | 160806430001 | |||||
| THOMPSON, Neil | Amministratore | 33 Cavendish Square London W1G 0PW | United Kingdom | British | 114074230001 | |||||
| BARRETT, Christopher Jeremy Richard | Segretario | Flat 17 18 Broad Court WC2B 5QU London | British | 14920070001 | ||||||
| FRYER, Carolyn Jane | Segretario | 8 Bracken Close Farnham Common SL2 3JP Slough Buckinghamshire | British | 18355770002 | ||||||
| DRAKESMITH, Nicholas Timon | Amministratore | 33 Cavendish Square London W1G 0PW | England | British | 30973710004 | |||||
| GITTENS, Paul Alexander | Amministratore | 29 Woodland Way Woodford Wells IG8 0QQ Woodford Essex | British | 14920090001 | ||||||
| HALL, Patrick Oliver | Amministratore | The Old Farm House West Park Farm Corston SN16 0HH Malmesbury Wiltshire | United Kingdom | British | 28459940001 | |||||
| NOEL, Robert Montague | Amministratore | 19 Tedworth Square SW3 4DR London | England | British | 31743030007 | |||||
| PESKIN, Richard Martin | Amministratore | 41 Circus Road St Johns Wood NW8 9JH London | England | British | 35018930001 | |||||
| SHAW, Peter David Marley | Amministratore | Worth Cottage 9 Batchworth Heath WD3 1QB Rickmansworth Hertfordshire | British | 74197750001 | ||||||
| TAYLORSON, John Albert | Amministratore | 28 Viewpoint Sandbourne Road Alum Chyne BH4 8JP Bournemouth | British | 15287140002 | ||||||
| WHITELEY, John Howard | Amministratore | 14 Fallows Green AL5 4HD Harpenden Hertfordshire | England | British | 48980090002 |
LIMCO GPE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| First supplemental trust deed | Creato il 06 mar 1992 Consegnato il 06 mar 1992 | In corso | Importo garantito Principal and interest on £130,000,000 10 3/4 % first mortgage debenture stock 2021 of great portland estates limited and all other monies under this deed thetrust deed dated 5TH november 1991 the deed of release and substitution dated 28NOVEMBER 1991 and the deed of charge dated 14TH january 1992 see form 395 ref M105 | |
Brevi particolari All right title and interest in the benefit of all guarantees contracts and warranties relating to the design and construction of property known as weybridge business park see form 395 ref M105. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 14 gen 1992 Consegnato il 21 gen 1992 | In corso | Importo garantito The principal of and interest on the £100,000,000 10.75% first mortgage debenture stock 2021 of great portland estates PLC and all other moneys intended to be secured by the above mentioned deed and deeds dated 05/11/91 and 28/11/91 to which it is supplimental | |
Brevi particolari Fixed charge all its right title and interest in the benefit of all contracts guarantees and warranties relating to the design or construction of the property k/a weybridge business park addlestone road weybridge surrey title nos SY464974,SY308646 and SY492742. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument of charge | Creato il 30 ago 1955 Consegnato il 20 set 1955 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the J.H. wallace properties LTD. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 42 albemarle street, london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument of charge | Creato il 30 ago 1955 Consegnato il 20 set 1955 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from J.H. wallace properties LTD. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 27 grosvenor street, london. W1. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0