JOSIAH F.LORD LIMITED

JOSIAH F.LORD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJOSIAH F.LORD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00265450
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JOSIAH F.LORD LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova JOSIAH F.LORD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di JOSIAH F.LORD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per JOSIAH F.LORD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Tom Brophy come segretario

    1 pagineAP03
    XG2XTWKL

    Cessazione della carica di Alison Drew come segretario

    1 pagineTM02
    XG2YMWKF

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A9VRETZB

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2010

    6 pagineAA
    AKIJWTM6

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02
    AR1QKSY2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A26LDPX2

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2010

    Stato del capitale al 05 nov 2010

    • Capitale: GBP 2,500
    SH01
    XVENCOUN

    Stato del capitale al 09 set 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19
    ADPZFN6J

    legacy

    1 pagineSH20
    A36UHN6N

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    A36UGN6M

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Canc share prem/dist reserves 31/08/2010
    RES13

    Cessazione della carica di Stephen Webster come amministratore

    1 pagineTM01
    XMYL5JH7

    Nomina di Mr Robert Andrew Ross Smith come amministratore

    2 pagineAP01
    XMYJAJHA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XZ6M2EUY

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2009

    5 pagineAA
    AD3D7EH5

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01
    XLJY0E3G

    Dettagli del segretario cambiati per Alison Drew il 01 ott 2009

    1 pagineCH03
    XLSN6E3K

    Bilancio redatto al 31 lug 2008

    5 pagineAA
    A6MGY5CX

    legacy

    4 pagine363a
    X6YP150W

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 lug 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di JOSIAH F.LORD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROPHY, Tom
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Segretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    162241170001
    SMITH, Robert Andrew Ross
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    Amministratore
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4GA Reading
    Parkview 1220
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant150753930001
    WOLSELEY DIRECTORS LIMITED
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    Amministratore
    Parkview 1220
    Arlington Business Park, Theale
    RG7 4GA Reading
    122185200001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    CLAY, Richard William
    14 The Drive
    Roundhay
    LS8 1JF Leeds
    Segretario
    14 The Drive
    Roundhay
    LS8 1JF Leeds
    British9531240002
    DREW, Alison
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Segretario
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    British86845230002
    LAITHWAITE, Alan
    669 Ripponden Road
    Moorside
    OL1 4JU Oldham
    Lancashire
    Segretario
    669 Ripponden Road
    Moorside
    OL1 4JU Oldham
    Lancashire
    BritishAccountant40611130002
    MULLEN, Nicholas Henderson
    41 Greenhill Road
    WA15 7BG Timperley
    Cheshire
    Segretario
    41 Greenhill Road
    WA15 7BG Timperley
    Cheshire
    British17851530003
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Segretario
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    ROGERS, Gerard
    8 Birchtree Close
    Bowdon
    WA14 3PP Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    8 Birchtree Close
    Bowdon
    WA14 3PP Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director47181870001
    WHITE, Mark Jonathan
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    38 Grange Close
    Church Road Nascot Wood
    WD17 4HQ Watford
    Hertfordshire
    British82978250001
    BARDEN, Adrian
    1 Croxton Gardens
    PE28 0SE Catworth
    Cambridgeshire
    Amministratore
    1 Croxton Gardens
    PE28 0SE Catworth
    Cambridgeshire
    BritishDirector66429950001
    BRADLEY, David
    Hambleton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3RX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hambleton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3RX Harrogate
    North Yorkshire
    BritishFinance Director65302630001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Secretary Director272310001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    DONELON, John Patrick
    Donelon House Crown Lane
    Horwich
    BL6 5HN Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Donelon House Crown Lane
    Horwich
    BL6 5HN Bolton
    Lancashire
    IrishDirector43413310001
    GATER, Thomas
    35 Blackburn Road
    Rishton
    BB1 4EU Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    35 Blackburn Road
    Rishton
    BB1 4EU Blackburn
    Lancashire
    BritishDirector2539860001
    HAMER, Russell
    Heath Farm Cottage
    SK13 7QF Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Heath Farm Cottage
    SK13 7QF Glossop
    Derbyshire
    BritishDirector1963610001
    MARSH, Eric Joseph
    33 Barsbank Lane
    WA13 0ER Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    33 Barsbank Lane
    WA13 0ER Lymm
    Cheshire
    BritishDirector2576380001
    MILLER, Neil
    Hightrees The Retreat Gregory Avenue
    Romiley
    SK6 3JZ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Hightrees The Retreat Gregory Avenue
    Romiley
    SK6 3JZ Stockport
    Cheshire
    BritishDirector5067000002
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    Amministratore
    The Homestead
    133 Malvern Road
    WR2 4LN Worcester
    BritishChartered Secretary37378570013
    ROGERS, Gerard
    8 Birchtree Close
    Bowdon
    WA14 3PP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    8 Birchtree Close
    Bowdon
    WA14 3PP Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director47181870001
    WEBSTER, Stephen Paul
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    Amministratore
    Parkview 1220
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4GA Reading
    United KingdomBritishCompany Director40201730005
    WHITE, Mark Jonathan
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    Amministratore
    Hawthorn House
    2 Wards Drive, Sarratt
    WD3 6AE Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishSolicitor82978250002

    JOSIAH F.LORD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 17 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 17 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land in cheetham in the city of manchester bounded on the north westerly,N.e and S.e sides thereof by stanley st,knowsley street and redbank respectively containing 2,714 sq: yds: approx. (And known as 1 knowsley st). F/hold land known as 2-2A knowsley st; t/no.gm 241091.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 17 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge over all present/future benefits over the credit policy/no. GCO1/94/100430901.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 17 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge over all present/future benefits in respect of the credit policy issued by trade indemnity PLC,policy/no. GC01/94/018334300. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 18 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities due or to become due from clearfigure limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land in cheetham in the city of manchester bounded on the north westerly,N.E. And S.e sides by stanley st,knowsley st and redbank,containing 2,714 sq.yds.(approx) and secondly plot of land known as 2-2A knowsley st; t/no.gm 241091. see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 apr 1993
    Consegnato il 14 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property k/a 1 knowsley street,cheetham hill road,manchester. Assigns the goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 12 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 03 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 1985
    Consegnato il 29 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • J.F.Doneton & Co. Limited
    Transazioni
    • 29 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 mag 1985
    Consegnato il 29 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land situate in cheetham in the city of manchester bounded on the north-westerley north-easterly & south easterly sides thereof by stanley street, knowsley street and red bank respectively containing in the whole 2,714 square yards or thereabouts.
    Persone aventi diritto
    • J.F. Doneton & Co. Limited
    Transazioni
    • 29 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 lug 1982
    Consegnato il 09 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2/20 knowsley street manchester cheetham title no. Gm 241091 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 05 mag 1982
    Consegnato il 13 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge on the f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0