HUNTER ESTATES LIMITED

HUNTER ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUNTER ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00266012
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUNTER ESTATES LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova HUNTER ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp, 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUNTER ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HUNTER (ESTATES) LIMITED10 gen 198910 gen 1989
    MALLINSON - DENNY (ESTATES) LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    NORCROSS PANEL PLYWOOD COMPANY,LIMITED (THE)08 giu 193208 giu 1932

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUNTER ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HUNTER ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp, 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 21 set 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 set 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 dic 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Stato del capitale al 16 lug 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Tp Directors Ltd come amministratore in data 25 giu 2021

    2 pagineAP02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 dic 2019

    18 pagineAA

    Notifica di Travis Perkins Financing Company No.3 Limited come persona con controllo significativo il 19 dic 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione di Wickes Limited come persona con controllo significativo il 19 dic 2019

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Wickes Limited come persona con controllo significativo il 16 ott 2019

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 29 dic 2018

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 01 mag 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 dic 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di HUNTER ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Segretario
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8929285
    186000060001
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Segretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BAMFORD, Carmel
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    Amministratore
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    British17771540001
    BATTERSBY, Geoffrey Brian
    15 High Street
    Weedon
    HP22 4NW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    15 High Street
    Weedon
    HP22 4NW Aylesbury
    Buckinghamshire
    British41548740002
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Jeremy
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish111434190001
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Amministratore
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    EDWARDS, Fredderick George
    16 Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75885570001
    FRIEDMAN, Douglas Benjamin
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    Amministratore
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    American15200060001
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    JONES, Paul Samuel
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    British75187050001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Amministratore
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    THACKER, Colin David
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    Amministratore
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    United KingdomBritish39672600001
    THOMAS, Geoffrey John
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    Amministratore
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    British42980950001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HUNTER ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    19 dic 2019
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07180292
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Wickes Limited
    19 Colonial Way
    WD24 4JL Watford
    Vision House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    19 Colonial Way
    WD24 4JL Watford
    Vision House
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione2070200
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HUNTER ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A standard security which was presented for registration in scotland on 10 march 2004 and
    Creato il 16 set 2003
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Tenants interest in the lease relating to unit number 11 elgin street industrial estate dunfermaline fife.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch (As Security Trustee for the Mezzanine Finance Parties)
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 17 october 2003 and
    Creato il 16 set 2003
    Consegnato il 25 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the tenants' interest in the lease the subjects therein described lying in the said county of angus.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch (As Security Trustee for the Mezzanine Finance Parties)
    Transazioni
    • 25 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A mezzanine debenture
    Creato il 28 lug 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 10 march 2004 and
    Creato il 19 giu 2003
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenants interest in the lease relating to unit number 11 elgin street industrial estate dunfermaline fife.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch (As Security Trustee for the Senior Finance Parties)
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 6 june 2003 and
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the tenant's interest in the lease between dukeminster limited and hunter estates limited and wickes holdings limited dated 19 december. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch (As Security Trustee for the Senior Finance Parties)
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior security accession deed
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Thimble mill lane,aston,WM305958; cheston rd,aston,bridgewater rd,bridgewater; ST115690. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordinated security accession deed
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (I) thimble mill lane,aston; WM305958; (ii) cheston rd,aston;(iii) bridgewater rd,bridgewater; ST115690. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Creato il 16 gen 2001
    Consegnato il 31 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.,London Branch
    Transazioni
    • 31 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 2000
    Consegnato il 09 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London (As Security Agent)
    Transazioni
    • 09 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed supplemental to a debenture dated 26 september 2000 previously supplemented and amended by earlier security accession deeds (if any) (the "debenture")
    Creato il 27 ott 2000
    Consegnato il 06 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch as Security Agent (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 15 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Creato il 12 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all or any of the otther companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 30 lug 1996
    Consegnato il 07 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and for securing all monies due or to become due from the company to the banks (as defined) under the new monies facility agreement and under the guarantee and debenture dated 3RD july 1996 or the legal charge
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a land and buildings on the north side of fox street bury t/no. GM703775.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 07 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration scotland on 14 aug 1985.
    Creato il 14 ago 1985
    Consegnato il 24 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Grangemouth sawmills, earls road, grangemouth, stirling, scotland.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 24 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 17 ago 1988Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ago 1985
    Consegnato il 22 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due from mallison-denny limited, mallinson-denny group limited and each of the charging subsidiaries (including the company) to no agent and the banks under each of the financing documents and/or in respect of the anallary facilities under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Each of the principal properties, buildings and fixtures thereon, together with benefits of covenants. Fixed charge on present and future interest, all book debts and other debts, the benefits of all nights. (See doc M112 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 22 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 30 giu 1982
    Consegnato il 08 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 3,942,841 debenture stock of brooke bond group PLC and all othermonies intended to be secured by the deed
    Brevi particolari
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC.
    Transazioni
    • 08 lug 1982Registrazione di un'ipoteca

    HUNTER ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 set 2022Inizio della liquidazione
    23 dic 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0