HUNTER ESTATES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HUNTER ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00266012 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HUNTER ESTATES LIMITED?
- Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari
Dove si trova HUNTER ESTATES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Mazars Llp, 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HUNTER ESTATES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HUNTER (ESTATES) LIMITED | 10 gen 1989 | 10 gen 1989 |
| MALLINSON - DENNY (ESTATES) LIMITED | 31 dic 1977 | 31 dic 1977 |
| NORCROSS PANEL PLYWOOD COMPANY,LIMITED (THE) | 08 giu 1932 | 08 giu 1932 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HUNTER ESTATES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per HUNTER ESTATES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp, 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 21 set 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 dic 2021 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 16 lug 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Tp Directors Ltd come amministratore in data 25 giu 2021 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 dic 2019 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Travis Perkins Financing Company No.3 Limited come persona con controllo significativo il 19 dic 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Wickes Limited come persona con controllo significativo il 19 dic 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Wickes Limited come persona con controllo significativo il 16 ott 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 dic 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 01 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HUNTER ESTATES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England England |
| 186000060001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alan Richard | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| RIMMER, Barbara | Segretario | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||||||
| STOKES-SMITH, Keith Reginald | Segretario | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
| ARCHER, William Ernest | Amministratore | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | 15170380004 | ||||||||||
| BAMFORD, Carmel | Amministratore | 36 Enmore Gardens East Sheen SW14 8RF London | British | 17771540001 | ||||||||||
| BATTERSBY, Geoffrey Brian | Amministratore | 15 High Street Weedon HP22 4NW Aylesbury Buckinghamshire | British | 41548740002 | ||||||||||
| BHOTE, Sanaya Homi | Amministratore | 50 Bonnersfield Lane HA1 2LE Harrow Middlesex | British | 72716110002 | ||||||||||
| BIRD, Jeremy | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 111434190001 | |||||||||
| BIRD, Richard Sidney | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | 111500210001 | ||||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| CORNER, Michael Richmond | Amministratore | 95 Castelnau Barnes SW13 London | British | 21206150001 | ||||||||||
| EDWARDS, Fredderick George | Amministratore | 16 Caledon Road HP9 2BX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75885570001 | ||||||||||
| FRIEDMAN, Douglas Benjamin | Amministratore | 46 Lankaster Gardens N2 9AJ London | American | 15200060001 | ||||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HOSKINS, William John | Amministratore | 3 Homewood Road AL1 4BE St. Albans Hertfordshire | British | 49295070002 | ||||||||||
| JONES, Paul Samuel | Amministratore | Brooklyn Newell Green Warfield RG42 6AJ Bracknell Berkshire | British | 75187050001 | ||||||||||
| PENNY, Michael William Harrison | Amministratore | Windrush 9 Downsway GU1 2YA Guildford Surrey | United Kingdom | British | 144262470001 | |||||||||
| RICE, John Michael | Amministratore | Wayside Cottage Street Lane Rodeheath ST7 3SN Cheshire | British | 72718070001 | ||||||||||
| STOKES-SMITH, Keith Reginald | Amministratore | 5a The Broadway Penn Road HP9 2PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 75650590001 | ||||||||||
| THACKER, Colin David | Amministratore | Old Place Farm Birling Road Ryarsh ME19 5JS West Malling Kent | United Kingdom | British | 39672600001 | |||||||||
| THOMAS, Geoffrey John | Amministratore | 8 Stanbrooke Way Church Lane Yielden MK44 1AU Bedford North Bedfordshire | British | 42980950001 | ||||||||||
| WILSON, Geoffrey Charles | Amministratore | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HUNTER ESTATES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Perkins Financing Company No.3 Limited | 19 dic 2019 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Wickes Limited | 06 apr 2016 | 19 Colonial Way WD24 4JL Watford Vision House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HUNTER ESTATES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A standard security which was presented for registration in scotland on 10 march 2004 and | Creato il 16 set 2003 Consegnato il 19 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Tenants interest in the lease relating to unit number 11 elgin street industrial estate dunfermaline fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 17 october 2003 and | Creato il 16 set 2003 Consegnato il 25 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the tenants' interest in the lease the subjects therein described lying in the said county of angus. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A mezzanine debenture | Creato il 28 lug 2003 Consegnato il 13 ago 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 10 march 2004 and | Creato il 19 giu 2003 Consegnato il 19 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The tenants interest in the lease relating to unit number 11 elgin street industrial estate dunfermaline fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 6 june 2003 and | Creato il 29 gen 2003 Consegnato il 13 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the tenant's interest in the lease between dukeminster limited and hunter estates limited and wickes holdings limited dated 19 december. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Senior security accession deed | Creato il 29 gen 2003 Consegnato il 13 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Thimble mill lane,aston,WM305958; cheston rd,aston,bridgewater rd,bridgewater; ST115690. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Subordinated security accession deed | Creato il 29 gen 2003 Consegnato il 13 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (I) thimble mill lane,aston; WM305958; (ii) cheston rd,aston;(iii) bridgewater rd,bridgewater; ST115690. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent | Creato il 16 gen 2001 Consegnato il 31 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 dic 2000 Consegnato il 09 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed supplemental to a debenture dated 26 september 2000 previously supplemented and amended by earlier security accession deeds (if any) (the "debenture") | Creato il 27 ott 2000 Consegnato il 06 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (or any of them) on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 07 gen 1997 Consegnato il 15 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Limited recourse guarantee and debenture | Creato il 12 dic 1996 Consegnato il 20 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and all or any of the otther companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental legal charge | Creato il 30 lug 1996 Consegnato il 07 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and for securing all monies due or to become due from the company to the banks (as defined) under the new monies facility agreement and under the guarantee and debenture dated 3RD july 1996 or the legal charge | |
Brevi particolari All that l/h property k/a land and buildings on the north side of fox street bury t/no. GM703775. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 03 lug 1996 Consegnato il 10 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security presented for registration scotland on 14 aug 1985. | Creato il 14 ago 1985 Consegnato il 24 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Grangemouth sawmills, earls road, grangemouth, stirling, scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 09 ago 1985 Consegnato il 22 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due from mallison-denny limited, mallinson-denny group limited and each of the charging subsidiaries (including the company) to no agent and the banks under each of the financing documents and/or in respect of the anallary facilities under the terms of the charge. | |
Brevi particolari Each of the principal properties, buildings and fixtures thereon, together with benefits of covenants. Fixed charge on present and future interest, all book debts and other debts, the benefits of all nights. (See doc M112 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 30 giu 1982 Consegnato il 08 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 3,942,841 debenture stock of brooke bond group PLC and all othermonies intended to be secured by the deed | |
Brevi particolari Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
HUNTER ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0