MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED

MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMCCORMICK FOODSERVICE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00266894
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MCCORMICK FOOD SERVICE LIMITED09 gen 199809 gen 1998
    L.NOEL & SONS LIMITED11 lug 193211 lug 1932

    Quali sono gli ultimi bilanci di MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Haddenham Business Park Pegasus Way Haddenham Aylesbury Buckinghamshire HP17 8LB a 15 Canada Square London E14 5GL in data 22 dic 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 nov 2017

    LRESSP

    Notifica di Noel Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 09 set 2017

    2 paginePSC09

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Malcolm Stuart Swift come amministratore in data 31 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Laird Everett Creighton come amministratore in data 01 gen 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Jinks come amministratore in data 01 gen 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Charles Noble come amministratore in data 31 dic 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Noble come segretario in data 31 dic 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 nov 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2016

    Stato del capitale al 15 giu 2016

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 lug 2015

    Stato del capitale al 02 lug 2015

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2014

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Smith come segretario in data 30 set 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Charles Noble come segretario in data 01 ott 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Raymond Smith come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Charles Noble come amministratore in data 01 ott 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 giu 2014

    Stato del capitale al 18 giu 2014

    • Capitale: GBP 2,000,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CREIGHTON, Laird Everett
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandAmerican222075660001
    JINKS, Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandEnglish161032050003
    BURLEY, Nicholas James
    16 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    Segretario
    16 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    British89448590001
    DEAN, Paul
    7 Herschel Avenue
    BB12 0LN Burnley
    Lancashire
    Segretario
    7 Herschel Avenue
    BB12 0LN Burnley
    Lancashire
    English14447110001
    HANNA, Roisin
    180 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    Dublin 14
    Dublin
    Ireland
    Segretario
    180 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    Dublin 14
    Dublin
    Ireland
    British44105690001
    MANN, Christopher John
    12 Fryth Mead
    AL3 4TN St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    12 Fryth Mead
    AL3 4TN St Albans
    Hertfordshire
    British59971900001
    MOORE, Stephen Jeffrey
    41 Bicester Road
    HP18 9BP Long Crendon
    Buckinghamshire
    Segretario
    41 Bicester Road
    HP18 9BP Long Crendon
    Buckinghamshire
    Canadian71665970001
    MORRISROE, James Martin, Dr
    Tellicherry 15 Foxdell Way
    Chalfont St. Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Tellicherry 15 Foxdell Way
    Chalfont St. Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British62702000002
    NOBLE, Charles
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    Segretario
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    192171720001
    SAVAGE, Cameron David Freere
    Wayside Bledlow Road
    Saunderton
    HP27 9NG Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    Wayside Bledlow Road
    Saunderton
    HP27 9NG Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British45096570001
    SMITH, Michael
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    Segretario
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    168636460001
    STEELE, Darren Anthony
    London Road
    HP4 2ND Berkhamsted
    28
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    London Road
    HP4 2ND Berkhamsted
    28
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Australian125578160002
    STETZ, Gordon Mckenzie
    2 Belvedere Close
    HP6 6BA Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    2 Belvedere Close
    HP6 6BA Amersham
    Buckinghamshire
    American104851130001
    ALLEN, Eamon Joseph
    Grenagh
    Avoca Avenue
    Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Grenagh
    Avoca Avenue
    Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Irish33780080001
    BURLEY, Nicholas James
    16 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DS Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish89448590001
    DEAN, Paul
    7 Herschel Avenue
    BB12 0LN Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    7 Herschel Avenue
    BB12 0LN Burnley
    Lancashire
    English14447110001
    DISNEY, Colin
    24 Highfield Grove
    Carlton In Lindrick
    S81 9ET Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    24 Highfield Grove
    Carlton In Lindrick
    S81 9ET Worksop
    Nottinghamshire
    British17431590001
    GREENE, Eugene
    Maryvale
    38a Church Road
    IRISH Killiney
    Co Dublin
    Amministratore
    Maryvale
    38a Church Road
    IRISH Killiney
    Co Dublin
    Irish34070520001
    HANDLEY, Harold John
    28 Rivermead Court
    Bisham Road
    SL7 1SJ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    28 Rivermead Court
    Bisham Road
    SL7 1SJ Marlow
    Buckinghamshire
    British39829900001
    KEEFE, Robert John Frederick
    Glendale House
    Manor Road Penn
    HP10 8JA High Wycombe
    Bucks
    Amministratore
    Glendale House
    Manor Road Penn
    HP10 8JA High Wycombe
    Bucks
    United KingdomBritish22579040002
    KEENAN, John
    1 Woodcrest
    Wilpshire
    BB1 9PR Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    1 Woodcrest
    Wilpshire
    BB1 9PR Blackburn
    Lancashire
    British15667510001
    KURZIUS, Lawrence Erik
    1312 First Street
    New Orleans
    Louisiana 70130
    Usa
    Amministratore
    1312 First Street
    New Orleans
    Louisiana 70130
    Usa
    United StatesAmerican118683830001
    MANIFOLD, Albert Jude
    Spynans House
    Kiltegan
    County Wicklow
    Ireland
    Amministratore
    Spynans House
    Kiltegan
    County Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish264302310001
    MCGUIRE, Vivian Francis
    12 Knocknacree Park
    Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    12 Knocknacree Park
    Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Irish30974070001
    MOLAN, John Charles
    Little Birches Coronation Road
    SL5 9LQ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Little Birches Coronation Road
    SL5 9LQ Ascot
    Berkshire
    British46924240002
    MOORE, Stephen Jeffrey
    41 Bicester Road
    HP18 9BP Long Crendon
    Buckinghamshire
    Amministratore
    41 Bicester Road
    HP18 9BP Long Crendon
    Buckinghamshire
    Canadian71665970001
    MORRISROE, James Martin, Dr
    Tellicherry 15 Foxdell Way
    Chalfont St. Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tellicherry 15 Foxdell Way
    Chalfont St. Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British62702000002
    MURPHY, James Thomas
    15 Jevington Way
    Heysham
    LA3 2HQ Morecambe
    Lancashire
    Amministratore
    15 Jevington Way
    Heysham
    LA3 2HQ Morecambe
    Lancashire
    British15667520001
    NIEROP, Philip Godwin
    Keepers Cottage 1 Milton Street
    Westcott
    RH4 3PX Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Keepers Cottage 1 Milton Street
    Westcott
    RH4 3PX Dorking
    Surrey
    British60097480001
    NOBLE, Charles
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish191978360001
    PEPPERDINE, Roy
    1 Bankcroft Close
    Padiham
    BB12 8SQ Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    1 Bankcroft Close
    Padiham
    BB12 8SQ Burnley
    Lancashire
    British15667530001
    SMITH, Michael Raymond
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    EnglandAmerican168609300002
    STEELE, Darren Anthony
    London Road
    HP4 2ND Berkhamsted
    28
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    London Road
    HP4 2ND Berkhamsted
    28
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian125578160003
    STETZ, Gordon Mckenzie
    2 Belvedere Close
    HP6 6BA Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Belvedere Close
    HP6 6BA Amersham
    Buckinghamshire
    American104851130001
    SWIFT, Malcolm Stuart
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Haddenham Business Park
    Buckinghamshire
    EnglandBritish135538440002

    Chi sono le persone con controllo significativo di MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Haddenham Business Park, Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Mccormick (Uk) Plc
    Buckinghamshire
    England
    06 apr 2016
    Haddenham Business Park, Pegasus Way
    Haddenham
    HP17 8LB Aylesbury
    Mccormick (Uk) Plc
    Buckinghamshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02515228
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    31 mag 201731 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental legal charge
    Creato il 14 ago 1992
    Consegnato il 03 set 1992
    In corso
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due from the company to the governor and company of the bank of scotland (as security trustee) the banks and the overdraft bank (all as defined) under the terms of the facilities agreement in respect of the term loan facility and/or the working capital facility letter in respect of the working capital facility and all monies due or to become due from the company to the mezzanine lender (as defined) under the terms of the mezzanine loan agreement and the mezzanine loan and all monies due or to become due from each group company to the secured parties under the terms of the secured documents or any of them
    Brevi particolari
    All that freehold and leasehold land k/a stanhill mill stanhill valley oxwaldtwistle accrington lancashire BB5 4PR together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery (please see form 395 and attached schedule tc ref M171C for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 1991
    Consegnato il 20 mag 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of other companies named therein to the chargee under the terms of this charge and the various as defined therein
    Brevi particolari
    (See doc M701 c for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland the Mezzanine Lenders)(As Trustee for the Banks the Overdraft Bank And
    Transazioni
    • 20 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    Charge on credit balance of accounts.
    Creato il 30 apr 1991
    Consegnato il 20 mag 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the companies (as defined in the deed) to the governor and company of the bank of scotland in its capacity as overdraft bank and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 30.4.91.
    Brevi particolari
    By way of fixed and specific charge:- all moneys at 30-4-91. standing to the credit of the account of R. noel & sons limited with the bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1991Registrazione di un'ipoteca

    MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ott 2018Data di scioglimento
    28 nov 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0