JPEL CAMERA COMPANY LIMITED

JPEL CAMERA COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJPEL CAMERA COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00267083
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JPEL CAMERA COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova JPEL CAMERA COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JPEL CAMERA COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JESSOPS PHOTO EXPRESS LIMITED07 mag 200407 mag 2004
    HUSBANDS & SONS LIMITED18 lug 193218 lug 1932

    Quali sono gli ultimi bilanci di JPEL CAMERA COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per JPEL CAMERA COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 26 mar 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mar 2013

    Stato del capitale al 07 mar 2013

    • Capitale: GBP 10,200
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Nicholas John Molyneux come segretario in data 20 mar 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Hannan come amministratore in data 26 ott 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Sean Emmett come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Chris Yates come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di David Cashman come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Hannan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Rollason come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Cashman come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di JPEL CAMERA COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOYDELL, Joanna
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritishDirector164373820001
    EMMETT, Sean Robert
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritishDirector152701300001
    YATES, Chris
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritishDirector165227300001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    BritishFinance Director48224770001
    GEARY, Robert Alan
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    BritishAccountant11918210001
    JESSOP, Alan Vernon
    101 Uppingham Road
    Houghton On The Hill
    LE7 9HL Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    101 Uppingham Road
    Houghton On The Hill
    LE7 9HL Leicester
    Leicestershire
    British5103560001
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant93529300001
    CASHMAN, David Peter Charles
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritishFinance Director151553190001
    CHURCHILL, Roger
    61 Sapcote Road
    Burbage
    LE10 2AS Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    61 Sapcote Road
    Burbage
    LE10 2AS Hinckley
    Leicestershire
    BritishDirector48957720002
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishFinance Director48224770001
    GEARY, Robert Alan
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    2 Hilders Road
    LE3 6HD Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector11918210001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    BritishAccountant105128310002
    GRAY, Richard Kevin
    Skegby Lane
    Mansfield
    NG19 6QR Nottingham
    54
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Skegby Lane
    Mansfield
    NG19 6QR Nottingham
    54
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant151698490001
    HANNAN, Andrew
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritishDirector153976980001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector116885790001
    HEFFORD, Richard Arthur
    The Grange
    Main Street, Welham
    LE16 7UJ Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Grange
    Main Street, Welham
    LE16 7UJ Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishGeneral Manager85603250001
    JESSOP, Alan Vernon
    101 Uppingham Road
    Houghton On The Hill
    LE7 9HL Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    101 Uppingham Road
    Houghton On The Hill
    LE7 9HL Leicester
    Leicestershire
    BritishPhotographic Dealer5103560001
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant123915050001
    RIORDAN, Peter Joseph
    73 Fairfax Avenue
    Ewell
    KT17 2QQ Epsom
    Surrey
    Amministratore
    73 Fairfax Avenue
    Ewell
    KT17 2QQ Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Director106574800001
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritishDirector67354680003

    JPEL CAMERA COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 29 set 2009
    Consegnato il 06 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 29 set 2009
    Consegnato il 02 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties k/a 32 market street nottingham t/no NT289948, 9 commercial street sheffield t/no and 9 devonshire street t/no CU54562 for further properties charged refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite debenture
    Creato il 30 ago 2007
    Consegnato il 17 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A supplemental deed
    Creato il 07 giu 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2007
    Consegnato il 19 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 1950
    Consegnato il 13 gen 1950
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    Freehold:- no 8 st. Augustines parade bristol 1. & no 25 denmark street bristol 1. including all trade and other fixtures present and future.
    Persone aventi diritto
    • Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 13 gen 1950Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0