LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED
Panoramica
Nome della società | LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00272076 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
- fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (20160) / Industrie manifatturiere
Dove si trova LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Suite 5 2nd Floor Bulman House Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LUCITE INTERNATIONAL SPECIALTY RESINS AND POLYMERS LIMITED | 08 mag 2002 | 08 mag 2002 |
INEOS ACRYLICS NEWTON AYCLIFFE LIMITED | 28 lug 2000 | 28 lug 2000 |
BONAR POLYMERS LIMITED | 05 apr 1988 | 05 apr 1988 |
BONAR COLE POLYMERS LIMITED | 23 mag 1986 | 23 mag 1986 |
COLE POLYMERS LIMITED | 12 gen 1933 | 12 gen 1933 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2023 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE England a Suite 5 2nd Floor Bulman House Regent Centre Gosforth Newcastle upon Tyne NE3 3LS in data 17 gen 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2021 al 30 set 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Stato del capitale al 22 nov 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2020 | 36 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Melanie Jane Jury come amministratore in data 01 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip James Bailey come amministratore in data 01 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Lucite International Holdco Limited come persona con controllo significativo il 01 feb 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE England a Monomer House 9 Cheltenham Road Portrack Interchange Business Park Stockton-on-Tees TS18 2AD | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 35 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Fusion House Haslingden Road Blackburn BB1 2FD England a Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 35 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Orchard Mill Duckworth Street Darwen BB3 1AT England a Fusion House Haslingden Road Blackburn BB1 2FD | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTHILL, Colin Neil | Segretario | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor Bulman House | 241213370001 | |||||||
CUTHILL, Colin Neil | Amministratore | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor Bulman House | United Kingdom | British | Accountant | 161168950001 | ||||
HOOGERDIJK, Dirk Cornelis | Amministratore | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor Bulman House | Belgium | Dutch | Marketing Director | 229646300001 | ||||
JURY, Melanie Jane | Amministratore | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor Bulman House | England | British | Company Director | 227689900001 | ||||
PRIOR, Caroline | Amministratore | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor Bulman House | England | British | Director | 244214800001 | ||||
LAMBERT, Ian Robin | Segretario | The White Cottage Hook Road SO51 9BY Ampfield Hampshire | British | 71289480003 | ||||||
TURNER, William | Segretario | 101 Stanhope Road South DL3 7SF Darlington County Durham | British | 11585250001 | ||||||
VEERMAN, Annie Sophia | Segretario | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | Dutch | Chief Finance Officer | 90566780002 | |||||
BAILEY, Philip James | Amministratore | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | England | British | Chemical Site Manager | 128766340001 | ||||
BARTLETT, Peter Andrew | Amministratore | Hill House Somersal Herbert DE6 5PD Ashbourne Derbyshire | British | Group Managing Director | 71099790001 | |||||
BRENNAN, Michael Patrick Joseph, Dr | Amministratore | Riding Lea Strathmore Road NE39 1JA Rowlands Gill Tyne & Wear | British | Manager | 11585260001 | |||||
DAVIDSON, Scott | Amministratore | 54 Burgess Wood Road South HP9 1EJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Director | 14566540001 | |||||
HAY, John Andrew | Amministratore | Fairview House Barningham DL11 7DU Richmond North Yorkshire | British | Manager | 11585270001 | |||||
HENDERSON, Andrew Paul | Amministratore | Overton Coach House Overton Lane, Heaton BL1 5BZ Bolton Lancashire | British | Director | 118088100001 | |||||
LAMBERT, Ian Robin | Amministratore | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton Cumberland House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 71289480007 | ||||
LENG, James William | Amministratore | Caledonian Crescent Gleneagles PH3 1NG Auchterarder Glenuyll Perthshire | British | Manager | 134713800001 | |||||
MACLEAN, Calum Grigor | Amministratore | 11 Raymond Road SO15 5AG Southampton Hampshire | British | Company Director | 71175820001 | |||||
MUSTAFA, Imtiaz, Dr | Amministratore | 6 Glastonbury Grove NE2 2HA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Chemist | 11585280002 | |||||
PRITCHARD, Dudley James | Amministratore | 16 Acle Meadows DL5 4XD Newton Aycliffe County Durham | British | Chemical Engineer | 28933530001 | |||||
RANKIN, Clive Taunton, Dr | Amministratore | Carsegreen House Tully Belton Bankfoot PH1 1DJ Perthshire | British | Manager | 78087820002 | |||||
REGAN, Kenneth | Amministratore | Whitegates House Stock Lane Whaddon MK17 0LS Milton Keynes Buckinghamshire | British | Manager | 20954050001 | |||||
SAYERS, Neil Lawson | Amministratore | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton Cumberland House Hampshire United Kingdom | England | British | Director | 68514560002 | ||||
STANNARD, Ann-Marie | Amministratore | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | United Kingdom | British | General Manager | 189241280002 | ||||
TURNER, William | Amministratore | 101 Stanhope Road South DL3 7SF Darlington County Durham | British | Accountant | 11585250001 | |||||
VEERMAN, Annie Sophia | Amministratore | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | Australia | Dutch | Chief Financial Officer | 90566780005 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcc Methacrylates Holdco Limited | 06 apr 2016 | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works Cleveland England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 07 lug 2006 Consegnato il 24 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each loan party to the chargee and/or the secured parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
LUCITE INTERNATIONAL SPECIALITY POLYMERS AND RESINS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0