ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00276098 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED?
- Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ARRIVA MOTOR RETAILING PLC | 01 gen 1998 | 01 gen 1998 |
| COWIE MOTOR HOLDINGS P.L.C. | 04 ago 1993 | 04 ago 1993 |
| POLLARD & CRITCHLEY LIMITED | 10 mag 1933 | 10 mag 1933 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 21 nov 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Martin James Hibbert come amministratore in data 23 ott 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Christopher John Applegarth come amministratore in data 23 ott 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Turner come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Christopher John Applegarth il 05 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Paul Turner come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Martin James Hibbert come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Lonsdale come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 11 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Segretario | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Amministratore | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | 161250030001 | |||||
| TURNER, David Paul | Segretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| APPLEGARTH, David Christopher John | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | Scotland | British | 81952520001 | |||||
| BARBER, Richard Charles | Amministratore | Dancer's End Lodge Dancers End HP23 6JY Tring Hertfordshire | British | 34307140002 | ||||||
| CLARKE, Michael John | Amministratore | 9 Ash Grove Kirklevington TS15 9NQ Yarm Cleveland | British | 43094600001 | ||||||
| COWIE, Thomas, Sir | Amministratore | Broadwood Hall DH7 0TD Lanchester County Durham | United Kingdom | British | 142033700001 | |||||
| DAVIES, Robert John | Amministratore | Foresters Hall The Green Middleton Tyas DL10 6QY Richmond North Yorkshire | British | 62023220002 | ||||||
| FLEET, John Richard | Amministratore | Cliffe Lodge NE45 5RN Corbridge Northumberland | British | 43498380001 | ||||||
| GWILT, Michael Peter | Amministratore | 17 Telford Close High Shincliffe DH1 2YJ Durham | British | 51840420005 | ||||||
| HIBBERT, Martin James | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 111092090001 | |||||
| HODGSON, Gordon William | Amministratore | Bramble House Easington Lane DH5 0QX Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 1108360001 | ||||||
| HUGHES, Anthony Thomas Charles | Amministratore | 29 Shaggs Meadow SO43 7BN Hampshire | British | 45636800001 | ||||||
| JANE, Iain Stewart | Amministratore | The Folly 53 Barmpton Lane DL1 3HH Darlington County Durham | British | 45241110001 | ||||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Amministratore | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| RAY, John Alfred | Amministratore | 37 Harefield Long Melford CO10 9DE Sudbury Suffolk | British | 58415290002 | ||||||
| SMALES, David | Amministratore | Common House Gilsland CA8 7AN Brampton Cumbria | United Kingdom | British | 87433950001 | |||||
| TURNER, David Paul | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 48937720001 |
ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creato il 25 mar 1994 Consegnato il 11 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 10 feb 1994 Consegnato il 15 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 10 gen 1994 Consegnato il 28 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 11 mar 1985 Consegnato il 12 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at chester road, heswall, merseyside. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 mag 1982 Consegnato il 15 giu 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 and all other monies due or to become due from J.cowie limited to the chargee under the terms of the charge including monies due on account current or stated for goods supplied or otherwise. | |
Brevi particolari Leighton motors chester high road, heswell, wirral cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 feb 1970 Consegnato il 05 mar 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 127 duke street, liverpool lancs. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ARRIVA MOTOR RETAILING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0