E.A.BARKER LIMITED
Panoramica
| Nome della società | E.A.BARKER LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00276180 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di E.A.BARKER LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova E.A.BARKER LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 15th Floor 6 Bevis Marks EC3A 7BA London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di E.A.BARKER LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per E.A.BARKER LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Susanne Gray come amministratore in data 15 lug 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 apr 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Sheraz Afzal come amministratore in data 06 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Marie-Anne Bousaba come amministratore in data 29 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Lisa Susanne Gray come amministratore in data 01 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England a 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA in data 12 nov 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Alpesh Kumar Patel come amministratore in data 07 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sheraz Afzal come amministratore in data 07 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew James Smith come amministratore in data 08 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alpesh Kumar Patel come amministratore in data 22 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Richard Kaye come amministratore in data 22 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di E.A.BARKER LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUSABA, Marie-Anne | Amministratore | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | United Kingdom | Australian | 293005440001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Segretario | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196291410001 | |||||||
| FISHER, Mark | Segretario | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| FISHER, Mark | Segretario | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GOLD, Nick | Segretario | 126 Hamilton Terrace St John's Wood NW8 9UT London | British | 111562560001 | ||||||
| GREGG, Terence Michael | Segretario | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HARRINGTON, Nicholas Joseph | Segretario | 9 Kingsmead Avenue KT4 8XB Worcester Park Surrey | British | 1273670001 | ||||||
| MCKENZIE, Robbie | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195400190001 | |||||||
| PAGE, Elizabeth | Segretario | Flat 3 5 St Leonards Road, Ealing W13 8PN London | British | 34006010001 | ||||||
| PRIOR, Mark Lee | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178629510001 | |||||||
| REID, Michael John | Segretario | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Segretario | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | 62321110002 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Segretario | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 151302380001 | ||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Amministratore | Applegarth Three Elm Lane Hadlow TN11 0AB Tonbridge Kent | England | British | 55757700003 | |||||
| AFZAL, Sheraz | Amministratore | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | United Kingdom | British | 251073350001 | |||||
| ATTALLAH, Naim Ibrahim | Amministratore | Flat 15 51 South Street W1Y 5PA London | United Kingdom | British | 25646240001 | |||||
| BERKMEN, Gillian | Amministratore | Orchard View 27 Woodhill Avenue SL9 8DP Gerrards Cross South Buckinghamshire | Gb | British | 92154270001 | |||||
| BRAGG, Roy Alec | Amministratore | 80 West Hill KT19 8LF Epsom Surrey | British | 14124670001 | ||||||
| BROWN, Andrew Saville | Amministratore | 123 Edenfield Gardens KT4 7DX Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | 69874610002 | |||||
| BRYAN, Robert Andrew | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 122733810001 | |||||
| CLARK, Keith Dudley | Amministratore | Brock House 30 The Hedgerow Grove Green ME14 5TG Maidstone Kent | British | 30702450003 | ||||||
| CLAYMAN, Paul Sidney | Amministratore | 18 Keepier Wharf 12 Narrow Street E14 8DH London | British | 14436120006 | ||||||
| COOPER, Caroline | Amministratore | 222 Caraway 2 Cayenne Court 32 Shad Thames SE1 2PP London | British | 92733900001 | ||||||
| COREPAL, Sanjiv Kumar | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | United Kingdom | British | 205239750001 | |||||
| DAHL, Ian Xavier | Amministratore | 2 Heathfield Lodge Carron Lane GU29 9LD Midhurst West Sussex | British | 66486140001 | ||||||
| DEAKIN, Tony | Amministratore | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 210862440001 | |||||
| ERICKSON, Eric George | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| EVANS, Nicholas David | Amministratore | 6 Raddington Road W10 5TF London | United Kingdom | British | 57490310002 | |||||
| FILECCIA, Piero | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 116096800001 | |||||
| FISHER, Mark | Amministratore | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GOLD, Nicholas Paul | Amministratore | 126 Hamilton Terrace St Johns Wood NW8 9UT London | England | British | 53606570002 | |||||
| GRAY, Lisa Susanne | Amministratore | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | England | British | 262153810001 | |||||
| GREGG, Terence Michael | Amministratore | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| HOWARD, Stuart John | Amministratore | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | 192909600002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di E.A.BARKER LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan & Co (Birmingham) Limited | 06 apr 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
E.A.BARKER LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 22 nov 2005 Consegnato il 06 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties | Creato il 05 giu 2001 Consegnato il 13 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 24 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent | Creato il 24 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0