CLARENDON PROPERTY COMPANY

CLARENDON PROPERTY COMPANY

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLARENDON PROPERTY COMPANY
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00276997
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLARENDON PROPERTY COMPANY LIMITED19 giu 193319 giu 1933

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di David Clifford Wheeler come amministratore in data 14 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Bruce Richardson come amministratore in data 14 giu 2019

    2 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    5 pagineRP04CS01

    Cessazione della carica di Sarah Nelson come amministratore in data 14 gen 2019

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 22 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish152531940004
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish189632520001
    COWEN, Geraint Jamie
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish141040000003
    HONEYMAN, James Andrew
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish201179510001
    PINKSTONE, James Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish241498640001
    RICHARDSON, Bruce
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish,South African260008150001
    SHAH, Hursh
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish162123940002
    WATSON, James
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish248560570001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    ATKINSON, William Stephen
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish174566650001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Amministratore
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritish175617500001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Amministratore
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Amministratore
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish119073370001
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British166550001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Amministratore
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COHEN, Carolina Alfred
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish248093020001
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    FRANCIS, Luke Thomas
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish223122340001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    HOORN, Antony John Van Der
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891040001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish1188110001
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish116126860008

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLARENDON PROPERTY COMPANY?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pencilscreen Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    31 dic 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione06532033
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CLARENDON PROPERTY COMPANY ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A composite supplemental trust deed
    Creato il 29 ago 2006
    Consegnato il 13 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The land and buildings on the northerly side of dale street liverpool t/no MS228942. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transazioni
    • 13 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A seventh supplemental trust deed
    Creato il 17 giu 1998
    Consegnato il 30 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the trustee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge over all the company's right title and interest in the property st james' house, st james' street newcastle-upon-tyne t/n-TY115370 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to the company and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transazioni
    • 30 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 13 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000,000 9 3/8 per cent.first mortgage debenture stock 2028 of the british land company PLC (the "parent") and all other moneys due from the parent to the chargee and all other persons or companies acting under the trust deed and any other deeds supplemental thereto as trustees,subject to a maximum of £1,000,000
    Brevi particolari
    F/Hold land/blds on north east side of irwell st,ralli quays,salford,manchester; t/no.gm 490260; f/hold land and blds at 2 moorfields,dale st,liverpool; t/no.ms 228942.......f/hold land/blds at finsgate,5/7 cranwood st,london E.C.1; t/no.egl 166558.....plus various other properties....all fittings,fixtures,fixed plant and machinery......see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limitedthe "Trustee"
    Transazioni
    • 13 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ott 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 mar 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 ott 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 28 giu 1984
    Consegnato il 12 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on under the terms of a guarantee dated 28/6/84
    Brevi particolari
    5/6 cork street & 1/2 cork mews city of westminster title no ngl 455028.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on agreement
    Creato il 20 giu 1984
    Consegnato il 03 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the interest of the company in an agreement dated 25/1/83 between liverpool city council and the british land company PLC and the company relating to development at moorfields and dale street in the city of liverpool & all the premises comprised therein & all buildings thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 27 nov 1979
    Consegnato il 17 dic 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the BRIT2SH land company limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    1) f/h of kingsway hall carlton house, 66, 67, 68, 69 & 69A great queen street and wesley house wild court london WC2. Title no:- ln 456409 2) l/h part of the entrance hall of kingsway hall aferesaid and the basement the under demised by a lease dated 7/8/13 title no:- ln 19597.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 27 lug 1979
    Consegnato il 16 ago 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or hereafter standing to the credit of an account designated "lloyds bank international (france) limited re british land company limited no. 6 account tog. With interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1978
    Consegnato il 19 mag 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12-2-73 as amended
    Brevi particolari
    37 & 38 golden sq. 4 - 7 upper james st 34/36/38 beak st. London W1 9 hanover st 6 masons arms mews london W1.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 19 mag 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assurance
    Creato il 14 lug 1976
    Consegnato il 15 lug 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing debenture stock of the british land company limited. Amounting to £5,000,000 secured by a trust deed dated 30/4/62 and deeds suplemental thereto.
    Brevi particolari
    9, hanovre street and 6, masons arms mews, in the london borough of the city of westminster. Together with all buildings & erections, fixtures and fittings and fixed plant and mchinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 15 lug 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge by deposit of deeds without writing
    Creato il 26 set 1975
    Consegnato il 16 ott 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due from the british land co. LTD to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH dec 73
    Brevi particolari
    28,29,29A,30,30A &31 pride hill, shrewsbury.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Co of New York
    Transazioni
    • 16 ott 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1974
    Consegnato il 12 giu 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due from the british land company LTD to the chargee under the terms of an agreement dated 12/12/73
    Brevi particolari
    Land and buildings known as 299, oxford street, london.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 12 giu 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental trust deed
    Creato il 10 feb 1969
    Consegnato il 25 feb 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Supplemental trust deed effecting substitution of security for securing debenture stock of the company amounting to £650,000 secured by a trust deed dated 19/01/34 & deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    See schedule attached to doc 155.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 25 feb 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Exfacie absolute disposition
    Creato il 17 gen 1968
    Consegnato il 06 feb 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing debenture stock of the company amounting to £650,000 secured by a trust deed dated 17/01/68
    Brevi particolari
    104/112 sanchichall st, 208/212 hope st, glasgow, & all other buildings & erections thereon including all landlords fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 06 feb 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Exfacie absolute disposition
    Creato il 17 gen 1968
    Consegnato il 06 feb 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing debenture stock of the company amounting to £650,000 secured by a trust deed dated 17/01/68
    Brevi particolari
    122-132 argyle st, 2-8 buchanan st, glasgow with all buildings & erections thereon including landlords fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 06 feb 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assurance
    Creato il 17 gen 1968
    Consegnato il 25 gen 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Deed of assurances for further securing debenture stock of the british land co LTD amounting to £3,500,000 secured by a trust deed dated 30/4/62 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    166-168 western rd, 1-5 crown st, brighton; 31-33 high st, 2,2A,3 & 4 skinner st, newport with landlords fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Assurance Co. LTD
    Transazioni
    • 25 gen 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assurance
    Creato il 19 ott 1967
    Consegnato il 24 ott 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing £3,500,000 the british land co. LTD debenture stock secured by a trust deed of 30-4-62 & deeds supp.thereto.
    Brevi particolari
    39, dover st., & 118 berkeley st., London W.19 & landlords fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Assurance Co. LTD
    Transazioni
    • 24 ott 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assurance
    Creato il 22 apr 1966
    Consegnato il 05 mag 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Deed of assurance for further securing ukp 1,826.320 denbenture stock of the british land company LTD. Secured by a trust deed dated 30.4.62 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Zetland house, marloes rd, kensington, london W8; 495 high rd, wembley, great london; 9 high st, harpenden, hants; quality court, chancery, london WC2 & land & fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company LTD
    Transazioni
    • 05 mag 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 26 mar 1964
    Consegnato il 08 apr 1964
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Trust deed securing debenture stock amounting to £1,826,320 of the british land company LTD inclusive of £1,204,000 secured by a trust deed dated 30/04/62 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Various properties at liverpool and london (see doc for details).
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co. LTD
    Transazioni
    • 08 apr 1964Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage by way of substituted security
    Creato il 31 gen 1956
    Consegnato il 09 feb 1956
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    $650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34
    Brevi particolari
    84A high st, stony stratford, bucks.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 09 feb 1956Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage by way of substituted security
    Creato il 19 ott 1954
    Consegnato il 25 ott 1954
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34
    Brevi particolari
    Freehold york house, york street, st. Marylebone, london 27 silver street, gainsborough, lancs.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 25 ott 1954Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 20 set 1951
    Consegnato il 01 ott 1951
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34
    Brevi particolari
    99, sandgate road, folkstone, kent.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 01 ott 1951Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 11 mag 1951
    Consegnato il 23 mag 1951
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £650,000 debenure stock secured by a trust deed dated 19/1/34
    Brevi particolari
    495, high road, wembley, middx.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 23 mag 1951Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 ott 1950
    Consegnato il 17 ott 1950
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34
    Brevi particolari
    Various properties for details see particular doc no:66.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 17 ott 1950Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 14 mar 1935
    Consegnato il 02 apr 1935
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £55,000
    Brevi particolari
    Property at buttersea london, islington braintree, romford, southard, richard liverpool & wallasey.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 02 apr 1935Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Series of debentures
    Creato il 19 gen 1934
    Consegnato il 30 gen 1934
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star & Bristol Dominions Insurance Co.
    Transazioni
    • 30 gen 1934Registrazione di un'ipoteca
    • 12 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0