CLARENDON PROPERTY COMPANY
Panoramica
| Nome della società | CLARENDON PROPERTY COMPANY |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 00276997 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CLARENDON PROPERTY COMPANY?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CLARENDON PROPERTY COMPANY?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CLARENDON PROPERTY COMPANY?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CLARENDON PROPERTY COMPANY LIMITED | 19 giu 1933 | 19 giu 1933 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CLARENDON PROPERTY COMPANY?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CLARENDON PROPERTY COMPANY?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Cessazione della carica di David Clifford Wheeler come amministratore in data 14 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Bruce Richardson come amministratore in data 14 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||
legacy | 5 pagine | RP04CS01 | ||
Cessazione della carica di Sarah Nelson come amministratore in data 14 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Soddisfazione dell'onere 24 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 14 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 17 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 19 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 23 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 15 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 18 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 16 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 22 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 20 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Chi sono gli amministratori di CLARENDON PROPERTY COMPANY?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000003 | |||||||||
| HONEYMAN, James Andrew | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 201179510001 | |||||||||
| PINKSTONE, James Michael | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 241498640001 | |||||||||
| RICHARDSON, Bruce | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British,South African | 260008150001 | |||||||||
| SHAH, Hursh | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 162123940002 | |||||||||
| WATSON, James | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 248560570001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Segretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| ATKINSON, William Stephen | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 174566650001 | |||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Amministratore | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BERRY, David Charles | Amministratore | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 166550001 | ||||||||||
| BIRCH, John Matthew | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Amministratore | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| COHEN, Carolina Alfred | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 248093020001 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GUNSTON, Michael Ian | Amministratore | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HOORN, Antony John Van Der | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 170891040001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| KALMAN, Stephen Lionel | Amministratore | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | 1188110001 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Amministratore | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CLARENDON PROPERTY COMPANY?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pencilscreen Limited | 31 dic 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CLARENDON PROPERTY COMPANY ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A composite supplemental trust deed | Creato il 29 ago 2006 Consegnato il 13 set 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The land and buildings on the northerly side of dale street liverpool t/no MS228942. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A seventh supplemental trust deed | Creato il 17 giu 1998 Consegnato il 30 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the british land company PLC (the "issuer"), all further bonds (as defined in the principal trust deed dated 6TH october, 1995 (the "principal trust deed")) whether or not of the same series, and all other monies payable by the issuer to the trustee (as defined in the principal trust deed) under the terms of the principal trust deed | |
Brevi particolari By way of first fixed charge over all the company's right title and interest in the property st james' house, st james' street newcastle-upon-tyne t/n-TY115370 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to the company and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 29 apr 1993 Consegnato il 13 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000,000 9 3/8 per cent.first mortgage debenture stock 2028 of the british land company PLC (the "parent") and all other moneys due from the parent to the chargee and all other persons or companies acting under the trust deed and any other deeds supplemental thereto as trustees,subject to a maximum of £1,000,000 | |
Brevi particolari F/Hold land/blds on north east side of irwell st,ralli quays,salford,manchester; t/no.gm 490260; f/hold land and blds at 2 moorfields,dale st,liverpool; t/no.ms 228942.......f/hold land/blds at finsgate,5/7 cranwood st,london E.C.1; t/no.egl 166558.....plus various other properties....all fittings,fixtures,fixed plant and machinery......see form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 28 giu 1984 Consegnato il 12 lug 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on under the terms of a guarantee dated 28/6/84 | |
Brevi particolari 5/6 cork street & 1/2 cork mews city of westminster title no ngl 455028. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on agreement | Creato il 20 giu 1984 Consegnato il 03 lug 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the interest of the company in an agreement dated 25/1/83 between liverpool city council and the british land company PLC and the company relating to development at moorfields and dale street in the city of liverpool & all the premises comprised therein & all buildings thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 27 nov 1979 Consegnato il 17 dic 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the BRIT2SH land company limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari 1) f/h of kingsway hall carlton house, 66, 67, 68, 69 & 69A great queen street and wesley house wild court london WC2. Title no:- ln 456409 2) l/h part of the entrance hall of kingsway hall aferesaid and the basement the under demised by a lease dated 7/8/13 title no:- ln 19597. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 27 lug 1979 Consegnato il 16 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies now or hereafter standing to the credit of an account designated "lloyds bank international (france) limited re british land company limited no. 6 account tog. With interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 mag 1978 Consegnato il 19 mag 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12-2-73 as amended | |
Brevi particolari 37 & 38 golden sq. 4 - 7 upper james st 34/36/38 beak st. London W1 9 hanover st 6 masons arms mews london W1. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 14 lug 1976 Consegnato il 15 lug 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing debenture stock of the british land company limited. Amounting to £5,000,000 secured by a trust deed dated 30/4/62 and deeds suplemental thereto. | |
Brevi particolari 9, hanovre street and 6, masons arms mews, in the london borough of the city of westminster. Together with all buildings & erections, fixtures and fittings and fixed plant and mchinery thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge by deposit of deeds without writing | Creato il 26 set 1975 Consegnato il 16 ott 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies due or to become due from the british land co. LTD to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH dec 73 | |
Brevi particolari 28,29,29A,30,30A &31 pride hill, shrewsbury. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 11 giu 1974 Consegnato il 12 giu 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies due or to become due from the british land company LTD to the chargee under the terms of an agreement dated 12/12/73 | |
Brevi particolari Land and buildings known as 299, oxford street, london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 10 feb 1969 Consegnato il 25 feb 1969 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Supplemental trust deed effecting substitution of security for securing debenture stock of the company amounting to £650,000 secured by a trust deed dated 19/01/34 & deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari See schedule attached to doc 155. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Exfacie absolute disposition | Creato il 17 gen 1968 Consegnato il 06 feb 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further securing debenture stock of the company amounting to £650,000 secured by a trust deed dated 17/01/68 | |
Brevi particolari 104/112 sanchichall st, 208/212 hope st, glasgow, & all other buildings & erections thereon including all landlords fixtures & fittings. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Exfacie absolute disposition | Creato il 17 gen 1968 Consegnato il 06 feb 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing debenture stock of the company amounting to £650,000 secured by a trust deed dated 17/01/68 | |
Brevi particolari 122-132 argyle st, 2-8 buchanan st, glasgow with all buildings & erections thereon including landlords fixtures & fittings. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 17 gen 1968 Consegnato il 25 gen 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Deed of assurances for further securing debenture stock of the british land co LTD amounting to £3,500,000 secured by a trust deed dated 30/4/62 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari 166-168 western rd, 1-5 crown st, brighton; 31-33 high st, 2,2A,3 & 4 skinner st, newport with landlords fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 19 ott 1967 Consegnato il 24 ott 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Further securing £3,500,000 the british land co. LTD debenture stock secured by a trust deed of 30-4-62 & deeds supp.thereto. | |
Brevi particolari 39, dover st., & 118 berkeley st., London W.19 & landlords fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 22 apr 1966 Consegnato il 05 mag 1966 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Deed of assurance for further securing ukp 1,826.320 denbenture stock of the british land company LTD. Secured by a trust deed dated 30.4.62 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari Zetland house, marloes rd, kensington, london W8; 495 high rd, wembley, great london; 9 high st, harpenden, hants; quality court, chancery, london WC2 & land & fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 26 mar 1964 Consegnato il 08 apr 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Trust deed securing debenture stock amounting to £1,826,320 of the british land company LTD inclusive of £1,204,000 secured by a trust deed dated 30/04/62 and deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari Various properties at liverpool and london (see doc for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage by way of substituted security | Creato il 31 gen 1956 Consegnato il 09 feb 1956 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito $650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34 | |
Brevi particolari 84A high st, stony stratford, bucks. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage by way of substituted security | Creato il 19 ott 1954 Consegnato il 25 ott 1954 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34 | |
Brevi particolari Freehold york house, york street, st. Marylebone, london 27 silver street, gainsborough, lancs. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 20 set 1951 Consegnato il 01 ott 1951 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34 | |
Brevi particolari 99, sandgate road, folkstone, kent. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 11 mag 1951 Consegnato il 23 mag 1951 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £650,000 debenure stock secured by a trust deed dated 19/1/34 | |
Brevi particolari 495, high road, wembley, middx. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 ott 1950 Consegnato il 17 ott 1950 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £650,000 debenture stock secured by a trust deed dated 19/1/34 | |
Brevi particolari Various properties for details see particular doc no:66. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 14 mar 1935 Consegnato il 02 apr 1935 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £55,000 | |
Brevi particolari Property at buttersea london, islington braintree, romford, southard, richard liverpool & wallasey. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Series of debentures | Creato il 19 gen 1934 Consegnato il 30 gen 1934 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0