TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED

TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00283092
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    • (7440) /

    Dove si trova TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAIDEN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED25 giu 199125 giu 1991
    ARTHUR MAIDEN LIMITED29 dic 193329 dic 1933

    Quali sono gli ultimi bilanci di TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2012

    9 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    13 pagineF10.2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2012

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2012

    10 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    14 pagine2.34B

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ in data 26 mag 2011

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 gen 2011

    13 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 lug 2010

    13 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    33 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    9 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da 186 City Road London EC1V 2NT in data 26 gen 2010

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG04

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2009

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 nov 2009

    Stato del capitale al 14 nov 2009

    • Capitale: GBP 1,460,225
    SH01

    legacy

    5 pagine395

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    30 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    22 pagineAA

    legacy

    8 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    BritishDirector122298900001
    ALLMAN, Donald Russell
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Amministratore
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    UsaChief Executive Officer113088010001
    APFELBAUM, William Michael
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Amministratore
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    AmericanDirector113086280001
    ARNOLD, Stephen Ronald
    19 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    Amministratore
    19 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    BritishDirector85488020002
    GOLDSMITH, Scott
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Amministratore
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    AmericanAttorney111559610001
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritishDirector122298900001
    MOUG, Andrew John
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    Amministratore
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    EnglandBritishConsultant85481770002
    SLATKIN, Jonathan Aaron
    Flat 36 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Amministratore
    Flat 36 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    UsaDirector117628600001
    HOLME, Michael Alan Holt
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    British45837310001
    SAVAGE, Timothy John
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    Segretario
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    British8871460006
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    BritishFinance Director114617510001
    BLACKBURN, Richard James
    9 Sandes Close
    SN15 2NH Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    9 Sandes Close
    SN15 2NH Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishSales Director85487950001
    BLAKESLEY, Graham
    9 Salmons Mews
    West Cottages
    NW6 1RH London
    Amministratore
    9 Salmons Mews
    West Cottages
    NW6 1RH London
    BritishCompany Director41933580002
    BOUCHEZ, Helena Mary
    51 Grove Way
    KT10 8HQ Esher
    Surrey
    Amministratore
    51 Grove Way
    KT10 8HQ Esher
    Surrey
    IrishDirector85488050001
    CECILE-PRITCHARD, Joan Emily
    Penn Ridge
    Church Road Penn
    HP10 8NU High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Penn Ridge
    Church Road Penn
    HP10 8NU High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director1526040001
    DRON, David John Anthony
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    BritishCompany Director1730460002
    FERNLEY, Roger Laurence
    50 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    50 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector44036150004
    GOODWIN, Francis Dominic
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    Amministratore
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    United KingdomUnited KingdomJoint Managing Director127055040001
    GOULD, Catherine Ann
    62a Aberdeen Road
    N2 2XB London
    Amministratore
    62a Aberdeen Road
    N2 2XB London
    BritishMarketing Director85487800001
    HALDEN, Simon Mark
    Ground Floor Flat 60 Prebend Gardens
    W6 0XU London
    Amministratore
    Ground Floor Flat 60 Prebend Gardens
    W6 0XU London
    BritishCompany Director76543560001
    HARTLEY, Garry Robert
    8 De Pirenore
    Hazlemere
    HP15 7FQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 De Pirenore
    Hazlemere
    HP15 7FQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDevelopment Director15306460004
    HOLME, Michael Alan Holt
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director45837310001
    KEARNS, Martin Paul
    15 Cambrian Road
    E10 7JE London
    Amministratore
    15 Cambrian Road
    E10 7JE London
    United KingdomBritishSales Director142291100001
    MACEY, Julian Spencer
    50 Weston Park
    KT7 0HL Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    50 Weston Park
    KT7 0HL Thames Ditton
    Surrey
    BritishCompany Director63444820001
    MAIDEN, Ian Arthur
    38 Old Church Street
    Chelsea
    SW3 5BY London
    Amministratore
    38 Old Church Street
    Chelsea
    SW3 5BY London
    BritishCompany Director41370001
    MILES, Philip Howard
    32b Westwell Road
    SW16 5RT London
    Amministratore
    32b Westwell Road
    SW16 5RT London
    BritishSales Director85487990001
    POWELL, Ian
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant33706140001
    PUGH, David John
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    Amministratore
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    BritishMarketing Director70814670001
    REAY, Alison
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    Amministratore
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    EnglandBritishConsultant113085780001
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    BritishFinance Director114617510001
    WARD, Hazel Patricia Alexandra
    Tudor Dean Homedean Road
    Chipstead
    TN13 2QN Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Tudor Dean Homedean Road
    Chipstead
    TN13 2QN Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishSales Director34911180002
    ZEGHIBE, Ronald William
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    Amministratore
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    United KingdomAmericanManaging Director51349440001

    TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 14 ago 2009
    Consegnato il 21 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed continuing mortgage rights title interest and benefit from time to time present and future under and in respect of each of the asset purchase agreement see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Electric Capital Corporation
    Transazioni
    • 21 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 15 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Electric Capital Corporation
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Security agreement
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 07 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, intellectual property and miscellaneous. Floating charge all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 07 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 giu 2004
    Consegnato il 18 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    £25,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit balance.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 18 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 19 lug 2002
    Consegnato il 05 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from maiden group PLC to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 giu 1995
    Consegnato il 29 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    L/H property k/a 14 half moon street london ngl 459043. l/h property k/a fifth floor, churchill house titheborn street liverpool (MS108483). L/h property k/a suite 15 floor c josephs well westgate leeds. L/h property k/a part first floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a part second floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a unit 2 22/24 granville street birmingham.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co. Limitedthe "Security Agent"
    Transazioni
    • 29 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 apr 1995
    Consegnato il 25 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) top the chargee under each or any of the finance documents or any other document
    Brevi particolari
    See shedule attached to form M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co. Limited(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders (as Defined)
    Transazioni
    • 25 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 apr 1993
    Consegnato il 22 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with each of the financing documents (all as defined)
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 and contd sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (In It's Capacity as Security Trustee) and the Banks
    Transazioni
    • 22 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 1987
    Consegnato il 06 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock-in-trade worrk-in-progress prepayments, investments and cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 06 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on book debts.
    Creato il 29 giu 1987
    Consegnato il 04 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of deposit
    Creato il 15 lug 1985
    Consegnato il 17 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys deposited by the chargee in the name of the company with investors in industry group PLC.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 12 lug 1979
    Consegnato il 19 lug 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 9.5.77.
    Brevi particolari
    Fixed charge on f/h plot of land known as 37 osborne rd, bedminster, bristol, together with seven lock up garages and buildings erected thereon all of which are shown edged red on the plan filed under title no av 21311.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transazioni
    • 19 lug 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge registrered pursuant to an order of court dated 12.9.78 (M81)
    Creato il 03 lug 1978
    Consegnato il 15 set 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 9.5.77
    Brevi particolari
    Properties under title nos: ln 167384, 229306, sy 117493, ln 23968, 413203, 331602, 93569, 341725, 328947, 316167, 439386, 294908, sgl 152935, ln 167380, 357779, k 50662, mx 436927, sy 7040, ln 15153 with all building & fixtures (including, trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transazioni
    • 15 set 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 mag 1977
    Consegnato il 20 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing the monies advanced under the terms of an agreement dated 9/5/77 all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All book and other debts see doc M79 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    Transazioni
    • 20 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 26 apr 1977
    Consegnato il 02 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge: (see doc m 78). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 giu 2011Fine dell'amministrazione
    18 gen 2010Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DataTipo
    06 dic 2013Data di scioglimento
    16 giu 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0