BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00283556 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
- Commercio al dettaglio di orologi e gioielli in negozi specializzati (47770) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Concessione di credito da parte di istituti finanziari non depositari e altri concedenti specializzati di credito al consumo (64921) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
T. M. SUTTON LIMITED | 10 gen 1934 | 10 gen 1934 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 giu 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 mar 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 26 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 10 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 26 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2023 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2022 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Litmus Finance Limited come persona con controllo significativo il 25 mag 2022 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Nathan & Co (Birmingham) Limited come persona con controllo significativo il 25 mag 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Nomina di Mr David Bowles come amministratore in data 25 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Ashley come amministratore in data 25 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Andrew Richardson come amministratore in data 25 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Susanne Gray come amministratore in data 25 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2021 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2020 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2019 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 002835560007, creata il 18 nov 2019 | 5 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Ms Lisa Gray come amministratore in data 06 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Staadecker come amministratore in data 06 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sheraz Afzal come amministratore in data 08 mag 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew James Smith come amministratore in data 08 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2018 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFZAL, Sheraz | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 | England | British | Chief Risk Officer | 251073350001 | ||||
BOWLES, David | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 | England | British | Company Director | 120417090002 | ||||
RICHARDSON, James Andrew | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 | England | British | Company Director | 193813560001 | ||||
BIONDI, Lorna | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 196294620001 | |||||||
FISHER, Mark | Segretario | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | Director | 61931900002 | |||||
FISHER, Mark | Segretario | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | Head Of Operations | 61931900002 | |||||
GOLD, Nick | Segretario | 126 Hamilton Terrace St John's Wood NW8 9UT London | British | 111562560001 | ||||||
GREGG, Terence Michael | Segretario | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
HARRINGTON, Nicholas Joseph | Segretario | 9 Kingsmead Avenue KT4 8XB Worcester Park Surrey | British | 1273670001 | ||||||
MCKENZIE, Robbie | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195401610001 | |||||||
PAGE, Elizabeth | Segretario | Flat 3 5 St Leonards Road, Ealing W13 8PN London | British | 34006010001 | ||||||
PRIOR, Mark Lee | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178840320001 | |||||||
REID, Michael John | Segretario | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
RIVERS, Paul Edward | Segretario | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | Finance Director | 62321110002 | |||||
WALTON, Caroline Debra | Segretario | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 151301400001 | ||||||
ADAMS, David Alexander Robertson | Amministratore | Applegarth Three Elm Lane Hadlow TN11 0AB Tonbridge Kent | England | British | Group Finance Dir | 55757700003 | ||||
ASHLEY, Jonathan | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 | United Kingdom | American | Non Executive Director | 243931650001 | ||||
ATTALLAH, Naim Ibrahim | Amministratore | Flat 15 51 South Street W1Y 5PA London | United Kingdom | British | Business Executive | 25646240001 | ||||
BERKMEN, Gillian | Amministratore | Orchard View 27 Woodhill Avenue SL9 8DP Gerrards Cross South Buckinghamshire | Gb | British | Director | 92154270001 | ||||
BRAGG, Roy Alec | Amministratore | 80 West Hill KT19 8LF Epsom Surrey | British | Jeweller | 14124670001 | |||||
BRAY, Jeffrey | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | United Kingdom | United States | Business Executive | 176044030001 | ||||
BROWN, Andrew Saville | Amministratore | 123 Edenfield Gardens KT4 7DX Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | Director | 69874610002 | ||||
BRYAN, Robert Andrew | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | Marketing Director | 122733810001 | ||||
CLARK, Keith Dudley | Amministratore | Brock House 30 The Hedgerow Grove Green ME14 5TG Maidstone Kent | British | Director | 30702450003 | |||||
CLAYMAN, Paul Sidney | Amministratore | 18 Keepier Wharf 12 Narrow Street E14 8DH London | British | Jeweller | 14436120006 | |||||
COOPER, Caroline | Amministratore | 222 Caraway 2 Cayenne Court 32 Shad Thames SE1 2PP London | British | Director | 92733900001 | |||||
COREPAL, Sanjiv Kumar | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | United Kingdom | British | Retail Director | 205239750001 | ||||
DAHL, Ian Xavier | Amministratore | 2 Heathfield Lodge Carron Lane GU29 9LD Midhurst West Sussex | British | Group Chief Executive | 66486140001 | |||||
DEAKIN, Tony | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 210862440001 | ||||
DIAPER, Philip Malcom | Amministratore | Stoneleigh Avenue KT4 8XZ Worcester Park 110 Surrey United Kingdom | British | Director | 141156800001 | |||||
ERICKSON, Eric George | Amministratore | Lancaster Avenue Suite 300 19312 Berwyn 1436 Usa | Usa | Usa | Business Executive | 224104020001 | ||||
EVANS, Nicholas David | Amministratore | 6 Raddington Road W10 5TF London | United Kingdom | British | Director | 57490310002 | ||||
FILECCIA, Piero | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | Finance Director | 116096800001 | ||||
FISHER, Mark | Amministratore | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | Head Of Operations | 61931900002 | |||||
GOLD, Nicholas Paul | Amministratore | 126 Hamilton Terrace St Johns Wood NW8 9UT London | England | British | Company Director | 53606570002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litmus Finance Limited | 25 mag 2022 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Nathan & Co (Birmingham) Limited | 06 apr 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BEAULY FINANCIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 18 nov 2019 Consegnato il 26 nov 2019 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 24 dic 2014 Consegnato il 24 dic 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 giu 2006 Consegnato il 08 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 nov 2005 Consegnato il 06 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties | Creato il 05 giu 2001 Consegnato il 13 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 24 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent | Creato il 24 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0