G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED

G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00283943
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED?

    • (5139) /
    • (5211) /

    Dove si trova G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2010

    Stato del capitale al 22 dic 2010

    • Capitale: GBP 7,000
    SH01

    Nomina di Laura Taylor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Charles Wilson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Laura Taylor come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jonathan Prentis come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Chilton come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Paul Prentis il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mark Chilton il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Segretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    155913670001
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    United KingdomBritish155913200001
    ATTWOOD, Paul Gerard
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    British72538660001
    BELTON, Doris Valerie
    49 Drayton Road
    Irthlingborough
    NN9 5TA Wellingborough
    Northamptonshire
    Segretario
    49 Drayton Road
    Irthlingborough
    NN9 5TA Wellingborough
    Northamptonshire
    British67694030001
    BLUNDELL, Anthony Thomas
    35 Woodlands Road
    Handforth
    SK9 3AU Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    35 Woodlands Road
    Handforth
    SK9 3AU Wilmslow
    Cheshire
    British20781850001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    Segretario
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    British78255980001
    CHILTON, Mark
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Segretario
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    British109675640001
    DAWSON, Jeffrey George
    14b Clare Street
    PE16 6EJ Chatteris
    Cambridgeshire
    Segretario
    14b Clare Street
    PE16 6EJ Chatteris
    Cambridgeshire
    British4976790001
    JOHNSON, Shirley Elizabeth
    25 Stoney Common
    CM24 8NF Stansted
    Essex
    Segretario
    25 Stoney Common
    CM24 8NF Stansted
    Essex
    British52701320001
    LAMB, Robin
    1 Huntford Lodge 20 Albert Drive
    SW20 0SS London
    Segretario
    1 Huntford Lodge 20 Albert Drive
    SW20 0SS London
    British47795300001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Segretario
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    THOMPSON, William John
    1 Broomhey Avenue
    WN1 2RA Wigan
    Lancashire
    Segretario
    1 Broomhey Avenue
    WN1 2RA Wigan
    Lancashire
    British20781800001
    APPLEBY, Geoffrey
    18 Briar Garth
    YO25 7UL Driffield
    North Humberside
    Amministratore
    18 Briar Garth
    YO25 7UL Driffield
    North Humberside
    British20781860001
    BLUNDELL, Anthony Thomas
    35 Woodlands Road
    Handforth
    SK9 3AU Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    35 Woodlands Road
    Handforth
    SK9 3AU Wilmslow
    Cheshire
    British20781850001
    BUSBY, Adrian John
    22 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British3445300001
    CAMP, Michael James
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish12204760003
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Amministratore
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    DYE, Simon John
    46 Albany Road
    NN1 5LZ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    46 Albany Road
    NN1 5LZ Northampton
    Northamptonshire
    British67908930001
    FLEXEN, John Michael
    Ochre Cottage
    Church Lane Wroxton
    OX15 6QT Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ochre Cottage
    Church Lane Wroxton
    OX15 6QT Banbury
    Oxfordshire
    British984380003
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Amministratore
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    United KingdomBritish48949090001
    RENTOUL, James Alexander
    1a Dartmouth Place
    W4 2RH London
    Amministratore
    1a Dartmouth Place
    W4 2RH London
    British58897290002
    RUSSELL, Michael John
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish48183050001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001
    THOMPSON, David George
    Astley Farm House
    Pendlebury Lane Haigh
    WN2 1LU Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Astley Farm House
    Pendlebury Lane Haigh
    WN2 1LU Wigan
    Lancashire
    British78518860001
    THOMPSON, Geoffrey William
    Heyes Farm Grimshaw Road
    Upholland
    WN8 6BH Skelmersdale
    Lancashire
    Amministratore
    Heyes Farm Grimshaw Road
    Upholland
    WN8 6BH Skelmersdale
    Lancashire
    British20781820001
    THOMPSON, Harry
    The Laurels Meadowcroft Lane
    Storrs Park
    LA23 3JJ Bowness-On-Windermere
    Cumbria
    Amministratore
    The Laurels Meadowcroft Lane
    Storrs Park
    LA23 3JJ Bowness-On-Windermere
    Cumbria
    British20781810001
    THOMPSON, John Malcolm
    Hillcourt 72 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Hillcourt 72 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    British20781830001
    THOMPSON, Keith Norman
    Winstanley House
    Haigh
    WN2 1LX Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Winstanley House
    Haigh
    WN2 1LX Wigan
    Lancashire
    British5258940001
    THOMPSON, William John
    1 Broomhey Avenue
    WN1 2RA Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    1 Broomhey Avenue
    WN1 2RA Wigan
    Lancashire
    British20781800001
    TUTT, Trevor
    Bankside 41a Crookham Road
    GU13 8DT Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Bankside 41a Crookham Road
    GU13 8DT Fleet
    Hampshire
    British47665580001
    WILSON, Charles
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    Amministratore
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    United KingdomBritish123998480001

    G. THOMPSON (PROVISION MERCHANTS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 04 gen 1991
    Consegnato il 17 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000
    Brevi particolari
    Land and buildings at stephens way, goose green, wigan in the county of greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Burtonwood Brewery PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 feb 1987
    Consegnato il 04 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H - 1 penrose place, pimbo industrial area skelmersdale lancashire and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 22 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 dic 1986
    Consegnato il 29 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H - land & buildings at sutton fields industrial estate, kingston upon hull. Humberside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 dic 1986
    Consegnato il 22 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 set 1986
    Consegnato il 25 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H enterprise buildings poolstock wigan, greater manchester.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Girobank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 gen 1986
    Consegnato il 16 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First charge over all book debts & all rights relating thereto inc. Negotiable instruments legal & equitable charges second the goodwill & un-called capital of the company both present and future third the undertaking and all property and assets present and future including heritable and all other property & assets in scotland.
    Persone aventi diritto
    • Girobank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0