H.C.GRIMSTEAD LIMITED

H.C.GRIMSTEAD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàH.C.GRIMSTEAD LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 00284156
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di H.C.GRIMSTEAD LIMITED?

    • Servizi funebri e attività connesse (96030) / Altre attività di servizi

    Dove si trova H.C.GRIMSTEAD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di H.C.GRIMSTEAD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per H.C.GRIMSTEAD LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per H.C.GRIMSTEAD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    CERTIPS

    Varie

    Forms b & z convert to i&ps
    1 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to i&ps 06/11/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ago 2012

    Stato del capitale al 10 ago 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Andrew Oldale come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Walker come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Hendry come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Samuel Patrick Donald Kershaw il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil James Walker il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr George Murray Tinning il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Caroline Jane Sellers il 31 lug 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Buchan Hendry il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2010

    3 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 10 gen 2009

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 12 gen 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di H.C.GRIMSTEAD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Segretario
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    British45801060004
    KERSHAW, Samuel Patrick Donald
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Amministratore
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    EnglandBritish101845900003
    OLDALE, Andrew
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    Amministratore
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Amministratore
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    United KingdomBritish126913730001
    GREENFIELD, Phillip Lee Richard
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    Segretario
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    British161062970001
    MITCHELL, Clare Marion
    111 Wolsey Drive
    KT2 5DR Kingston
    Surrey
    Segretario
    111 Wolsey Drive
    KT2 5DR Kingston
    Surrey
    British72762420001
    PANTELI, Andreas
    61 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    Segretario
    61 Ashley Road
    KT18 5BN Epsom
    Surrey
    British109275700001
    SMITH, Ian Christopher Vincent
    52 Barton Road
    TQ1 4DW Torquay
    Devon
    Segretario
    52 Barton Road
    TQ1 4DW Torquay
    Devon
    British6378870001
    BECKETT ALLEN, Anne
    The Thatched Cottage
    Bungay Road Scole
    IP21 4DT Diss
    Norfolk
    Amministratore
    The Thatched Cottage
    Bungay Road Scole
    IP21 4DT Diss
    Norfolk
    EnglandEnglish64862160006
    CARPENTER, Paul Kenneth Christopher
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    Amministratore
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    British119893930001
    GREENFIELD, Phillip Lee Richard
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    Amministratore
    Wharf Road
    OX10 7EW Shillingford
    The Nook
    Oxfordshire
    EnglandBritish161062970001
    HENDRY, David Buchan
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Amministratore
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    ScotlandBritish128555100001
    HENDRY, David Buchan
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    Amministratore
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    ScotlandBritish128555100001
    HEWITT, Paul William
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish163759450001
    HOLMES, Susan
    14 The Avenue
    RG45 6PD Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    14 The Avenue
    RG45 6PD Crowthorne
    Berkshire
    British67967870001
    HULME, Martyn Alan
    20 Walton Heath Drive
    SK10 2QN Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    20 Walton Heath Drive
    SK10 2QN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish77326830003
    SMITH, Ian Christopher Vincent
    52 Barton Road
    TQ1 4DW Torquay
    Devon
    Amministratore
    52 Barton Road
    TQ1 4DW Torquay
    Devon
    British6378870001
    SMITH, Lorna Patricia
    52 Barton Road
    TQ1 4DW Torquay
    Devon
    Amministratore
    52 Barton Road
    TQ1 4DW Torquay
    Devon
    British6378880001
    TAYLOR, Nicholas Vincent
    Moat Farm Upgate Street
    Bedingham
    NR35 2AT Bungay
    Amministratore
    Moat Farm Upgate Street
    Bedingham
    NR35 2AT Bungay
    British23452670004
    TINNING, George Murray
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    Amministratore
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    United KingdomBritish126913730001
    VAN LANSCHOT HUBRECHT, Jean Henri
    9 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 Misbourne House
    Amersham Road
    HP8 4RY Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandDutch63934990003
    WALKER, Neil James
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    Amministratore
    New Century House
    Manchester
    M60 4ES
    EnglandBritish126913860001

    H.C.GRIMSTEAD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 24 giu 1998
    Consegnato il 30 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 58 swan road west drayton middlesex t/no MX281827. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 set 1990
    Consegnato il 13 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 ago 1987
    Consegnato il 21 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The servery churchfield road chalfort street st peter buckinghamshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mar 1986
    Consegnato il 03 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    36 high street, harefield, hillingdon, london title no ngl 470305 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 12 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of whole
    Creato il 09 feb 1965
    Consegnato il 17 feb 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    The benefit of a charge dated 11TH jan 1965 on part of no 9 cowley rd, uxbridge middx.
    Persone aventi diritto
    • Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 17 feb 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 dic 1963
    Consegnato il 03 gen 1964
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    62 high street, ruislip middx.
    Persone aventi diritto
    • Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 03 gen 1964Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 mag 1959
    Consegnato il 15 giu 1959
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc
    Brevi particolari
    9 cowley road, uxbridge, middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 15 giu 1959Registrazione di un'ipoteca
    • 28 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0