JTB REALISATIONS LIMITED

JTB REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJTB REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00288766
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JTB REALISATIONS LIMITED?

    • Commercio al dettaglio di calzature in negozi specializzati (47721) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova JTB REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JTB REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A. JONES & SONS LIMITED04 giu 193404 giu 1934

    Quali sono gli ultimi bilanci di JTB REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per JTB REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    32 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    32 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    36 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed A. jones & sons LIMITED\certificate issued on 03/05/17
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 apr 2017

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    44 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 09 apr 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2016 al 28 feb 2017

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Simon Edward Cook come amministratore in data 27 gen 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David John Riddiford come amministratore in data 19 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Robert Short come amministratore in data 06 ott 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 002887660014 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 002887660018, creata il 22 set 2016

    70 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da A Jones & Sons Limited Interlink Way West, Interlink Business Park Bardon Coalville Leicestershire LE67 1LD England a Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG in data 08 ago 2016

    1 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di JTB REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KILLICK, Michael David
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    WalesBritishCfo75927820002
    RIDDIFORD, David John
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishExecutive Chairman220918310001
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    British10571470001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    BritishFinance Director109143970003
    WHITE, Andrew Robert
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    Segretario
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    British159789980001
    BARTLE, Kenneth
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector73909180007
    BARTLE, Kenneth
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishRetail Consultant73909180007
    BOOT, Terry Michael
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCfo67041160001
    CHURCH, John George
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant12963560001
    CLARK, Lancelot Pease
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    Amministratore
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    BritishManager28161570002
    COOK, Simon Edward
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCpo104673410002
    COORENS, Eric Maria Hendrikus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Operating Officer157586370001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director121560001
    DE MOOR, Frank Karel
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    BelgiumBelgianChief Executive Office159745220001
    DUNCAN SMITH, Alastair David
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    Amministratore
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    BritishBusiness Manager69076490001
    HUNEN, Peter Therese Antoon
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Secretary159744910001
    JELINEK, Vaclav
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    BritishRetail Executive109139210002
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant10571470001
    KENNEDY, Iain Manning
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director187882990001
    NOBLE, Alison Jane Bennett
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    Amministratore
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    United KingdomBritishRetail Buyer103289830002
    PHILLIPS, Peter John
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51075400001
    PHILLIPS, Peter John
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    BritishCompany Director51075400002
    SHORT, David Robert
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCeo38957690003
    SHORTEN, Paul William
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    Amministratore
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    BritishCompany Director33661480001
    STRIJBOS, Theodorus Leonardus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Financial Officer157586510001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director109143970003
    WALTON JONES, Howard
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    Amministratore
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    BritishCompany Director20804560001
    WATKINSON, John Dudley
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    Amministratore
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    EnglandBritishDirector66949520004
    WHITE, Andrew Robert
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector146324190001

    JTB REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 set 2016
    Consegnato il 28 set 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P.
    Transazioni
    • 28 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 feb 2016
    Consegnato il 17 feb 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P. (The Security Agent)
    Transazioni
    • 17 feb 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 ott 2015
    Consegnato il 02 nov 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe L.P. (As Secuirty Agent)
    Transazioni
    • 02 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 ott 2015
    Consegnato il 02 nov 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P. (As Security Agent)
    Transazioni
    • 02 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 14 nov 2014
    Consegnato il 25 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. (The "Security Agent") as Trustee for Each of the Secured Parties
    Transazioni
    • 25 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 nov 2014
    Consegnato il 25 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., Acting in Its Capacity of Security Agent (The "Secured Party" Which Expression Includes Its Successors and Assigns)
    Transazioni
    • 25 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 set 2010
    Consegnato il 18 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 16 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 02 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2002
    Consegnato il 21 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 2002
    Consegnato il 23 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental mortgage to a debenture dated 22 february 2001,
    Creato il 16 ago 2001
    Consegnato il 03 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever, of each obligor to the lender
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the property being all that l/h premises k/a 53 west street horsham west sussex, all that l/h premises k/a number 30-32 the promenade cheltenham gloucestershire, all that l/h premises k/a 40 high street reigate surrey RH2 9AT, all that l/h premises k/a 103-105 terminus road eastbourne east sussex, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 03 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture to a debenture dated 22 february 2001 made between (amongst others) the chargor and burdale financial limited
    Creato il 10 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (all terms as defined)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all of its right title and interest in and to the additional collection account and all monies standing to the credit of the additional collection account and the debts represented by them. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 feb 2001
    Consegnato il 07 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the facility agreement (all terms as defined)
    Brevi particolari
    In order to provide continuing security for the payment or performance of the obligation in the agreement the obligor vested possession of the certificates of title to the collateral in the secured party (or its agent) to the intent that the secured party should have a security interest or interests in the collateral in accordance with article 2 (3) of the 1983 law but so that the secured party should not in any circumstances incur any liability or be under any obligation whatsoever in connection with the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 07 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture made between, amongst others, the company and the chargee
    Creato il 22 feb 2001
    Consegnato il 07 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 07 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 22 feb 2001
    Consegnato il 07 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and in accordance with the terms of an agreement of even date
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Church & Co PLC
    Transazioni
    • 07 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 20 apr 1995
    Consegnato il 21 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First floor office premises at 56 hanover street edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Amicable Life Assurance Society Limited
    Transazioni
    • 21 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    JTB REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2017Inizio dell'amministrazione
    05 apr 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0