BAGIR (WIGAN) LIMITED

BAGIR (WIGAN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBAGIR (WIGAN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00291012
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BAGIR (WIGAN) LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature (46420) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova BAGIR (WIGAN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit J209, The Biscuit Factory
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BAGIR (WIGAN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CASUAL SPORTSWEAR LIMITED08 ago 193408 ago 1934

    Quali sono gli ultimi bilanci di BAGIR (WIGAN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BAGIR (WIGAN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Yehuda Cohen come amministratore in data 16 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Samuel Vlodinger come amministratore in data 16 feb 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ago 2016

    Stato del capitale al 01 ago 2016

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Units 13-15 Deane House Studios Greenwood Place Highgate Rd Kentish Town London NW5 1LB a Unit J209, the Biscuit Factory 100 Clements Road London SE16 4DG in data 01 ago 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Eran Itzhak come amministratore in data 14 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Shalom Taragan come amministratore in data 01 nov 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ago 2015

    Stato del capitale al 11 ago 2015

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Cessazione della carica di Neville Critoph come segretario in data 10 lug 2015

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Neville Critoph come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Robin Harrison come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2013

    Stato del capitale al 30 lug 2013

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Robin Harrison come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Shlomo Moran come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di BAGIR (WIGAN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COHEN, Yehuda
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    Amministratore
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    IsraelIsraeli225109430001
    ITZHAK, Eran
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    Amministratore
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    IsraelIsraeli205573810001
    BLATT, Eliezer Leo
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Segretario
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Israeli31826280001
    CRITOPH, Neville
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Rd Kentish Town
    London
    Segretario
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Rd Kentish Town
    London
    180879700001
    FACKEY, Brian Arthur
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    British9935990001
    HARRISON, Robin
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Rd Kentish Town
    London
    Segretario
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Rd Kentish Town
    London
    171659890001
    HARRISON, Robin
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Segretario
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British16332500001
    LEWIS, David John
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    Segretario
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    British15641380006
    MELLOTTE, Joseph Thomas
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Segretario
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Irish14873920001
    MORAN, Shlomo
    Jabotinsky
    70700 Gedera
    15
    Israel
    Segretario
    Jabotinsky
    70700 Gedera
    15
    Israel
    Israeli130425510001
    ROTH, Ilan
    25 Hagalil Street
    Kfar Sava
    Israel
    Segretario
    25 Hagalil Street
    Kfar Sava
    Israel
    British78138620001
    ABRAMOVITCH, Doron
    8b Hazait Street Neva Yehuda
    Rehovot
    Israel
    Amministratore
    8b Hazait Street Neva Yehuda
    Rehovot
    Israel
    IsraelIsraeli114357690001
    BLATT, Eliezer Leo
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Amministratore
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Israeli31826280001
    BROWN, Mordechai
    PO BOX 187
    Kiryat Gat 82100
    Israel
    Amministratore
    PO BOX 187
    Kiryat Gat 82100
    Israel
    Israeli40071100001
    FACKEY, Brian Arthur
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    British9935990001
    GILBOA, Offer
    Ramot Hashavim
    FOREIGN Beit Ha'Am 13
    Israel
    Amministratore
    Ramot Hashavim
    FOREIGN Beit Ha'Am 13
    Israel
    IsraelIsraeli68581430002
    HARRISON, Robin
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British16332500001
    LANDAU, Schmuel
    19 Hibner Street
    Petach Tikva
    49400 Israel
    Amministratore
    19 Hibner Street
    Petach Tikva
    49400 Israel
    Israeli71013940001
    LANGLEIB, Moshe
    Pob 187
    Kiryat Gat 82100
    FOREIGN
    Israel
    Amministratore
    Pob 187
    Kiryat Gat 82100
    FOREIGN
    Israel
    Israeli14873910001
    LEWIS, David John
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    British15641380006
    MELLOTTE, Joseph Thomas
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Amministratore
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Irish14873920001
    PATRON, Gershon
    PO BOX 1877
    Kiryat Gat82100
    Israel
    Amministratore
    PO BOX 1877
    Kiryat Gat82100
    Israel
    Israeli37125540001
    RONEN, Micha
    Golani 82
    Kfar Yona
    Israel
    Amministratore
    Golani 82
    Kfar Yona
    Israel
    Israeli96878320001
    SADOT, Shmuel
    60 Levin Epstein Str
    Rehovot
    Israel
    Amministratore
    60 Levin Epstein Str
    Rehovot
    Israel
    Israeli44039540001
    TARAGAN, Daniel Shalom
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Rd Kentish Town
    London
    Amministratore
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Rd Kentish Town
    London
    IsraelIsraeli164669360001
    VLODINGER, Samuel
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    Amministratore
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    IsraelIsraeli164669140001
    WALTERS, Raymond Archibald
    Nightingale Cnr Nightingale Road
    Bushey
    WD2 3NJ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Nightingale Cnr Nightingale Road
    Bushey
    WD2 3NJ Watford
    Hertfordshire
    British52046110001

    BAGIR (WIGAN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge by way of assignment over cash deposit
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 04 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right, title, benefit and interest in a deposit account with united mizrahi bank limited together with all sums deposited therein or standing to the credit thereof and all interest.
    Persone aventi diritto
    • Courtaulds Textiles Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 ott 1984
    Consegnato il 25 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc M107 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Banks Hafoalim Bm
    Transazioni
    • 25 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0