GALLIC SHIPPING LIMITED

GALLIC SHIPPING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGALLIC SHIPPING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00293575
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GALLIC SHIPPING LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova GALLIC SHIPPING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Aquarium
    1-7 King Street
    RG12 7GJ Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GALLIC SHIPPING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per GALLIC SHIPPING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 apr 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 gen 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 gen 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 mar 2006

    7 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di GALLIC SHIPPING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GAULT, Jonathan James Leslie
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    Segretario
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    British11059570005
    FAIRHURST, George Trevor St John
    Myers
    Iping Road, Milland
    GU30 7NA Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    Myers
    Iping Road, Milland
    GU30 7NA Liphook
    Hampshire
    British35359510003
    GAULT, Jonathan James Leslie
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    EnglandBritish11059570005
    MILNER, Keith
    38 Deep Spinney
    MK40 4QH Biddenham
    Bedfordshire
    Segretario
    38 Deep Spinney
    MK40 4QH Biddenham
    Bedfordshire
    British78429440001
    PATEL, Bihesh
    9 Magnolia Court
    The Mall
    HA3 9UB Harrow
    Middlesex
    Segretario
    9 Magnolia Court
    The Mall
    HA3 9UB Harrow
    Middlesex
    British98979900001
    SAVADIA, Nitin Devchand
    52 Hillbury Avenue
    Kenton
    HA3 8EW Harrow
    Middlesex
    Segretario
    52 Hillbury Avenue
    Kenton
    HA3 8EW Harrow
    Middlesex
    British14455810001
    BROWN, James David Denholm
    Swains
    Marlpost Road Southwater
    RH13 9BY Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Swains
    Marlpost Road Southwater
    RH13 9BY Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish33538540001
    DE COURCY IRELAND, Jonathan Laurence Stanley
    19 Offerton Road
    SW4 0DJ London
    Amministratore
    19 Offerton Road
    SW4 0DJ London
    British68047940002
    FRANKLIN, Jonathan Michael
    Knodishall Hall
    IP17 1TP Saxmundham
    Suffolk
    Amministratore
    Knodishall Hall
    IP17 1TP Saxmundham
    Suffolk
    United KingdomBritish15312550001
    GAULT, Christopher John Hamilton
    4 Paradise Lawn
    EX36 3DJ South Molton
    North Devon
    Amministratore
    4 Paradise Lawn
    EX36 3DJ South Molton
    North Devon
    British23531990003
    GAULT, David Hamilton
    Kent House
    East Harting
    GU31 5LS Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Kent House
    East Harting
    GU31 5LS Petersfield
    Hampshire
    British1886870002
    GAULT, Simon Angus Graham Leslie
    Field Farm
    Iden Green
    TN17 4HF Benenden
    Kent
    Amministratore
    Field Farm
    Iden Green
    TN17 4HF Benenden
    Kent
    United KingdomBritish100905450001
    SAVADIA, Nitin Devchand
    52 Hillbury Avenue
    Kenton
    HA3 8EW Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    52 Hillbury Avenue
    Kenton
    HA3 8EW Harrow
    Middlesex
    EnglandBritish14455810001
    TATTERSALL, John Richard
    51 Cobden Hill
    WD7 7JL Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    51 Cobden Hill
    WD7 7JL Radlett
    Hertfordshire
    British1886890001
    THORNTON, Adrian Heber
    31 Cheyne Row
    SW3 5HW London
    Amministratore
    31 Cheyne Row
    SW3 5HW London
    British218050001
    THORNTON, Margaret Marion Gwendolen
    Mulberry House
    GU8 6AN Shackleford Nr Godalming
    Kent
    Amministratore
    Mulberry House
    GU8 6AN Shackleford Nr Godalming
    Kent
    British22957980001
    TRECHMAN, Gavin
    8 Paultons Street
    SW3 5DP London
    Amministratore
    8 Paultons Street
    SW3 5DP London
    British35249390001

    GALLIC SHIPPING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 08 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The following shares in the share capital of hebridean cruises PLC 2,003,131 oridinary shares of £0.50 each and 50,000 non-bes shares of £0.50 each.
    Persone aventi diritto
    • Forty Eight Shelf (149) Limited
    Transazioni
    • 08 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Bank account charge
    Creato il 12 mar 1998
    Consegnato il 13 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee pursuant to the loan agreement or any of the security documents or the bank account charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the account of the company with the bank and the deposits (as defined in the bank account charge) and all and any right to the repayment of all or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counter indemnity of customer incorporating a legal charge over cash
    Creato il 07 lug 1997
    Consegnato il 10 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a guarantee of even date
    Brevi particolari
    Full cash cover held in the name of the bank held on a separate account styled rbs provision for guarantee no. 7187 re gallic shipping LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 mar 1991
    Consegnato il 08 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or gallic managementcompany limited to the chargee not exceeding £800,000 under the terms of the security document (as defined)
    Brevi particolari
    All dividents, benefit and interests in shares in black watch limited (see doc M920C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Guiness Mahon and Co LTD
    Transazioni
    • 08 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 23 set 1988
    Consegnato il 05 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    $2,600,000 and all other moneys due or to become due from gallic shipping international S.a to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/9/88 and under the terms of the mortgage and the security document
    Brevi particolari
    All of the company's interest right & title to and in the stock of gallic shipping limited (whether issued or to be issued).
    Persone aventi diritto
    • Scandinavian Bank Group PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 mag 1985
    Consegnato il 13 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on and account current under the terms of a facility letter dated 22/6/83 a letter of confirmation dated 30/5/84 and a deed of covenant dated 13/5/85
    Brevi particolari
    Motorship "leslie gault" registered at douglas isle of man no.377334 For full details see doc.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 13 mag 1985
    Consegnato il 13 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 22/6/83, a lette of confirmation dated 30/5/84 and a mortgage dated 13/5/85
    Brevi particolari
    All rights title and interest on the vessel and all monies from contracts policies or earnings as defined of the deed of covenant.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Statutory mortgage
    Creato il 23 nov 1983
    Consegnato il 23 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a facility letter dated 22/6/83 and a deed of covenant dated 17/11/83
    Brevi particolari
    Sixteen sixteenth shares in the fishing boat "gallic may" registered at the port of buckie under port number bck 108.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenants
    Creato il 17 nov 1983
    Consegnato il 23 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current secured by a charge dated 17/11/83 and under the terms of a facility letter dated 22/6/83
    Brevi particolari
    The mortgaged premises (being the ship, the insurances & all benefits thereof, the requisition compensation (as defined in the deed of covenants).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 17 nov 1976
    Consegnato il 19 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £1,050,000 together with a commitment commission of 1% o f that sum and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the owner's rights, interests and benefits under a building agreement ("the contract") dated 13TH october 1976 between appledove ship-builders limited ("the builder") and the company relating to the construction & purchase of a single-screw single deck bulk carrier to be known during construction as yard no AS116. ("The vessel") see doc 91 for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 17 nov 1976
    Consegnato il 19 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £1,050,000 together with a commitment commission of 1% o f that sum and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the owner's rights, interests and benefits under a building agreement ("the contract") relating to the construction & purchase of a single-screw single deck bulk carrier to be known during construction as yard S117 ("the vessel") (see doc 90 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 11 giu 1976
    Consegnato il 18 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing the monies secured by another charge dated 11/6/76.
    Brevi particolari
    The mortgaged premises (being the ship, the insurances, the earnings of the ship and requisition compensation as defined in the said deed of covenant).
    Persone aventi diritto
    • Nationale-Nederlander Scheepshypotheek Bank N.V.
    • Scheepshypotheek Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 18 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 11 giu 1976
    Consegnato il 18 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees on an account current under the terms of a loan agreement dated 30/3/76 and a deed of covenant dated 11/6/76.
    Brevi particolari
    Sixty-four sixty-fourth shares of and in M.V. "mary anderson" official no. 366201.
    Persone aventi diritto
    • Nationale-Nederlander Scheepshypotheek Bank N.V.
    • Scheepshypotheek Bank Nederland N. V.
    Transazioni
    • 18 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 02 apr 1976
    Consegnato il 21 apr 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing ukp 1,191,725.23 and all other moni es due or to become due from the company to the chargees secured by another charge dated 2/4/76
    Brevi particolari
    The mortgaged premises (being the ship, the insurances, the earnings of the ship and reguisition, compensation as defined in the said deed of covenant).
    Persone aventi diritto
    • Schupshypsiheek Bank Nedereland N.V.See Doc for Detaisl
    Transazioni
    • 21 apr 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory mortgage
    Creato il 02 apr 1976
    Consegnato il 21 apr 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Statutory mortgage for securing all monies now due or to become due from the company to the chargees on an account current under the terms of a loan agreement dated 30/3/76 and a deed of covenant dated 2/4/76
    Brevi particolari
    Sixty four sixty-fourth shares of and m M. V. "gallicminch" registered at the port of london under official no. 363443.
    Persone aventi diritto
    • Schupshypsiheek Bank Nederland N.V.See Doc for Details
    Transazioni
    • 21 apr 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GALLIC SHIPPING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 gen 2009Inizio della liquidazione
    13 lug 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gareth Wyn Roberts
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Praticante
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Paul Ellison
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Praticante
    Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0