RAMILLIES PROPERTIES LIMITED

RAMILLIES PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAMILLIES PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00294111
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    • Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. (42990) / Costruzioni
    • Altro commercio al dettaglio in negozi non specializzati (47190) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BURFORD DISTRICT LAUNDRY COMPANY,LIMITED(THE)16 nov 193416 nov 1934

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicholas John Mervyn Cook come amministratore in data 29 nov 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mrs Ann Veronica Spackman come persona con controllo significativo il 29 ago 2018

    2 paginePSC04

    Cessazione della carica di Ann Veronica Spackman come amministratore in data 29 ago 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Grahame Miller come amministratore in data 21 feb 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 nov 2015

    Stato del capitale al 18 nov 2015

    • Capitale: GBP 4,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 nov 2014

    Stato del capitale al 11 nov 2014

    • Capitale: GBP 4,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOK, John Patrick Mervyn
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    British142431340001
    COOK, John Patrick Mervyn
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish142431340001
    COOK, Jennifer Wendy
    Sturt Farm
    OX18 4ET Burford
    Oxford
    Segretario
    Sturt Farm
    OX18 4ET Burford
    Oxford
    British6056560005
    BETTERIDGE, Lucinda Margaret Venetia
    North Close
    Medmenham
    SL7 2EJ Marlow
    18
    Buckinghamshire
    Amministratore
    North Close
    Medmenham
    SL7 2EJ Marlow
    18
    Buckinghamshire
    British132746110001
    COOK, Jennifer Wendy
    Sturt Farm
    OX18 4ET Burford
    Oxford
    Amministratore
    Sturt Farm
    OX18 4ET Burford
    Oxford
    British6056560005
    COOK, Julian Michael Patrick
    49 Uxbridge Road
    W12 London
    Amministratore
    49 Uxbridge Road
    W12 London
    EnglandBritish34024730002
    COOK, Nicholas John Mervyn
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish132746390001
    FRANCIS, George Carwardine
    East Cliff
    Tutshill
    NP6 7PT Chepstow
    Monmouthshire
    Amministratore
    East Cliff
    Tutshill
    NP6 7PT Chepstow
    Monmouthshire
    British10464610001
    IRELAND, Frances Christianne Innes
    Witney Street
    OX18 4DQ Burford
    Tannery
    Oxfon
    Amministratore
    Witney Street
    OX18 4DQ Burford
    Tannery
    Oxfon
    EnglandBritish132746230001
    MILLER, Grahame
    Palace Street
    NR3 1RT Norwich
    15
    Norfolk
    England
    Amministratore
    Palace Street
    NR3 1RT Norwich
    15
    Norfolk
    England
    United KingdomBritish77645570001
    SPACKMAN, Ann Veronica
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish16834230001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RAMILLIES PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr John Patrick Mervyn Cook
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    18 ott 2016
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Executors Of Mrs Ann Veronica Spackman Deceased
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    18 ott 2016
    Sturt Farm
    Oxford Road Burford
    OX18 4ET Oxford
    Oxfordshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    RAMILLIES PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 05 mar 2008
    Consegnato il 18 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H sturt lodge, sturt lodge industrial estate, burford t/n ON200727 and all buildings and fixtures, fixed charge all rents see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Butterfield Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 18 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over bank account
    Creato il 25 lug 2006
    Consegnato il 03 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All or any of the amounts from time to time to the credit of the account numbered 76543000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Butterfield Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2006
    Consegnato il 03 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a burford laudry witney street burford oxfordshire part of t/no ON200100 chapmans piece witney street burford oxfordshire part of t/no ON240859 tannery cottage witney street burford oxfordshire 53 and 61 castle street cirencester gloucestershire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Butterfield Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 25 lug 2006
    Consegnato il 03 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a burford laundry witney street burford oxfordshire part of t/no ON200100 chapmans piece witney street burford oxfordshire part of t/no ON240859 tannery cottage witney street burford oxfordshire 53 and 61 castle street cirencester gloucestershire and all buildings and erections thereon fixed charge all rents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Butterfield Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 03 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 2003
    Consegnato il 02 giu 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All that f/h property known as the burford laundry, burford, oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 2003
    Consegnato il 19 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chapmans piece cottage formerly tannery cottage tannery close burford oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 lug 1986
    Consegnato il 30 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fulbrook cottages. Fulbrook oxon. Premises at chapmans piece cottage field the orchard formerly buildings cottages and land at witney street burford in the county of oxford and premises south side of castle street cirencester in the county of gloucester, with all buildings and fixtures (inc. Trade fixtures) and fixed plant and machinery. All goodwill, uncalled capital, book debts and other debts. Floating charge all assets of the company whatsoever and wheresoever.
    Persone aventi diritto
    • John Patrick Melvyn Cook.
    Transazioni
    • 30 lug 1986Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 lug 1983
    Consegnato il 07 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    15/17 west street marlow buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1982
    Consegnato il 22 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as or being chapman's piece cottage, witney street, burford, oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 feb 1982
    Consegnato il 22 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as or being situated southside crossroads carterton oxon.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 15 mar 1977
    Consegnato il 23 mar 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situated at the cross roads, carterton oxford.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second mortgage
    Creato il 08 gen 1976
    Consegnato il 15 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    53,55,57,59,& 61 castle street, cirencester, gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second mortgage
    Creato il 08 gen 1976
    Consegnato il 15 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Racket court off witney street, burford,oxford.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second mortgage
    Creato il 08 gen 1976
    Consegnato il 15 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Five cottages in meadow lane, fulbrook, oxford known as fulbrook cottages.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second mortgage
    Creato il 08 gen 1976
    Consegnato il 15 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The tannery, witney str, burford, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second mortgage
    Creato il 08 gen 1976
    Consegnato il 15 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    50, high street, witney, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second mortgage
    Creato il 08 gen 1976
    Consegnato il 15 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Burford mill off witney street, burford,oxford.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1974
    Consegnato il 24 dic 1974
    Soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 7 deb 1974
    Brevi particolari
    1) laundry buildings cottages and lands at witney, st burford, oxfordshire 2) five cottages meadow lane, fulbrook, burford, oxford 3) 53,55,57,59 & 61 castle street, cirencester, glos 4) shop garden and premises 50 high street, witney, oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • K.L.Cook.
    • F.M.Cooke
    Transazioni
    • 24 dic 1974Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0