SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED

SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00294232
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mar 2015

    14 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 06 mar 2015

    14 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 set 2014

    43 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    2 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    130 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Hanbury Court Harris Business Park, Hanbury Road Stoke Prior Bromsgrove Worcestershire B60 4DJ* in data 13 mar 2014

    2 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Nicholas Crawley come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2014

    Stato del capitale al 10 gen 2014

    • Capitale: GBP 151,566.7
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Hanbury Court Harris Business Park, Hanbury Road Stoke Prior Bromsgrove Worcestershire B60 4JJ United Kingdom* in data 10 gen 2014

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Glen Donald Hanbury Court Hariss Business Park Stoke Prior Bromsgrove B60 4JJ United Kingdom

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Alan Murray come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Glen Donald Room 114-115 Cornwall Buildings 45-51 Newhall Street Birmingham B3 3QR United Kingdom

    1 pagineAD02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 02 ott 2012 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Richmond Gate Hotel Richmond Hill Richmond upon Thames Surrey TW10 6RP* in data 27 ago 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2011

    11 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 28 feb 2012 al 02 ott 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 29 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 27 feb 2011

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRENT, James Stephen
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Amministratore
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    EnglandBritish146907760002
    WELBOURN, Philip Matthew
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Amministratore
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United KingdomBritish135168350001
    BOOTE, Robert Edward
    61 Efford Way
    Pennington
    SO41 8DA Lymington
    Hampshire
    Segretario
    61 Efford Way
    Pennington
    SO41 8DA Lymington
    Hampshire
    British5533200001
    LEWIS, David Richard
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Segretario
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British5754090003
    COLLINS, Robin Evan
    Old House
    Lyndhurst Road
    BH24 4HU Burley
    Hampshire
    Amministratore
    Old House
    Lyndhurst Road
    BH24 4HU Burley
    Hampshire
    EnglandBritish5533210001
    CRAWLEY, Nicholas Davd Townsend
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Amministratore
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United KingdomBritish146568590001
    CRAWLEY, Nicholas David Townsend
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    England
    EnglandEnglish96980780001
    LEWIS, David Richard
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritish5754090003
    MURRAY, Alan John
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Amministratore
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    EnglandBritish104826920002

    SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 15 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 lug 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2010
    Consegnato il 06 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the properties,second fixed charge all present and future interest of the company in or over f/h and l/h property,all present and future rights licences guarantees rents deposits contracts covenants and warranties see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robin Evan Collins
    Transazioni
    • 06 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 lug 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 22 dic 2010
    Consegnato il 29 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Creato il 22 dic 2010
    Consegnato il 29 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H moorland links hotel yelverton t/no:DN466858 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Creato il 22 dic 2010
    Consegnato il 29 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H southampton park hotel 13 and 13 cumberland place southampton hampshire t/no:HP618323 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of guarantee and legal mortgage
    Creato il 10 gen 2008
    Consegnato il 24 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from forestdale hotels limited and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land being moorland links hotel yelverton t/no DN466858. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Flodrive UK V Property 1 Sarl
    Transazioni
    • 24 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as southampton park hotel,12 and 13 cumberland place southampton hants. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as moorland links hotel,yelverton devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19,838 ordinary shares in the share capital of parade hotels (bath) limited and all stocks,shares and other securities thereon and all certificates and other documents of title deposited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ott 1982
    Consegnato il 03 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts legal mortgage over:- southampton park hotel cumberland place southampton and moorland links hotel yelverton devonshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 gen 1938
    Consegnato il 20 gen 1938
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £43000
    Brevi particolari
    Undertaking and all property including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Branch Nominees LTD
    Transazioni
    • 20 gen 1938Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 ott 1937
    Consegnato il 29 ott 1937
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys etc
    Brevi particolari
    Freehold court royal 10 northland rd southampton title P164346. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • National Provincial Bank
    Transazioni
    • 29 ott 1937Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 mar 2015Fine dell'amministrazione
    07 mar 2014Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    James Joseph Bannon
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham
    Praticante
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0