BENNET PROPERTY LIMITED

BENNET PROPERTY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBENNET PROPERTY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00294916
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BENNET PROPERTY LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova BENNET PROPERTY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Greens Court Lansdown Road
    Holland Park
    W11 3AP London
    Uk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BENNET PROPERTY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BENNET PROPERTY PLC26 giu 199726 giu 1997
    BENNET PROPERTY COMPANY LIMITED(THE)11 dic 193411 dic 1934

    Quali sono gli ultimi bilanci di BENNET PROPERTY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BENNET PROPERTY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2009

    21 pagineAA

    legacy

    36 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    8 pagine395

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    12 pagineMAR

    legacy

    1 pagine53

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di BENNET PROPERTY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TETT, Victoria Roselle
    Wormstall
    Wickham
    RG20 8HB Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Wormstall
    Wickham
    RG20 8HB Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director64813080001
    TETT, Colin Christopher
    Wormstall
    Wickham
    RG20 8HB Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Wormstall
    Wickham
    RG20 8HB Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director82534140001
    TETT, Victoria Roselle
    Wormstall
    Wickham
    RG20 8HB Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Wormstall
    Wickham
    RG20 8HB Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director64813080001
    AYLIFFE, Nigel John Bonnett
    3 The Old Rectory
    Ayot Lawrence
    AL6 Welwyn
    Herts
    Segretario
    3 The Old Rectory
    Ayot Lawrence
    AL6 Welwyn
    Herts
    British10389120001
    COWLEY, Julia
    Millfield House 4 Millfield
    Marton Cum Grafton
    YO51 9PT York
    North Yorkshire
    Segretario
    Millfield House 4 Millfield
    Marton Cum Grafton
    YO51 9PT York
    North Yorkshire
    British34431310006
    HLF NOMINEES LIMITED
    20 West Mills
    RG14 5HG Newbury
    Berkshire
    Segretario
    20 West Mills
    RG14 5HG Newbury
    Berkshire
    83449150001
    SEYMOUR MACINTYRE LIMITED
    Millfield House 4 Millfield
    Marton Cum Grafton
    YO51 9PT York
    North Yorkshire
    Segretario
    Millfield House 4 Millfield
    Marton Cum Grafton
    YO51 9PT York
    North Yorkshire
    100081770002
    CHARLES, David Michael
    Normandy Hill Cottage
    Normandy Common Normandy
    GU3 2AP Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Normandy Hill Cottage
    Normandy Common Normandy
    GU3 2AP Guildford
    Surrey
    BritishChartered Surveyor9538070001
    DOWSON, Ian Gerald
    One Shepperds Close
    North Marston
    MK18 3PB Buckingham
    Amministratore
    One Shepperds Close
    North Marston
    MK18 3PB Buckingham
    UkBritishChartered Accountant51391240001
    HAWKES, Michael John Cameron
    Park Farm Drive
    Punchbowl Lane
    RH5 4EB Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Park Farm Drive
    Punchbowl Lane
    RH5 4EB Dorking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor33284180001
    ORAM, Brian Denis
    11 Elm Close
    Rowde
    SN10 2QP Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    11 Elm Close
    Rowde
    SN10 2QP Devizes
    Wiltshire
    BritishRetired Manager3965750002
    TILLEY, Keith John
    Ayot Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BT Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Ayot Cottage
    Ayot St Lawrence
    AL6 9BT Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor2411700001

    BENNET PROPERTY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 nov 2008
    Consegnato il 12 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking, property and assets of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company assigns to the society the exclusive rights to receive all rents in respect of the property subject to reimbursement of any insurance premium or service charge paid or incurred by the company as contemplated in the deed of assignment and subject to the rights of redemption on repayment of the indebtedness as defined in the commercial mortgage.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Commercial mortgage
    Creato il 19 ott 2001
    Consegnato il 26 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that freehold property known as heathervale house 2-4 vale avenue tunbridge wells kent TN1 1DJ title number K343544. By way of first fixed charge all the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 26 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 mar 2000
    Consegnato il 28 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 mar 2000
    Consegnato il 24 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as hambledon house flambard way godalming surrey title number SY417669. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 27 mag 1999
    Consegnato il 02 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 8 and 10 crown hill church street croydon and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time thereonthe goodwill of any trade or business all book and other monetary debts .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 02 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 apr 1999
    Consegnato il 30 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 182-186 high street guildford surrey t/n ST670184 and all rental income all fixtures and fittings the goodwill of the business the benefit of all guarantees and warranties and a floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Britannia Building Society
    Transazioni
    • 30 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 14 ott 1997
    Consegnato il 24 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee including without limitation the principal sum of money lent by the lender to the company and which is outstanding from time to time pursuant to a loan agreement dated 7TH october 1997 and under or in connection with any security document (as defined in the said loan agreement) and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 35 fore street tiverton devon and 73-77 high street cheltenham including all fixtures fixed plant and machinery and a floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • The Canada Life Assurance Company
    Transazioni
    • 24 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 14 ott 1997
    Consegnato il 17 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 252 high street guildford surrey and all buildings fixtures plant & machinery the goodwill of the business the benefit of all licences all book and other debts and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 17 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 16 lug 1997
    Consegnato il 18 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Woodlands, bartholomew street, newbury, 134 & 135 london road, brighton, guildgate house, pelican lane, newbury, 154 putney high street, putney and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery, goodwill of the business, benefit of licences, all book debts, by way of floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 18 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 30 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Northampton house, 1 high street and 53/59 poplar road, solihull t/no. WM592191.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 30 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 dic 1993
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a bennet court 1 bellevue road wandsworth common t/no SGL399819. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 01 lug 1992
    Consegnato il 08 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge and legal mortgage f/h land k/a shops,flats and garages on land at martin hardie way title no: k 157510 and various other properties as described on form 395 the goodwill of the business benefit of all licences all book and other debts all stocks and shares. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transazioni
    • 08 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 giu 1992
    Consegnato il 26 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 bellevue road london SW17 t/no.SGL399819 & the proceeds of sale thereof floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 giu 1991
    Consegnato il 28 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1-13 (odd) queen victoria house albert street swindon wiltshire and the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 gen 1991
    Consegnato il 18 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dovemill properties (newbury) limited on any account whatsoever not exceeding £2,000,000.
    Brevi particolari
    22-26, high street tunbridg wells, kent title numbers K207644 and K468022 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 gen 1991
    Consegnato il 18 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dovemill properties (newbury) limited on any account whatsoever not exceeding £2,000,000.
    Brevi particolari
    Bennett court 1. belleuve road london SW17. Title no: sel 399819. and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1990
    Consegnato il 16 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any associated company or any guarantee (as defined in the charge) on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H land k/a 97 and 99 victoria road (incl land 3 massetts road) horley reigate and bunstead surrey title no sy 73409 fixed charge any proceeds of sale and the benefit of covenants & licenses agreements copyrights guarantees warranties insurance policies. Please see doc M99 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 16 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 feb 1989
    Consegnato il 03 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a queen victoria house albert street victoria road. Swindon wiltshire goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 18 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1987
    Consegnato il 02 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 124,126 & 128 draycott avenue and 311 and 315 brompton road. Title no ln 214440 f/h property k/a 313/313A brompton road. Title no ngl 236321. fixed equitable charge over the benefit of each & all of the personal covenants all rights of enforcement.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release & substitution
    Creato il 01 set 1986
    Consegnato il 03 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £760,000 & all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage dated 7/9/84.
    Brevi particolari
    1, union st, luton (title no bd 27181).
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 03 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release & substitution
    Creato il 30 ott 1985
    Consegnato il 31 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a trust deed dated 17/2/64, various deeds supplemental there to and the mortgage dated 7/9/84
    Brevi particolari
    31 and 32 errismore gardens, london SW7 title no. Ln 56149.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 31 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 set 1984
    Consegnato il 11 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and £500,000 & all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Properties as listed (see doc M329).
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Public Lmited Company
    Transazioni
    • 11 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Deed of release and substituion
    Creato il 20 apr 1979
    Consegnato il 23 apr 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £760,000 first mortgage debenture stock 1989/94 supplemental to a trust deed dated 17 eb 1964 annd deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Land and buildings at chaul end lane, luton, beds title no bd 56848.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 23 apr 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0