SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED

SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00301946
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?

    • (5242) /

    Dove si trova SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPECIALITY RETAIL GROUP PLC27 nov 199527 nov 1995
    SUITS YOU PLC20 giu 198820 giu 1988
    BRICKS MANS SHOPS LIMITED19 giu 193519 giu 1935

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 feb 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ott 2012

    14 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mar 2012

    12 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    1 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineF10.2

    Chi sono gli amministratori di SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARPENTER, Scott Keith
    124 High Street
    TW12 1NS Hampton Hill
    Central House
    Middlesex
    Amministratore
    124 High Street
    TW12 1NS Hampton Hill
    Central House
    Middlesex
    United StatesAmerican145987830001
    GEORGE, Gavin Michael
    124 High Street
    TW12 1NS Hampton Hill
    Central House
    Middlesex
    Amministratore
    124 High Street
    TW12 1NS Hampton Hill
    Central House
    Middlesex
    United KingdomBritish148227120001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Segretario
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    British122889900001
    COCKIN, Anna Margaret
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    16 Manor House Estate
    HA7 4BH Stanmore
    Middlesex
    British95030040001
    PAUL, Richard Neil
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    British43099210003
    SPERRY, Ian Nicholas
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    British106924330002
    ARAFA, Alaa, Dr
    Aluaza St Helipolis
    Cairo
    42
    Egypt
    Amministratore
    Aluaza St Helipolis
    Cairo
    42
    Egypt
    EgyptEgyptian131943020001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Amministratore
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritish3007630001
    BERNARD, Henry
    9 North Riding
    Bricket Wood
    AL2 3LH St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 North Riding
    Bricket Wood
    AL2 3LH St Albans
    Hertfordshire
    British45597530001
    BRICK, Alexander Paul
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    Amministratore
    12 The Bishops Avenue
    N2 0AN London
    EnglandBritish122889900001
    BRICK, Anthony Allan
    11 Pangbourne Drive
    HA7 4QS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    11 Pangbourne Drive
    HA7 4QS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish34122180001
    BRICK, Brian Denis
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    28 Aylmer Drive
    HA7 3EG Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish9649690002
    COTTER, Mark Michael Sean
    Little Garth
    Lords Moor Lane Strensall
    YO32 5XF York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Little Garth
    Lords Moor Lane Strensall
    YO32 5XF York
    North Yorkshire
    EnglandBritish73990340003
    EL FAR, Saher
    Abou Dawoud
    Al Zahari St
    50
    Cairo
    Egypt
    Amministratore
    Abou Dawoud
    Al Zahari St
    50
    Cairo
    Egypt
    Egyptian131643360001
    FREEDMAN, Jonathan Sydney
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    9 Eastglade
    HA5 3AN Pinner
    Middlesex
    British5232410001
    GIPSON, Stephen
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Amministratore
    The Engine House
    2 Leigh Court Barns
    WR6 5LB Leigh
    Worcestershire
    Great BritainBritish98785200001
    GUZZETTI, Aristide
    Via Dei Baiardi
    93/2 Trieste
    Italy
    Amministratore
    Via Dei Baiardi
    93/2 Trieste
    Italy
    Italian97837570001
    HALLETT, Peter John
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Goldfields Glenhill Farm
    Glendon Road
    NN14 1QE Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish20621770002
    HARTLEY, Stephen Russell
    51 Greenway Close
    N20 8ES London
    Amministratore
    51 Greenway Close
    N20 8ES London
    British72483640007
    HASHEM, Maha
    Gamel Dowal El Arabaa-Mohandeseen
    Giza
    8
    Egypt
    Amministratore
    Gamel Dowal El Arabaa-Mohandeseen
    Giza
    8
    Egypt
    Egyptian131942790001
    JOHNSON, Steven Leslie
    4 The Knoll
    MK16 9NZ Sherington
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 The Knoll
    MK16 9NZ Sherington
    Buckinghamshire
    EnglandBritish183186080001
    KELLY, Deborah Jane
    146 Gammons Lane
    WD24 5HY Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    146 Gammons Lane
    WD24 5HY Watford
    Hertfordshire
    British88831730003
    KEYTE, Nick
    14 The Mead
    BR3 5PE Beckenham
    Kent
    Amministratore
    14 The Mead
    BR3 5PE Beckenham
    Kent
    British115552050001
    LUCAS, Peter
    The Old Rectory
    Oswaldkirk
    YO62 5XT York
    Amministratore
    The Old Rectory
    Oswaldkirk
    YO62 5XT York
    EnglandBritish5858840002
    MARSHALL, Robert Gavin
    1 Canal Wharf
    Holbeck
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Canal Wharf
    Holbeck
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    United KingdomBritish139110060001
    MIDDLETON, Alison
    36 Drifters Drive
    Deepcut Camberley
    GU16 6GT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    36 Drifters Drive
    Deepcut Camberley
    GU16 6GT Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish116051660001
    NORCLIFFE, John Martyn
    1 Canal Wharf
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    1 Canal Wharf
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish155008850001
    PAUL, Richard Neil
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    21 Almsford Avenue
    HG2 8HD Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish43099210003
    RICH, Michael John
    St Bees School Lane
    Bricket Wood
    AL2 3XS St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    St Bees School Lane
    Bricket Wood
    AL2 3XS St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish189317060001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    SCOTT, Charles Thomas
    Chase Manor Farm
    Lickfold Road, Fernhurst
    GU27 3JA Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Chase Manor Farm
    Lickfold Road, Fernhurst
    GU27 3JA Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish57006540003
    SPERRY, Ian Nicholas
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 St. Thomas Place
    Wheathampstead
    AL4 8BG St. Albans
    Hertfordshire
    British106924330002
    THOMSON, Andrew David
    1 Canal Wharf
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    1 Canal Wharf
    LS11 5BB Leeds
    Granary Building
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish155008430001
    WOODHOUSE, Anthony John
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    Amministratore
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    United KingdomBritish131678400001
    WRIGHT, Adrian James
    The Copse
    10a Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Surrey
    Amministratore
    The Copse
    10a Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish89162730002

    SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 15 giu 2010
    Consegnato il 30 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited (Security Holder)
    Transazioni
    • 30 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2008
    Consegnato il 20 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gresham LLP (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over accounts
    Creato il 06 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account named bbre speciality retail group numbered 60853216 sort code 20-80-57. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplement deed
    Creato il 25 mag 2006
    Consegnato il 09 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 nov 2005
    Consegnato il 13 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 15 mag 2000
    Consegnato il 24 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    69 kesington way borehamwood hertfordshire t/n HD379236.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 gen 1998
    Consegnato il 23 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    175 high street hounslow l/b of hounslow t/n NGL562548.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 04 ago 1993
    Consegnato il 14 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £61039.90
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 14 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1992
    Consegnato il 03 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 234 (formerly unit 119) lakeside shopping centre thurrock essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 feb 1992
    Consegnato il 24 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor and basement shop 55,57, and 59 oxford street & 2 soho street l/b of city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 mag 1991
    Consegnato il 10 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    175, high street, hounslow, london borough of hounslow.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1991
    Consegnato il 26 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 031, whiteleys queensway, bayswater london borough of city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1990
    Consegnato il 14 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Basement and ground floors of 372 oxford street, being part of the building and all and any part of such property and any additions thereto.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 lug 1990
    Consegnato il 24 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit no: su 119 thurrock lakeside shopping centre west thurrock essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mag 1990
    Consegnato il 21 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2 (infill site) wood green shopping city high road, wood green l/b of haringey. Title no:- ngl 355496.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1990
    Consegnato il 02 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    49 the parade high street watford hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1990
    Consegnato il 02 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of basement and ground floor of 55/59 (odd nos only) oxford street l/b of the city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1990
    Consegnato il 02 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The ground floor and basement 77 high street and 1 mackenzie street slough buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 set 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 67, the friary, north street, guildford, surrey. Title no. Sy 594596.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 giu 1988
    Consegnato il 15 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of ground floor at 129/133 high street slough buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 giu 1988
    Consegnato il 06 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    175 high street hounslow l/b of hounslow.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 giu 1988
    Consegnato il 06 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground floor and basement of 55, 57 and 59 oxford street and 2 solo street l/b of city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1988
    Consegnato il 08 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 5 park industrial estate frogmore st. Albans title no hd 213420.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 06 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 feb 1988
    Consegnato il 15 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 5 park industrial estate, frogmore, 56 albans, hertfordshire. Title no. Hd 213240.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2010Data della riunione per approvare il CVA
    05 nov 2010Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    3
    DataTipo
    28 ott 2010Inizio dell'amministrazione
    09 mar 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Fraser James Gray
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    Praticante
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    4
    DataTipo
    09 mar 2011Inizio della liquidazione
    17 gen 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Fraser James Gray
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    Praticante
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    Charles Peter Holder
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praticante
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0