CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED

CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00307115
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hawkslease
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COVO REFINING COMPANY LIMITED16 nov 193516 nov 1935

    Quali sono gli ultimi bilanci di CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Stato del capitale al 27 apr 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 apr 2010

    • Capitale: GBP 101
    4 pagineSH01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 apr 2010

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Reece come amministratore

    1 pagineTM01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Cessazione della carica di Leonardus Heemskerk come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Jonathan Frank Ginns come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    35 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Apt of auditor 16/02/2010
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dettagli del direttore cambiati per Leonardus Hendrik Heemskerk il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Martin Howard Stokes il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Reece il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graeme Leask il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STOKES, Martin Howard
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    British7345750001
    GINNS, Jonathan Frank, Mr.
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137152420001
    LEASK, Graeme
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish82427110002
    BELL, Roger
    Greenacre
    Cockpit Lane Sandiway
    CW8 2DT Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Greenacre
    Cockpit Lane Sandiway
    CW8 2DT Northwich
    Cheshire
    British74504200001
    GROSSET, Margaret Wilhelmina
    7 Arnprior Place
    KA7 4PT Alloway
    Ayrshire
    Segretario
    7 Arnprior Place
    KA7 4PT Alloway
    Ayrshire
    British54009620001
    HUGHES, Loraine
    4 Brackenwood
    West Derby
    L12 0NG Liverpool
    Segretario
    4 Brackenwood
    West Derby
    L12 0NG Liverpool
    British88641690001
    MAHER, Michael John
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    Segretario
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    British110531730001
    OLIPHANT, William John
    1 Bromley Close
    Lower Heswall
    L60 9LG Wirral
    Merseyside
    Segretario
    1 Bromley Close
    Lower Heswall
    L60 9LG Wirral
    Merseyside
    British55939940001
    REECE, John
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    Segretario
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    British68799970001
    TRIMBLE, Julie Ann
    Sycamore Barn
    Yew Tree Farm Broad Lane, Grappenhall
    WA4 3HT Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Sycamore Barn
    Yew Tree Farm Broad Lane, Grappenhall
    WA4 3HT Warrington
    Cheshire
    British110747130002
    WAKEFIELD, Barry John
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    Segretario
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    British27554930001
    THE NEW HOVEMA LIMITED
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    Segretario
    Unilever House
    Blackfriars
    EC4P 4BQ London
    602120001
    CURRIE, Andrew Christopher
    South Marden
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    South Marden
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British38220340001
    DEE, Peter Francis
    7 Leighton Court
    CH64 6UW Neston
    Cheshire
    Amministratore
    7 Leighton Court
    CH64 6UW Neston
    Cheshire
    United KingdomBritish76889150002
    FOSTER, Brian Robert
    19 Belvedere Gardens
    Chineham
    RG24 8GB Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    19 Belvedere Gardens
    Chineham
    RG24 8GB Basingstoke
    Hampshire
    British55652430001
    GRIFFITHS, William Reginald
    Highfield
    51 Trafford Road
    SK9 7DN Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Highfield
    51 Trafford Road
    SK9 7DN Alderley Edge
    Cheshire
    British36877220003
    HALLAM, Martin John Barrat
    4 Clarence Park
    BB2 7FA Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    4 Clarence Park
    BB2 7FA Blackburn
    Lancashire
    British110783420001
    HAMPTON-COUTTS, Cheryl Jane
    17 Grosvenor Gardens
    East Sheen
    SW14 8BY London
    Amministratore
    17 Grosvenor Gardens
    East Sheen
    SW14 8BY London
    British12016130001
    HEEMSKERK, Leonardus Hendrik
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomDutch115611110002
    HINNIGAN, John
    The Grange
    CW8 2RQ Acton Bridge
    Cheshire
    Amministratore
    The Grange
    CW8 2RQ Acton Bridge
    Cheshire
    British86193040001
    HOGAN, Iain Timothy, Dr
    10 Highlands Road
    Barton On Sea
    BH25 7BN New Milton
    Hampshire
    Amministratore
    10 Highlands Road
    Barton On Sea
    BH25 7BN New Milton
    Hampshire
    United KingdomBritish65774850002
    JOSLIN, Christopher Peter
    Mayfield Welsh Road
    Childer Thornton
    L66 5PN South Wirral
    Amministratore
    Mayfield Welsh Road
    Childer Thornton
    L66 5PN South Wirral
    British41642710001
    LEEK, Robert David
    40 Loveridge Road
    NW6 2DT London
    Amministratore
    40 Loveridge Road
    NW6 2DT London
    United KingdomBritish53569940002
    LOVELL, Anthony Leonard, Dr
    Cefyn Bychan Farm
    Pantymwyn
    Clwyd
    Amministratore
    Cefyn Bychan Farm
    Pantymwyn
    Clwyd
    British41976390001
    MAHER, Michael John
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    Amministratore
    7 Cae Eithin
    Lixwm
    CH8 8NB Holywell
    Clwyd
    British110531730001
    MULHOLLAND, Gerard
    Rosehill 2 Congleton Close
    SK9 7AJ Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Rosehill 2 Congleton Close
    SK9 7AJ Alderley Edge
    Cheshire
    British14868310002
    NEELY, Paul
    54 Mountfield Road
    Finchley
    N3 3NP London
    Amministratore
    54 Mountfield Road
    Finchley
    N3 3NP London
    United KingdomBritish36575750002
    QUARMBY, Simon Charles
    26 Skipton Close
    Great Sankey
    WA5 8XS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    26 Skipton Close
    Great Sankey
    WA5 8XS Warrington
    Cheshire
    British110748930002
    REECE, John
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hawkslease
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142028710001
    REECE, John
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    British68799970001
    RIVETT, Michael John Edward
    61 Park End
    BR1 4AW Bromley
    Kent
    Amministratore
    61 Park End
    BR1 4AW Bromley
    Kent
    United KingdomBritish813120001
    SAMUEL, Michael John, Mr.
    38 St Botolphs Road
    TN13 3AG Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    38 St Botolphs Road
    TN13 3AG Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish13896090003
    TOMLINSON, Robert Michael
    89 Cambridge Road
    SW20 0PU London
    Amministratore
    89 Cambridge Road
    SW20 0PU London
    British8692180001
    TRIMBLE, Julie Ann
    Sycamore Barn
    Yew Tree Farm Broad Lane, Grappenhall
    WA4 3HT Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Sycamore Barn
    Yew Tree Farm Broad Lane, Grappenhall
    WA4 3HT Warrington
    Cheshire
    British110747130002
    WHELAN, Russell, Dr
    Richmond House
    136 Boughton
    CH3 5BP Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Richmond House
    136 Boughton
    CH3 5BP Chester
    Cheshire
    British74708700002

    CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 gen 2001
    Consegnato il 19 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each of the finance documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all rights title and interest in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the chargor, the investments, the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights and all monetery claims and assigns the proceeds of any insurance policy and all related rights, each of the specific contracts and all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings, guarantees, covenants, warranties, representations and other documents, by way of first floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CROSFIELD INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 ago 2011Data di scioglimento
    16 apr 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0